STENTION LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSTENTION LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01865604
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di STENTION LIMITED?

    • Altro commercio al dettaglio in negozi non specializzati (47190) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

    Dove si trova STENTION LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Nursery
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    Suffolk
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di STENTION LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al28 feb 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per STENTION LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    1 pagineMR04

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 25 feb 2016

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Cessazione della carica di Ian William Furniss come amministratore in data 17 feb 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Ian William Furniss come segretario in data 17 feb 2016

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Mark Haddock come amministratore in data 17 feb 2016

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2015

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 09 nov 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 nov 2015

    Stato del capitale al 09 nov 2015

    • Capitale: GBP 50,000
    SH01

    Cessazione della carica di Andrew Michael Lawrence Staff come amministratore in data 31 mar 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 09 nov 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 dic 2014

    Stato del capitale al 04 dic 2014

    • Capitale: GBP 50,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2014

    7 pagineAA

    Nomina di Mr Ian William Furniss come segretario

    2 pagineAP03

    Nomina di Mr Ian William Furniss come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Andrew Staff come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 09 nov 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 dic 2013

    Stato del capitale al 05 dic 2013

    • Capitale: GBP 50,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2013

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 09 nov 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 29 feb 2012

    7 pagineAA

    Cessazione della carica di Andrew King come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Roger Notcutt come amministratore

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di STENTION LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HADDOCK, Mark
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    The Nursery
    Suffolk
    Amministratore
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    The Nursery
    Suffolk
    EnglandBritish205244020001
    ANDREW, Stephen Robert
    Chapel Farmhouse Chapel Lane
    Mouldsworth
    CH3 8BF Chester
    Cheshire
    Segretario
    Chapel Farmhouse Chapel Lane
    Mouldsworth
    CH3 8BF Chester
    Cheshire
    British49087860002
    FRASER, Ian Ford
    The Bothy
    Welbeck
    S80 3LW Worksop
    Nottinghamshire
    Segretario
    The Bothy
    Welbeck
    S80 3LW Worksop
    Nottinghamshire
    British17335680002
    FURNISS, Ian William
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    The Nursery
    Suffolk
    Segretario
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    The Nursery
    Suffolk
    188358510001
    STAFF, Andrew Michael Lawrence
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    The Nursery
    Suffolk
    Segretario
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    The Nursery
    Suffolk
    British134035650001
    WALKER, Linda Margaret
    21 Cornelia Crescent
    Belvidere
    SY2 5NA Shrewsbury
    Shropshire
    Segretario
    21 Cornelia Crescent
    Belvidere
    SY2 5NA Shrewsbury
    Shropshire
    British48968430002
    ANDREW, Stephen Robert
    Chapel Farmhouse Chapel Lane
    Mouldsworth
    CH3 8BF Chester
    Cheshire
    Amministratore
    Chapel Farmhouse Chapel Lane
    Mouldsworth
    CH3 8BF Chester
    Cheshire
    EnglandBritish49087860002
    BARNES, Ian Malcolm
    Holly House The Fold
    Dorrington
    SY5 7JD Shrewsbury
    Shropshire
    Amministratore
    Holly House The Fold
    Dorrington
    SY5 7JD Shrewsbury
    Shropshire
    United KingdomBritish37745750001
    COLE, Michael David
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    The Nursery
    Suffolk
    Amministratore
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    The Nursery
    Suffolk
    United KingdomBritish146969370001
    DRAPER, David
    The Barn
    High Hatfield
    NG9 7ST Cuckney Mansfield
    Nottinghamshire
    Amministratore
    The Barn
    High Hatfield
    NG9 7ST Cuckney Mansfield
    Nottinghamshire
    British22730200002
    FAUN, Stephen
    2 Worleston Close
    CW10 0RG Middlewich
    Cheshire
    Amministratore
    2 Worleston Close
    CW10 0RG Middlewich
    Cheshire
    British81650270001
    FRASER, Ian Ford
    The Bothy
    Welbeck
    S80 3LW Worksop
    Nottinghamshire
    Amministratore
    The Bothy
    Welbeck
    S80 3LW Worksop
    Nottinghamshire
    British17335680002
    FURNISS, Ian William
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    The Nursery
    Suffolk
    Amministratore
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    The Nursery
    Suffolk
    EnglandBritish117943650001
    GRUNDY, Paul
    74 Broadwalk
    SK9 5PN Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    74 Broadwalk
    SK9 5PN Wilmslow
    Cheshire
    EnglandBritish17333220001
    KING, Andrew James
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    The Nursery
    Suffolk
    Amministratore
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    The Nursery
    Suffolk
    EnglandBritish217979240001
    NOTCUTT, Roger William
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    The Nursery
    Suffolk
    Amministratore
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    The Nursery
    Suffolk
    EnglandBritish134038090001
    REEVES, James Alan
    9 Kingscroft Close
    Dore
    S17 3RE Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    9 Kingscroft Close
    Dore
    S17 3RE Sheffield
    South Yorkshire
    British22730190001
    SCOTT, Graham Robert
    216 Main Road
    Goostrey
    CW4 8PE Crewe
    Cheshire
    Amministratore
    216 Main Road
    Goostrey
    CW4 8PE Crewe
    Cheshire
    British44672550004
    SPURLING, Anthony Christopher
    36 Mossgrove Road
    Timperley
    WA15 6LF Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    36 Mossgrove Road
    Timperley
    WA15 6LF Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritish106994510001
    STAFF, Andrew Michael Lawrence
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    The Nursery
    Suffolk
    Amministratore
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    The Nursery
    Suffolk
    EnglandBritish134035650001
    WHITING, Richard Antony
    Chestnut Farm
    Cross Lane, Kermincham
    CW12 2LJ Congleton
    Cheshire
    Amministratore
    Chestnut Farm
    Cross Lane, Kermincham
    CW12 2LJ Congleton
    Cheshire
    EnglandBritish327792630001
    WHITING, Richard Antony
    Chestnut Farm
    Cross Lane, Kermincham
    CW12 2LJ Congleton
    Cheshire
    Amministratore
    Chestnut Farm
    Cross Lane, Kermincham
    CW12 2LJ Congleton
    Cheshire
    EnglandBritish327792630001

    STENTION LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee & debenture
    Creato il 02 ott 2008
    Consegnato il 09 ott 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 ott 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 01 ott 2008
    Consegnato il 04 ott 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property k/a victoria garden centre wakefield road streethouse PO9NTEFACT west yorkshire t/no WYK445421, WYK72899, WYK781899 and WYK781290.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 04 ott 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 mar 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 02 nov 2004
    Consegnato il 05 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £3,085,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    F/H land on the south side of wakefield road, snydale, pontefract k/a victoria garden centre t/no WYK445421 and f/h land on the south side of wakefield road, snydale, pontefract t/no WYK72899.
    Persone aventi diritto
    • Niel Graham Hirst and Lillian Hirst
    Transazioni
    • 05 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 02 nov 2004
    Consegnato il 03 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    T/Nos WYK72899 & WYK445421. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 01 mag 2008
    • 01 nov 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 24 set 2002
    Consegnato il 26 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 26 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 nov 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 26 giu 1997
    Consegnato il 02 lug 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 02 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 mar 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 05 giu 1990
    Consegnato il 11 giu 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge over the book debts & other debts owing to the company floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts (excluding those mentioned above) uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 11 giu 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 21 mar 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0