ISUZU SOUTH AND WEST YORKSHIRE LIMITED

ISUZU SOUTH AND WEST YORKSHIRE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàISUZU SOUTH AND WEST YORKSHIRE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01865963
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ISUZU SOUTH AND WEST YORKSHIRE LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova ISUZU SOUTH AND WEST YORKSHIRE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    14 Park Row
    NG1 6GR Nottingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ISUZU SOUTH AND WEST YORKSHIRE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SHERWOOD LEYLAND DAF (SHEFFIELD) LIMITED18 apr 198918 apr 1989
    WATERFALL & HOLMES LIMITED11 mag 198811 mag 1988
    EAST MIDLANDS EXPORT PACKERS LIMITED01 feb 198501 feb 1985
    AIMHIGH LIMITED23 nov 198423 nov 1984

    Quali sono gli ultimi bilanci di ISUZU SOUTH AND WEST YORKSHIRE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 apr 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per ISUZU SOUTH AND WEST YORKSHIRE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    3 pagine4.71

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 08 mag 2012

    20 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da Sherwood House Berristow Lane Blackwell Derby DE55 5HP in data 18 mag 2011

    2 pagineAD01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 09 mag 2011

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Risoluzione di insolvenza

    Resolution insolvency:special resolution ;- "creditors payments"
    1 pagineLIQ MISC RES

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2010

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 09 ott 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 ott 2010

    Stato del capitale al 26 ott 2010

    • Capitale: GBP 10,000
    SH01

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 30 set 2010

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2009

    1 pagineAA

    Cessazione della carica di David Smith come segretario

    2 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 09 ott 2009 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 30 apr 2008

    1 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 30 apr 2007

    1 pagineAA

    legacy

    7 pagine363s

    Bilancio redatto al 30 apr 2006

    1 pagineAA

    legacy

    7 pagine363s

    Bilancio redatto al 30 apr 2005

    1 pagineAA

    legacy

    7 pagine363s

    Bilancio redatto al 30 apr 2004

    1 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di ISUZU SOUTH AND WEST YORKSHIRE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HEMP, Paul Richard
    89 Main Road
    Underwood
    NG16 5GP Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    89 Main Road
    Underwood
    NG16 5GP Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish18753330002
    WATERFALL, Terrance Anthony
    Willowcroft
    Hallfield Gardens
    Shirland
    Derbyshire
    Amministratore
    Willowcroft
    Hallfield Gardens
    Shirland
    Derbyshire
    EnglandBritish20704620003
    HASLOP, Stephen Robert
    1 Copse Close
    Ravenshead
    NG15 9HU Nottingham
    Segretario
    1 Copse Close
    Ravenshead
    NG15 9HU Nottingham
    British30719780002
    SMITH, David Anthony
    18 Farmlands Lane
    Littleover
    DE23 7UR Derby
    Derbyshire
    Segretario
    18 Farmlands Lane
    Littleover
    DE23 7UR Derby
    Derbyshire
    British52247650002
    SMITH, David Anthony
    6 Templar Close
    Stenson Fields
    DE24 3EL Derby
    Derbyshire
    Segretario
    6 Templar Close
    Stenson Fields
    DE24 3EL Derby
    Derbyshire
    British52247650001
    HASLOP, Stephen Robert
    1 Copse Close
    Ravenshead
    NG15 9HU Nottingham
    Amministratore
    1 Copse Close
    Ravenshead
    NG15 9HU Nottingham
    EnglandBritish30719780002
    HOLMES, Laurence Francis
    6 Willow Holt
    Lowdham
    NG14 7EJ Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    6 Willow Holt
    Lowdham
    NG14 7EJ Nottingham
    Nottinghamshire
    British18753340001
    HOLMES, Laurence Francis
    6 Willow Holt
    Lowdham
    NG14 7EJ Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    6 Willow Holt
    Lowdham
    NG14 7EJ Nottingham
    Nottinghamshire
    British18753340001
    RENSHAW, Neil Eric
    Brookside Farm
    Lower Bagthorpe, Bagthorpe
    NG16 5HF Nottingham
    Amministratore
    Brookside Farm
    Lower Bagthorpe, Bagthorpe
    NG16 5HF Nottingham
    British18753350003

    ISUZU SOUTH AND WEST YORKSHIRE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 19 mag 1999
    Consegnato il 21 mag 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 21 mag 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 apr 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 03 mag 1989
    Consegnato il 16 mag 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a highfield garage highfield lane sheffield.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 16 mag 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 12 lug 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge over agreement
    Creato il 01 set 1986
    Consegnato il 05 set 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the principal charge dated 3.4.85.
    Brevi particolari
    The benefit of agreements listed in the schedule attached to the document & all monies & rights under the agreements (see doc).
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank Equity Limited.
    Transazioni
    • 05 set 1986Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge over agreements
    Creato il 01 set 1986
    Consegnato il 05 set 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For further securing all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the principal charge dated 12.12.85
    Brevi particolari
    The benefit of agreements listed in the schedule attached to the document & all monies & rights under the agreements (see doc).
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank Equity Limited.
    Transazioni
    • 05 set 1986Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 03 giu 1986
    Consegnato il 10 giu 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings lying to the east of hucknall lane bulwell nottingham.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 10 giu 1986Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 03 giu 1986
    Consegnato il 10 giu 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings lying to the east of hucknall lane bulwell nottingham.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank Equity Limited
    Transazioni
    • 10 giu 1986Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 12 dic 1985
    Consegnato il 20 dic 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge over all book & other debts with a floating charge over please see doc M12. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank Equity Limited
    Transazioni
    • 20 dic 1985Registrazione di un'ipoteca
    Fixed and floating charge
    Creato il 03 apr 1985
    Consegnato il 12 apr 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge over all book & other debts with a floating charge over (see doc M11). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 12 apr 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 02 apr 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    ISUZU SOUTH AND WEST YORKSHIRE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    09 mag 2011Inizio della liquidazione
    07 mag 2013Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Nicholas John Edwards
    1 Colton Square
    LE1 1QH Leicester
    Leicestershire
    Praticante
    1 Colton Square
    LE1 1QH Leicester
    Leicestershire
    Tyrone Courtman
    Cooper Parry
    1 Colton Square
    LE1 1QH Leicester
    Praticante
    Cooper Parry
    1 Colton Square
    LE1 1QH Leicester

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0