HIBERNIA FOODS LIMITED

HIBERNIA FOODS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHIBERNIA FOODS LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01866659
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HIBERNIA FOODS LIMITED?

    • (1589) /

    Dove si trova HIBERNIA FOODS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o KPMG LLP
    One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HIBERNIA FOODS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SWEET 'N' SAVOURY FROZEN FOODS LIMITED14 mag 199014 mag 1990
    BETTERBAKE PRODUCTS LIMITED24 lug 198524 lug 1985
    TRESCOMIT LIMITED27 nov 198427 nov 1984

    Quali sono gli ultimi bilanci di HIBERNIA FOODS LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 mar 2003
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 gen 2004
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per HIBERNIA FOODS LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al02 ott 2016
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma16 ott 2016
    Scaduto

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per HIBERNIA FOODS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per HIBERNIA FOODS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Ripristino per ordine del tribunale

    4 pagineAC92

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    L'azione di cancellazione obbligatoria è stata sospesa

    1 pagineDISS16(SOAS)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Ripristino per ordine del tribunale

    4 pagineAC92

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 31 gen 2011

    2 pagine3.6

    legacy

    2 pagineLQ02

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 23 ott 2010

    2 pagine3.6

    Indirizzo della sede legale modificato da , 2 Cornwall Street, Birmingham, West Midlands, B3 2DL a C/O Kpmg Llp One Snowhill Snow Hill Queensway Birmingham B4 6GH in data 22 dic 2009

    1 pagineAD01

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 23 ott 2009

    2 pagine3.6

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 23 ott 2008

    2 pagine3.6

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore

    2 pagine3.6

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore

    2 pagine3.6

    legacy

    287

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore

    2 pagine3.6

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore

    3 pagine3.6

    Varie

    Stat of affairs with f 3.10
    27 pagineMISC

    Relazione del commissario giudiziario amministrativo

    43 pagine3.10

    legacy

    1 pagine288b

    Varie

    Form 3.2 - statement of affairs
    27 pagineMISC

    Relazione del commissario giudiziario amministrativo

    14 pagine3.10

    Certificato di costituzione modificato del comitato dei creditori

    1 pagine3.4

    Chi sono gli amministratori di HIBERNIA FOODS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MURPHY, Oliver
    68 Merrion Square
    Dublin 2
    Ireland
    Amministratore
    68 Merrion Square
    Dublin 2
    Ireland
    Irish54197800002
    CHEUNG, Denis
    Springbank Flatts Lane
    Nunthorpe
    TS7 0PQ Middlesbrough
    Cleveland
    Segretario
    Springbank Flatts Lane
    Nunthorpe
    TS7 0PQ Middlesbrough
    Cleveland
    British22534000003
    DELVES, Colm
    Rose Hall
    Killineer
    IRISH Drogheda
    County Louth
    Ireland
    Segretario
    Rose Hall
    Killineer
    IRISH Drogheda
    County Louth
    Ireland
    Irish54197880005
    CHEUNG, Denis
    Springbank Flatts Lane
    Nunthorpe
    TS7 0PQ Middlesbrough
    Cleveland
    Amministratore
    Springbank Flatts Lane
    Nunthorpe
    TS7 0PQ Middlesbrough
    Cleveland
    British22534000003
    CLOUGH, Jack
    56 Haycock Close
    SK15 2UD Stalybridge
    Cheshire
    Amministratore
    56 Haycock Close
    SK15 2UD Stalybridge
    Cheshire
    British7843080001
    COOPER, Colin
    Burley Hurst Farm Burleyhurst Lane
    SK9 4LX Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    Burley Hurst Farm Burleyhurst Lane
    SK9 4LX Wilmslow
    Cheshire
    United KingdomBritish42373350002
    COOPER, Derek
    Old Dalby Free Green Lane
    Lower Peover
    WA16 9PT Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    Old Dalby Free Green Lane
    Lower Peover
    WA16 9PT Knutsford
    Cheshire
    British35268330003
    DELVES, Colm
    Rose Hall
    Killineer
    IRISH Drogheda
    County Louth
    Ireland
    Amministratore
    Rose Hall
    Killineer
    IRISH Drogheda
    County Louth
    Ireland
    Irish54197880005
    HOLLINS, Derek
    40 Summershades Lane
    Grasscroft
    OL4 4ED Oldham
    Lancashire
    Amministratore
    40 Summershades Lane
    Grasscroft
    OL4 4ED Oldham
    Lancashire
    British22462460001
    NICHOLSON, Edward
    147 Birchineton Avenue
    NE33 4EJ South Shields
    Tyne And Wear
    Amministratore
    147 Birchineton Avenue
    NE33 4EJ South Shields
    Tyne And Wear
    British33284300001
    SKEELS, Norman
    1 The Kilpaw Princess Road
    Lostock
    BL6 4DR Bolton
    Lancashire
    Amministratore
    1 The Kilpaw Princess Road
    Lostock
    BL6 4DR Bolton
    Lancashire
    British53978500002

    HIBERNIA FOODS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage deed
    Creato il 10 ott 2003
    Consegnato il 23 ott 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from hibernia foods bakeries limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The freehold property being land lying to the north of concord way preston farm stockton-on-tees t/n CE123477 together with all buildings & fixtures (including trade fixtures) fixed plant & machinery by way of fixed charge all present & future book & other debts.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 23 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Charge and release over deposit
    Creato il 16 ago 2002
    Consegnato il 22 ago 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The deposit by way of first fixed charge and release of the deposit until the liabilities have been paid or discharged in full. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Fortis Bank S.A./N.V.
    Transazioni
    • 22 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 04 set 2001
    Consegnato il 12 set 2001
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The freehold and leasehold property of the company known as all leasehold land under the lease dated 15/12/2000,as defined,with all fixtures buildings plant and machinery thereon; the benefit of all rights and claims whatsoever. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Fortis Bank F.A./N.V.
    Transazioni
    • 12 set 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    Equipment mortgage
    Creato il 09 mag 2001
    Consegnato il 19 mag 2001
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever arising under or pursuant to the mortgage
    Brevi particolari
    With full title guarantee the equipment (as defined) and all right title benefit and interest of the company in and to all the insurances and all warranties and other claims under or in connection with the sale to the purchase by the company of the equipment and/or its conditions and repair and all contracts and agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Gmac Commercial Credit Limited
    Transazioni
    • 19 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    Supplemental legal charge to composite guarantee and debenture dated 25TH september 1998
    Creato il 09 mag 2001
    Consegnato il 19 mag 2001
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company to the chargee incurred under the finance documents or any other document
    Brevi particolari
    The "newly acquired property" being l/h property k/a land on the east side of bridge road kingswood bristol. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Gmac Commercial Credit Limited
    Transazioni
    • 19 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    Supplemental legal charge to composite guarantee and debenture dated 25TH september 1998
    Creato il 09 mag 2001
    Consegnato il 19 mag 2001
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company to the chargee incurred under the finance documents or any other document
    Brevi particolari
    All the "newly acquired property" being f/h property k/a land at bridge road station road and hot water lane kingswood bristol AV246628. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Gmac Commercial Credit Limited
    Transazioni
    • 19 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 09 mag 2001
    Consegnato il 16 mag 2001
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property located on the south east of bridge road kingswood bristol t/no: AV246628 and all buildings and fixtures plant machinery and vehicles. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Fortis Bank S.A./N.V.
    Transazioni
    • 16 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    Account assignment
    Creato il 26 apr 2000
    Consegnato il 10 mag 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in respect of lease agreements (as defined)
    Brevi particolari
    All monies from time to time credited to and for the time being standing to the credit of account 60636096 held by the company with barclays bank PLC. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ing Lease (UK) LTD
    Transazioni
    • 10 mag 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 20 apr 2000
    Consegnato il 04 mag 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Fortis Bank Sa-Nv
    Transazioni
    • 04 mag 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 25 set 1998
    Consegnato il 12 ott 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Premises at concorde way preston farm industrial estate stockton in the county of stockton on tees t/n CE123477.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 ott 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 set 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 25 set 1998
    Consegnato il 12 ott 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Bt 97/6 park view industrial estate brenda road hartlepool t/n's CE87359 and CE97741.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 ott 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 set 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 25 set 1998
    Consegnato il 08 ott 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the undertaking property and assets of the company.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 ott 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 set 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Senior subordinated security trust deed
    Creato il 25 set 1998
    Consegnato il 09 ott 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations and liabilities owing by any chargor (as defined) to the holders of the notes, to bank of new york (the security trustee) and any receiver appointed pursuant to the deed whether incurred under the finance documents or any other document
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of New York
    Transazioni
    • 09 ott 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 25 set 1998
    Consegnato il 07 ott 1998
    In corso
    Importo garantito
    All obligations and liabilities due or to become due by any chargor (as defined) to the chargee under the finance documents (as defined) or any other document
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over all undertaking property and assets including goodwill book debts uncalled capital intellectual property rights fixtures fittings plant and machinery. Excluding to the extent that it cannot be charged the l/h premises at bridge road kingswood gloucestershire. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bny International Limited
    Transazioni
    • 07 ott 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ott 2003Nomina di un amministratore o gestore (405 (1))
    • 102 feb 2011Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (LQ02)
      • Numero di pratica 1
    Fixed and floating charge
    Creato il 01 giu 1998
    Consegnato il 11 giu 1998
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed equitable charge all book and other debts floating charge all the undertaking property rights and assets.
    Persone aventi diritto
    • Confidential Invoice Discounting Limited
    Transazioni
    • 11 giu 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    Chattel mortgage
    Creato il 22 gen 1997
    Consegnato il 29 gen 1997
    In corso
    Importo garantito
    £400,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    1 off gateaux (serial no's;-sta 105,std 106) to include ;-index conveyor, continuous conveyor, 5 off per line vertical depositors, 1 off per line horizontal depositors, three bridge table (graduated), 6 turntables 2). dry store racking 3). rondo roller (zms 800 serial no.A4059006) 4). mono multi depositor (fco 72E serial no.109346443).
    Persone aventi diritto
    • Allied Mills Limited
    Transazioni
    • 29 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage deed
    Creato il 07 gen 1997
    Consegnato il 27 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land lying to the north of concorde way,preston farm,stockton-on-tees with all buildings,fixtures,plant and machinery thereon; all book/other debts,other monetary claims and any amounts by way of rent,licence fee,etc; the goodwill of business and benefit of any licences and all guarantees or covenants; see form 395. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 27 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 07 gen 1997
    Consegnato il 27 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    First-the plant machinery chattels or other equipment. Secondly-the benefit of any guarantee, warranty or other obligation in relation to the mortgaged chattels. Thirdly-the benefit of all agreements now or hereafter entered into by the company or the benefit of which is otherwise vested in the company for the bailment or (in scotland) the hiring of the mortgaged chattels. Fourthly-all copyrights patents trademarks servicemarks brand names inventions design rights know-how and other intellectual property rights in or relating to the mortgaged chattels. Fifthly-the full benefit of the company's rights and interest (if any) in and to all insurance effected by the company or by any other person of the mortgaged chattels or the use thereof. The schedule- 2/32 oakesway hartlepool industrial estate hartlepool cleveland. HPSAV13 a gisuti 500 litre capacity stainless steel jacketed pressurised cooking vessel (1980) serial no. PJ8114 with access platform control panel and equipment. HPSAV14 a scaniro L7 food bin hoist (1984) serial no. 1685 with safety rail. HPSAV20 a laska ke/20-2 rotary bowl chopping machine serial no. R4678 with stainless steel case and control panel.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 27 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 07 gen 1997
    Consegnato il 22 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a land at concorde way stockton on tees t/n CE123477.
    Persone aventi diritto
    • Derek Cooper
    Transazioni
    • 22 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 07 gen 1997
    Consegnato il 22 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a land at concorde way stockton on tees t/n CE123477.
    Persone aventi diritto
    • Colin Tindling and Paul Ernest Hudson
    Transazioni
    • 22 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 ago 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 07 gen 1997
    Consegnato il 22 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a land at concorde way stockton on tees t/n CE123477.
    Persone aventi diritto
    • Pannell Kerr Forster Trustee Company Limited
    Transazioni
    • 22 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 07 gen 1997
    Consegnato il 22 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a 2/32 oakesway hartlepool industrial estate hartlepool cleveland with HPSAV13 a giusti 500 litre capacity stainless steel jacketed pressurised cooking vessel (1980) serial no.PJ8114 with access platform control panel and equipment, HPSAV14 a scaniro L7 food bin hoist (1984) serial no 1685 with safety rail, HPSAV20 a laska ke/20-2 rotary bowl chopping machine serial no R4678 with stainless steel case and control panel and all other chattels as detailed in the schedule attatched to the form 395 and all policies of insurance. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Pannell Kerr Forster Trustee Company Limitedas Trustees of the Derek Cooper Settlement
    Transazioni
    • 22 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 07 gen 1997
    Consegnato il 22 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a 2/32 oakesway hartlepool industrial estate hartlepool cleveland with HPSAV13 a giusti 500 litre capacity stainless steel jacketed pressurised cooking vessel (1980) serial no PJ8114 with access platform control panel and equipment, HPSAV14 a scaniro L7 food bin hoist (1984) serial no 1685 with safety rail, HPSAV20 a laska ke/20-2 rotary bowl chopping machine serial no R4678 with stainless steel case and control panel and all the other chattels as detailed in the schedule attatched to the form 395 with all policies of insurance. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Derek Cooper
    Transazioni
    • 22 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 07 gen 1997
    Consegnato il 22 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a 2/32 oakesway hartlepool industrial estate hartlepool cleveland with HPSAV13 a giusti 500 litre capacity stainless steel jacketed pressurised cooking vessel (1980) serial no PJ8114 with access platform control panel and equipment, HPSAV14 a scaniro L7 food bin hoist (1984) serial no 1685 with safety rail, HPSAV20 a laska ke/20-2 rotary bowl chopping machine serial no R4678 with stainless steel case and control panel, and all the other chattels as defined in the schedule attatched to the form 395 with all polocies of insurance. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Colin Tindling and Paul Ernest Hudson
    Transazioni
    • 22 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 set 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 29 mar 1996
    Consegnato il 04 apr 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a land & buildings lying to the north of concorde way preston farm stockton-on-tees cleveland t/no CE123477 and the proceeds of sale thereof.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 apr 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 ago 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    HIBERNIA FOODS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    25 set 1998Data dello strumento
    Ricevitore amministrativo nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Allan Watson Graham
    One Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Praticante
    One Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Myles Anthony Halley
    Kpmg Llp
    2 Cornwall Street
    B3 2DL Birmingham
    Praticante
    Kpmg Llp
    2 Cornwall Street
    B3 2DL Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0