CHOICESUK PLC

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCHOICESUK PLC
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà per azioni
    Numero di società 01870439
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CHOICESUK PLC?

    • (5212) /

    Dove si trova CHOICESUK PLC?

    Indirizzo della sede legale
    Pricewaterhousecoopers Llp
    12 Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CHOICESUK PLC?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HOME ENTERTAINMENT CORPORATION PLC02 ago 200102 ago 2001
    THE HOME ENTERTAINMENT CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY13 mag 198813 mag 1988
    VIDEO BOX OFFICE LIMITED08 mag 198508 mag 1985
    VIDEO TOP SHOP LIMITED08 gen 198508 gen 1985
    BOOKQUO LIMITED11 dic 198411 dic 1984

    Quali sono gli ultimi bilanci di CHOICESUK PLC?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al03 giu 2006

    Quali sono le ultime deposizioni per CHOICESUK PLC?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione di beni vacanti

    2 pagineBONA

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    11 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 13 ago 2012

    22 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 13 feb 2012

    6 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 13 ago 2011

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 13 feb 2011

    6 pagine4.68

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Ordinanza giudiziaria in materia di insolvenza

    Court order insolvency:- replacement of liquidator
    12 pagineLIQ MISC OC

    Avviso di cessazione di funzioni come liquidatore volontario

    1 pagine4.40

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 13 ago 2010

    6 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 13 feb 2010

    7 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 13 ago 2009

    35 pagine4.68

    Domanda di insolvenza

    Insolvency:s/s cert. Release of liquidator
    1 pagineLIQ MISC

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Ordinanza giudiziaria in materia di insolvenza

    Court order insolvency:replacement of liquidator
    7 pagineLIQ MISC OC

    Avviso di cessazione di funzioni come liquidatore volontario

    1 pagine4.40

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    11 pagine2.34B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 06 ago 2008

    11 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 21 ago 2008

    11 pagine2.24B

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di CHOICESUK PLC?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SEALEY, John Malcolm
    Willow House
    Ouse Lane
    NR12 0YP Hickling
    Norfolk
    Segretario
    Willow House
    Ouse Lane
    NR12 0YP Hickling
    Norfolk
    British12498550004
    BARCLAY, Fitzalbert
    The Old Barn
    Mill Lane Waternewton
    PE8 6LY Peterborough
    Cambridgeshire
    Amministratore
    The Old Barn
    Mill Lane Waternewton
    PE8 6LY Peterborough
    Cambridgeshire
    EnglandBritish111285680001
    BARKER, Stephen Edwin
    3 Old Rectory Drive, Thornhaugh
    PE8 6HW Peterborough
    Cambridgeshire
    Amministratore
    3 Old Rectory Drive, Thornhaugh
    PE8 6HW Peterborough
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish111553140001
    CLARK, Gareth Peter Andrew
    Burdenshot House
    Burdenshott Hill, Worplesdon
    GU3 3RL Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Burdenshot House
    Burdenshott Hill, Worplesdon
    GU3 3RL Guildford
    Surrey
    British69163560001
    DE KARE SILVER, Michael Phillip
    14 Wilton Street
    SW1X 7AF London
    Amministratore
    14 Wilton Street
    SW1X 7AF London
    United KingdomBritish212747870001
    GARDNER, Diane May
    44 Vetchfield
    Orton Brimbles
    PE2 5FH Peterborough
    Cambridgeshire
    Amministratore
    44 Vetchfield
    Orton Brimbles
    PE2 5FH Peterborough
    Cambridgeshire
    British12500160001
    HOPKINS, Geoffrey Douty Borrough
    Flat 3
    9 Roland Gardens
    SW7 3PE London
    Amministratore
    Flat 3
    9 Roland Gardens
    SW7 3PE London
    British12498580001
    MUSPRATT, Iain David
    Backwater House 50 Common Lane
    Hemingford Abbots
    PE28 9AW Huntingdon
    Cambridgeshire
    Amministratore
    Backwater House 50 Common Lane
    Hemingford Abbots
    PE28 9AW Huntingdon
    Cambridgeshire
    EnglandBritish12498560001
    PARKER, Roy David
    26 Lippitts Hill
    LU2 7YN Luton
    Bedfordshire
    Amministratore
    26 Lippitts Hill
    LU2 7YN Luton
    Bedfordshire
    British6523320001
    RIDING, Frederick Michael Peter
    5 Williams Grove
    Long Ditton
    KT6 5RN Surbiton
    Surrey
    Amministratore
    5 Williams Grove
    Long Ditton
    KT6 5RN Surbiton
    Surrey
    British76317830003
    SANDERS, David John
    Armstor House
    Vale Down, Lydford
    EX20 4BB Okehampton
    Devon
    Amministratore
    Armstor House
    Vale Down, Lydford
    EX20 4BB Okehampton
    Devon
    EnglandBritish44175100003
    SEALEY, John Malcolm
    Willow House
    Ouse Lane
    NR12 0YP Hickling
    Norfolk
    Amministratore
    Willow House
    Ouse Lane
    NR12 0YP Hickling
    Norfolk
    British12498550004
    SKITT, Anthony
    Moat Cottage
    South Street Woodhurst
    PE28 3BW Huntingdon
    Amministratore
    Moat Cottage
    South Street Woodhurst
    PE28 3BW Huntingdon
    British65351790002
    WHALLEY, Richard
    Rose Cottage 4 Teigh Road
    Market Overton
    LE15 7PW Oakham
    Leicestershire
    Amministratore
    Rose Cottage 4 Teigh Road
    Market Overton
    LE15 7PW Oakham
    Leicestershire
    British106175990001
    WHITE, Christopher John
    8 Salisbury Road
    Burbage
    LE10 2AR Hinckley
    Leicestershire
    Amministratore
    8 Salisbury Road
    Burbage
    LE10 2AR Hinckley
    Leicestershire
    EnglandBritish34823590001
    WILLS, David John
    15 Kildare Gardens
    W2 5JS London
    Amministratore
    15 Kildare Gardens
    W2 5JS London
    EnglandEnglish6523330001

    CHOICESUK PLC ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    All assets debenture
    Creato il 03 lug 2007
    Consegnato il 05 lug 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 05 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 set 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 21 set 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Debenture deed
    Creato il 01 ago 2001
    Consegnato il 04 ago 2001
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 04 ago 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 set 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 21 set 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Mortgage
    Creato il 17 ago 1994
    Consegnato il 20 ago 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold property known as 51/53 bassano rd,blackheath,rowley regis,west midlands;t/nos.wm 427148 and wm 278504 with all buildings/fixtures; goodwill of business and benefit of all guarantees or covenants; fixed charge over shares in any residents' or management company and all rentals payable. See form 395. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 20 ago 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 set 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 12 giu 1992
    Consegnato il 17 giu 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    80 stourport road, kidderminster by way of assignment the goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 17 giu 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 12 giu 1992
    Consegnato il 17 giu 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    782 hagley road, west quinton, west midlands by way of assignment the goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 17 giu 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 12 giu 1992
    Consegnato il 17 giu 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    51/53 bassano road, blackheath west midlands by way of assignment the goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 17 giu 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 12 giu 1992
    Consegnato il 17 giu 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    87/89 high street, cradley heath, west midlands by way of assignment the goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 17 giu 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 12 giu 1992
    Consegnato il 17 giu 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    1876/1878 pershore road, king's norton birmingham by way of assignment the goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 17 giu 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 12 giu 1992
    Consegnato il 17 giu 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land on the northwest side of bassano road, blackheath, west midlands by way of assignment the goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 17 giu 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A credit agreement
    Creato il 22 lug 1991
    Consegnato il 25 lug 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £35491-98 due from the company to the chargee pursuant to the terms of the agreement
    Brevi particolari
    All its right title and interest in and to all sums payable under the insurance (see 395 for more details).
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited
    Transazioni
    • 25 lug 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 27 giu 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 10 gen 1991
    Consegnato il 11 gen 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 11 gen 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 07 set 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 29 mar 1989
    Consegnato il 05 apr 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 75 rosemary street, mansfield nottinghamshire the goodwill of the business (if any).. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 05 apr 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 07 set 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 12 apr 1985
    Consegnato il 22 apr 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Inc. Stocks shares of other securities. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 22 apr 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 07 set 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    CHOICESUK PLC ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    22 ago 2007Inizio dell'amministrazione
    14 ago 2008Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Stephen Mark Oldfield
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Abacus House
    CB3 0AN Castle Park
    Cambridge
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Abacus House
    CB3 0AN Castle Park
    Cambridge
    Mark Nicholas Cropper
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    Michael John Andrew Jervis
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Colin Michael Trevethyn Haig
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Plumtree Court 3rd Floor
    EC4A 4HT London
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Plumtree Court 3rd Floor
    EC4A 4HT London
    2
    DataTipo
    14 ago 2008Inizio della liquidazione
    19 feb 2013Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Colin Michael Trevethyn Haig
    Pricewaterhousecoopers Llp
    12 Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp
    12 Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    Mark Nicholas Cropper
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    Russell Downs
    Pricewaterhousecoopers Llp Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    Ian C. Oakley-Smith
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0