WADE ALLIED LIMITED

WADE ALLIED LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWADE ALLIED LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01871630
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di WADE ALLIED LIMITED?

    • Altre industrie manifatturiere n.c.a. (32990) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova WADE ALLIED LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Wade Ceramics Ltd
    Bessemer Drive
    ST1 5GR Stoke-On-Trent
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di WADE ALLIED LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ALLIED INSULATORS LTD18 mar 198518 mar 1985
    OFFSHELF (45) LTD13 dic 198413 dic 1984

    Quali sono gli ultimi bilanci di WADE ALLIED LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per WADE ALLIED LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 apr 2017 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Bilancio annuale redatto al 11 apr 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 apr 2016

    Stato del capitale al 15 apr 2016

    • Capitale: GBP 7,975,050
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Wade Ceramics Limited 5 Bessemer Drive Eutria Stoke-on-Trent Staffordshire ST1 5GR England a C/O Wade Ceramics Ltd Bessemer Drive Stoke-on-Trent ST1 5GR in data 14 apr 2016

    1 pagineAD01

    Ripristino per ordine del tribunale

    3 pagineAC92

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 24 mar 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 mar 2012

    Stato del capitale al 27 mar 2012

    • Capitale: GBP 7,975,050
    SH01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 24 mar 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 mar 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Royal Victoria Pottery Westport Road Stoke on Trent Staffordshire ST6 4AG* in data 06 apr 2010

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    12 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di WADE ALLIED LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FARMER, Paul William
    The Pines
    Aynsleys Drive
    ST11 9HJ Blythe Bridge
    Staffordshire
    Segretario
    The Pines
    Aynsleys Drive
    ST11 9HJ Blythe Bridge
    Staffordshire
    BritishDirector107938650002
    DUKE, Edward
    Foul Rice Farm
    Marton Lordship Stillington
    YO61 1NT York
    Amministratore
    Foul Rice Farm
    Marton Lordship Stillington
    YO61 1NT York
    United KingdomBritishCompany Director1876560002
    FARMER, Paul William
    The Pines
    Aynsleys Drive
    ST11 9HJ Blythe Bridge
    Staffordshire
    Amministratore
    The Pines
    Aynsleys Drive
    ST11 9HJ Blythe Bridge
    Staffordshire
    EnglandBritishDirector107938650002
    JACKSON, Paul William
    24 Ashendene Grove
    Hanford
    ST4 8NL Stoke On Trent
    Staffordshire
    Segretario
    24 Ashendene Grove
    Hanford
    ST4 8NL Stoke On Trent
    Staffordshire
    British8655120001
    BAILEY, Anthony Stanley
    2 Crossway Road
    Sneyd Green
    ST6 2NE Stoke On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    2 Crossway Road
    Sneyd Green
    ST6 2NE Stoke On Trent
    Staffordshire
    BritishCompany Director8655130001
    BIGGIN, Anthony John
    Paddock End Ridley Hill Farm
    Ridley
    CW6 9RX Tarporley
    Cheshire
    Amministratore
    Paddock End Ridley Hill Farm
    Ridley
    CW6 9RX Tarporley
    Cheshire
    BritishDirector58388890001
    COOPER, Alan Raymond
    63 Seven Star Road
    B91 2BZ Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    63 Seven Star Road
    B91 2BZ Solihull
    West Midlands
    BritishDirector33870610001
    COOPER, Grant Geoffrey
    1 Monkleigh Close
    Treentham
    ST4 8TP Stoke On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    1 Monkleigh Close
    Treentham
    ST4 8TP Stoke On Trent
    Staffordshire
    EnglandBritishProduction Director148123670001
    GIDMAN, Leonard
    17 Barley Croft
    Alsager
    ST7 2QU Stoke On Trent
    Amministratore
    17 Barley Croft
    Alsager
    ST7 2QU Stoke On Trent
    United KingdomBritishCompany Director72471890002
    GILHAM, Clive Martin
    No 3 Birch House, The Alders
    Allerton Park Chapel
    LS1 4ND Allerton
    Leeds, West Yorkshire
    Amministratore
    No 3 Birch House, The Alders
    Allerton Park Chapel
    LS1 4ND Allerton
    Leeds, West Yorkshire
    BritishCompany Director97163670001
    HUGHES, Michael Thomas
    1 Rambleford Way
    ST16 1TW Stafford
    Staffordshire
    Amministratore
    1 Rambleford Way
    ST16 1TW Stafford
    Staffordshire
    EnglandEnglishFoundry Director80207070001
    JACKSON, Paul William
    24 Ashendene Grove
    Hanford
    ST4 8NL Stoke On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    24 Ashendene Grove
    Hanford
    ST4 8NL Stoke On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritishDirector8655120001
    JACKSON, Paul William
    24 Ashendene Grove
    Hanford
    ST4 8NL Stoke On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    24 Ashendene Grove
    Hanford
    ST4 8NL Stoke On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritishCompany Director8655120001
    KINGSBURY, Derek John
    Birling Long Bottom Lane
    Seer Green
    HP9 2UL Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Birling Long Bottom Lane
    Seer Green
    HP9 2UL Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director18255570001
    LEE, Thomas Barrie
    1 Brookside
    GU6 7BA Cranleigh
    Surrey
    Amministratore
    1 Brookside
    GU6 7BA Cranleigh
    Surrey
    BritishCompany Director8655160001
    LIPTROT, Frederick James
    3 The Mount
    ST13 6QZ Leek
    Staffordshire
    Amministratore
    3 The Mount
    ST13 6QZ Leek
    Staffordshire
    BritishCompany Director26359780001
    MEIGHAN, Jonathon Adam
    7 The Brambles
    ST5 4JJ Newcastle
    Staffordshire
    Amministratore
    7 The Brambles
    ST5 4JJ Newcastle
    Staffordshire
    BritishCompany Director69523400001
    PAGE, Michael Brian
    90 Station Road
    Cropston
    LE7 7HE Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    90 Station Road
    Cropston
    LE7 7HE Leicester
    Leicestershire
    EnglandEnglishManaging Director24710330001
    PERRIN, Donald Roy
    65 Kingsgate Avenue
    CT10 3LW Broadstairs
    Kent
    Amministratore
    65 Kingsgate Avenue
    CT10 3LW Broadstairs
    Kent
    EnglandBritishCompany Director76317740001
    POULTER, John William
    28 Sydney Road
    TW9 1UB Richmond
    Surrey
    Amministratore
    28 Sydney Road
    TW9 1UB Richmond
    Surrey
    BritishCompany Director4333730002
    RILEY, Frank Edward
    Four Trees
    Wetton Lane Butterton
    ST13 7ST Leek
    Staffordshire
    Amministratore
    Four Trees
    Wetton Lane Butterton
    ST13 7ST Leek
    Staffordshire
    BritishCompany Director8655170001
    SHENTON, Reginald Gordon
    Cowal Meadows Farm Crowborough
    Lask Edge
    ST13 8QW Leek
    Staffordshire
    Amministratore
    Cowal Meadows Farm Crowborough
    Lask Edge
    ST13 8QW Leek
    Staffordshire
    BritishCompany Director26359790001
    TRAVERS, Richard Benjamin
    Ragleth House
    73 High Street
    SY6 6BY Church Stretton
    Salop
    Amministratore
    Ragleth House
    73 High Street
    SY6 6BY Church Stretton
    Salop
    BritishCompany Director34916570001

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per WADE ALLIED LIMITED?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    11 apr 2017La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società.

    WADE ALLIED LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 23 set 2009
    Consegnato il 24 set 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Advantage Transition Bridge Fund Limited
    Transazioni
    • 24 set 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 feb 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 02 ott 2006
    Consegnato il 13 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 13 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 set 2008Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 15 mar 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 02 ott 2006
    Consegnato il 13 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Any sums or sums standing to the credit if any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 13 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mar 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    All asset debenture
    Creato il 02 ott 2006
    Consegnato il 07 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 07 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 set 2008Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 15 mar 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 02 ott 2006
    Consegnato il 05 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a land on the north and south side of leek new road, milton, stoke on trent, staffordshire t/no SF294002 by way of floating charge all plant, machinery, goodwill. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 05 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mar 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage
    Creato il 02 ott 2006
    Consegnato il 05 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a land at milton, leek new road, milton, stoke on trent, staffordshire t/no SF117104. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 05 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mar 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed and floating security agreement
    Creato il 11 apr 2006
    Consegnato il 21 apr 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Itochu Corporation
    Transazioni
    • 21 apr 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ott 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 17 set 2003
    Consegnato il 24 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 24 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 ott 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 01 ago 2003
    Consegnato il 07 ago 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land at milton leek new road milton stoke on trent. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 07 ago 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 ott 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 11 giu 2002
    Consegnato il 13 giu 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property k/a land on the west side of sandbach road, cobridge, stoke on trent, t/n SF324387 (part). With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 13 giu 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 ott 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 04 mar 2002
    Consegnato il 06 mar 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings on the north and south sides of leek new road milton t/no;-SF117104. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 06 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mag 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 feb 2002
    Consegnato il 15 feb 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £100,000 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The f/h land at leek new road milton stoke on trent t/n SF117104.
    Persone aventi diritto
    • Woodford Industries Limited
    Transazioni
    • 15 feb 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 20 mag 1999
    Consegnato il 08 giu 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All amounts payable under £1,800,000 8% secured loan stock and £500,000 20% secured loan stock issued to the chargee and all other future actual or contingent obligations and liabilities owed to the chargee by the company or any of the other companies named in schedule 1 of the composite guarantee and debenture
    Brevi particolari
    First fixed charge over the company's present and future interest in plant and machinery stock shares debentures bonds or other securities and share rights attaching to them money standing to the credit of accounts book and other debts and the proceeds of their realisation the benefits and proceeds of insurances and the right of return of any insurance premium the benefit of all licences ,goodwill uncalled capital and by way of floating charge all the company's present and future undertaking and assets.
    Persone aventi diritto
    • Capital Partners Ii Limited
    Transazioni
    • 08 giu 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 set 2008Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 12 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 20 mag 1999
    Consegnato il 05 giu 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee under the finance documents or any other document
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bny International Limited
    Transazioni
    • 05 giu 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 22 gen 1998
    Consegnato il 29 gen 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 29 gen 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 22 gen 1998
    Consegnato il 27 gen 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property at leek new road milton stoke on trent. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 27 gen 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 30 giu 1987
    Consegnato il 16 lug 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee and all moneys due from fairey group limited an any account whatsoever to security pacific everofimance (UK) limited.
    Brevi particolari
    F/Hold land at buildings on the north & south sies of leek new road, milton stoke on trent t/n sf 117104 & the proceeds of sale thereof and all buildings and trade and athes fixtures. See doc M24/17JUL/ln.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Security Pacific Everofimance (UK.) Limited
    Transazioni
    • 16 lug 1987Registrazione di un'ipoteca
    Fixed and floating charge
    Creato il 16 gen 1987
    Consegnato il 04 feb 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from fairey group limited to samuel montagu & co. Limited as agent & trustee for itself and the banks under the terms of the loan agreement dated 31 dec '86 and for securing all moneys due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to samuel montagu & co. Limited as agent and trustee for itself and the banks under the term of the a foresaid loan agreement dated 31 dec '86
    Brevi particolari
    F/Hold land & buildings on the south side of hampton street, hanley, stoke-on-trent, staffordshire. Title no. Sf 215608. f/hold land & buildings on the north and south sides of leek new road, milton, stoke-on-trent title no. Sf 11704 specific equitable charge over all esates & interests in any f/h & l/h property charged to the company/other than the property referred to above. Assignment of all debts and other sums of money (please see doc for fuller details).
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montagu & Co Limitedas Agent and Trusee for Itself and the Banks Joined as Parties to the Loan Agreement
    Transazioni
    • 04 feb 1987Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage debenture
    Creato il 16 gen 1987
    Consegnato il 27 gen 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Legal mortgage and or the proceeds of sale on f/h land & buildings on the south side of hampton street henley stoke on trent. Title no SE 215608 and f/h land & buildings on the north and south sides of leek new road milton stoke on trent. Title no. Sf 11704. a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 27 gen 1987Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 15 mar 1985
    Consegnato il 26 mar 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings on the north and south sides of leek new road milton staffordshire title no. Sf 117104.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 mar 1985Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 11 mar 1985
    Consegnato il 26 mar 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Including trade fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 mar 1985Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0