RIVENDELL NURSERIES LIMITED

RIVENDELL NURSERIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàRIVENDELL NURSERIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01873497
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di RIVENDELL NURSERIES LIMITED?

    • Altro commercio al dettaglio in negozi non specializzati (47190) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

    Dove si trova RIVENDELL NURSERIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Nursery
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    Suffolk
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di RIVENDELL NURSERIES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DASHKILO LIMITED20 dic 198420 dic 1984

    Quali sono gli ultimi bilanci di RIVENDELL NURSERIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al28 feb 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per RIVENDELL NURSERIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 25 feb 2016

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Nomina di Mr Mark Haddock come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Ian William Furniss come segretario in data 17 feb 2016

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Mark Haddock come amministratore in data 17 feb 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Ian William Furniss come segretario in data 17 feb 2016

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Ian William Furniss come amministratore in data 17 feb 2016

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2015

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 09 nov 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 nov 2015

    Stato del capitale al 09 nov 2015

    • Capitale: GBP 1,275,000
    SH01

    Cessazione della carica di Andrew Michael Lawrence Staff come amministratore in data 31 mar 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 09 nov 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 dic 2014

    Stato del capitale al 04 dic 2014

    • Capitale: GBP 1,275,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2014

    7 pagineAA

    Nomina di Mr Ian William Furniss come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Andrew Staff come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Ian William Furniss come segretario

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Andrew Staff come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 09 nov 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 dic 2013

    Stato del capitale al 05 dic 2013

    • Capitale: GBP 1,275,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2013

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 09 nov 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio redatto al 29 feb 2012

    11 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di RIVENDELL NURSERIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HADDOCK, Mark William
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    The Nursery
    Suffolk
    Amministratore
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    The Nursery
    Suffolk
    EnglandEnglish205242470001
    ANDREW, Stephen Robert
    Chapel Farmhouse Chapel Lane
    Mouldsworth
    CH3 8BF Chester
    Cheshire
    Segretario
    Chapel Farmhouse Chapel Lane
    Mouldsworth
    CH3 8BF Chester
    Cheshire
    British49087860002
    COOKSON, Michael Dean
    Bankside Farm
    Winsford Road
    CW7 4DL Wettenhall Winsford
    Cheshire
    Segretario
    Bankside Farm
    Winsford Road
    CW7 4DL Wettenhall Winsford
    Cheshire
    British2233500002
    FURNISS, Ian William
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    The Nursery
    Suffolk
    Segretario
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    The Nursery
    Suffolk
    188397290001
    HOWARD, Vera Sally
    Mill Green Farm
    Millgreen Lane
    WA8 3UP Widnes
    Cheshire
    Segretario
    Mill Green Farm
    Millgreen Lane
    WA8 3UP Widnes
    Cheshire
    British31045050001
    STAFF, Andrew Michael Lawrence
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    The Nursery
    Suffolk
    Segretario
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    The Nursery
    Suffolk
    British134035650001
    WALKER, Linda Margaret
    21 Cornelia Crescent
    Belvidere
    SY2 5NA Shrewsbury
    Shropshire
    Segretario
    21 Cornelia Crescent
    Belvidere
    SY2 5NA Shrewsbury
    Shropshire
    British48968430002
    BARNES, Ian Malcolm
    Holly House The Fold
    Dorrington
    SY5 7JD Shrewsbury
    Shropshire
    Amministratore
    Holly House The Fold
    Dorrington
    SY5 7JD Shrewsbury
    Shropshire
    United KingdomBritish37745750001
    COLE, Michael David
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    The Nursery
    Suffolk
    Amministratore
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    The Nursery
    Suffolk
    United KingdomBritish146969370001
    FAUN, Stephen
    2 Worleston Close
    CW10 0RG Middlewich
    Cheshire
    Amministratore
    2 Worleston Close
    CW10 0RG Middlewich
    Cheshire
    British81650270001
    FULKER, Alan Ernest
    White Lodge 17 Overhill Road
    SK9 2BE Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    White Lodge 17 Overhill Road
    SK9 2BE Wilmslow
    Cheshire
    British2233530001
    FURNISS, Ian William
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    The Nursery
    Suffolk
    Amministratore
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    The Nursery
    Suffolk
    EnglandBritish117943650001
    GRUNDY, Paul
    74 Broadwalk
    SK9 5PN Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    74 Broadwalk
    SK9 5PN Wilmslow
    Cheshire
    EnglandBritish17333220001
    HOWARD, Harry
    Mill Green Farm
    Mill Green Lane
    WA8 3UP Widnes
    Cheshire
    Amministratore
    Mill Green Farm
    Mill Green Lane
    WA8 3UP Widnes
    Cheshire
    British31045060001
    HOWARD, Vera Sally
    Mill Green Farm
    Millgreen Lane
    WA8 3UP Widnes
    Cheshire
    Amministratore
    Mill Green Farm
    Millgreen Lane
    WA8 3UP Widnes
    Cheshire
    British31045050001
    KING, Andrew James
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    The Nursery
    Suffolk
    Amministratore
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    The Nursery
    Suffolk
    EnglandBritish217979240001
    NOTCUTT, Roger William
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    The Nursery
    Suffolk
    Amministratore
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    The Nursery
    Suffolk
    EnglandBritish134038090001
    SCOTT, Graham Robert
    216 Main Road
    Goostrey
    CW4 8PE Crewe
    Cheshire
    Amministratore
    216 Main Road
    Goostrey
    CW4 8PE Crewe
    Cheshire
    British44672550004
    SPURLING, Anthony Christopher
    36 Mossgrove Road
    Timperley
    WA15 6LF Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    36 Mossgrove Road
    Timperley
    WA15 6LF Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritish106994510001
    STAFF, Andrew Michael Lawrence
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    The Nursery
    Suffolk
    Amministratore
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    The Nursery
    Suffolk
    EnglandBritish134035650001
    WHITING, Richard Antony
    Chestnut Farm
    Cross Lane, Kermincham
    CW12 2LJ Congleton
    Cheshire
    Amministratore
    Chestnut Farm
    Cross Lane, Kermincham
    CW12 2LJ Congleton
    Cheshire
    EnglandBritish327792630001

    RIVENDELL NURSERIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee & debenture
    Creato il 02 ott 2008
    Consegnato il 09 ott 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 ott 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 ago 2010Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    Legal charge
    Creato il 01 ott 2008
    Consegnato il 04 ott 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property k/a rivendell garden centre mill lane bold heath widnes cheshire t/no CH381559, CH385422 and CH426389.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 04 ott 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage debenture
    Creato il 30 mar 2000
    Consegnato il 10 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 10 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 nov 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 20 ott 1994
    Consegnato il 25 ott 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The land on the west side of mill lane, bold, widnes, cheshire t/n MS238440 and the f/h property k/a rivendell nurseries, mill lane, bold, widnes together with all fixtures and fittings. The benefit of all rights licences guarantees rent deposits contract deeds undertakings and warranties and goodwill of the company.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 25 ott 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 ott 1986
    Consegnato il 24 ott 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land situate on the west side of mill lane, bold.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 24 ott 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 21 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 ott 1986
    Consegnato il 24 ott 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land known as field 19 and part of field 21 O.S. survey sheet for mill lane, bold.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 24 ott 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 21 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 28 feb 1985
    Consegnato il 06 mar 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge over book debts & other debts.. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 06 mar 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 21 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0