O.L.C. (HOLDINGS) LIMITED

O.L.C. (HOLDINGS) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàO.L.C. (HOLDINGS) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01874277
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di O.L.C. (HOLDINGS) LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova O.L.C. (HOLDINGS) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Glendevon House Hawthorn Park
    Coal Road
    LS14 1PQ Leeds
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di O.L.C. (HOLDINGS) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per O.L.C. (HOLDINGS) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    18 pagine4.71

    Indirizzo della sede legale modificato da 5th Floor Maple House Mutton Lane Potters Bar Hertfordshire EN6 5BS United Kingdom in data 18 nov 2011

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 31 ott 2011

    LRESSP

    Bilancio annuale redatto al 16 giu 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 lug 2011

    Stato del capitale al 07 lug 2011

    • Capitale: GBP 36,728.8
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    5 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da 11-12 Frederick Road Edgbaston Birmingham B15 1JD in data 21 feb 2011

    1 pagineAD01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Neil Michael Croxson il 05 mag 2010

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 16 giu 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    5 pagineAA

    legacy

    3 pagine288a

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    9 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine288c

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    9 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    legacy

    2 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di O.L.C. (HOLDINGS) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CROXSON, Neil Michael
    Hawthorn Park
    Coal Road
    LS14 1PQ Leeds
    Glendevon House
    Amministratore
    Hawthorn Park
    Coal Road
    LS14 1PQ Leeds
    Glendevon House
    United KingdomBritishCfo96469690003
    LASCHKAR, Henri-Paul
    23 Hyde Park Place
    W2 2LP London
    Flat 2
    Amministratore
    23 Hyde Park Place
    W2 2LP London
    Flat 2
    UkFrenchS V P139160640001
    ANGEL, Barry Paul
    41 Frampton Way
    Totton
    SO40 9AD Southampton
    Hampshire
    Segretario
    41 Frampton Way
    Totton
    SO40 9AD Southampton
    Hampshire
    BritishBusiness Executive9549440001
    EVETTS, John Graham
    72 Sycamore Avenue
    RM14 2HS Upminster
    Essex
    Segretario
    72 Sycamore Avenue
    RM14 2HS Upminster
    Essex
    Pollish/British56188860003
    JAMES, Simon Michael
    37 Brand Hill Drive
    Crofton
    WF4 1PF Wakefield
    Yorkshire
    Segretario
    37 Brand Hill Drive
    Crofton
    WF4 1PF Wakefield
    Yorkshire
    British111338120001
    POWELL, Alexander John
    The Croft Chichester Road
    GU29 9QE Midhurst
    West Sussex
    Segretario
    The Croft Chichester Road
    GU29 9QE Midhurst
    West Sussex
    British11440630001
    TALLIS, Aleksandra Jadwiga
    6 St Chads Grove
    LS6 3PN Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    6 St Chads Grove
    LS6 3PN Leeds
    West Yorkshire
    Polish34638000004
    AMOS, Michael Charles Gilbert
    1 Harlands Grove
    BR6 7WB Orpington
    Kent
    Amministratore
    1 Harlands Grove
    BR6 7WB Orpington
    Kent
    BritishChartered Secretary9904110001
    ANGEL, Barry Paul
    41 Frampton Way
    Totton
    SO40 9AD Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    41 Frampton Way
    Totton
    SO40 9AD Southampton
    Hampshire
    BritishBusiness Executive9549440001
    BOLGER, Eamon Joseph
    149 Ard Na Mara
    Malahide
    IRISH Dublin
    Ireland
    Amministratore
    149 Ard Na Mara
    Malahide
    IRISH Dublin
    Ireland
    IrishAccountant114519590001
    BURR, Anthony Hugh
    Woodend House
    33 Woodlands Avenue
    WS5 3LN Walsall
    West Midlands
    Amministratore
    Woodend House
    33 Woodlands Avenue
    WS5 3LN Walsall
    West Midlands
    BritishDirector986020002
    CUTTING, Anthony
    29 Hollycombe Close
    GU30 7HR Liphook
    Hampshire
    Amministratore
    29 Hollycombe Close
    GU30 7HR Liphook
    Hampshire
    BritishCompany Director37491490001
    FITCHETT, David John
    22 Lynwood Heights
    WD3 4ED Rickmansworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    22 Lynwood Heights
    WD3 4ED Rickmansworth
    Hertfordshire
    EnglandUnited KingdomChartered Accountant83165530001
    FRASER, Angus Maclean
    3 Fulwith Mill Lane
    HG2 8HJ Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    3 Fulwith Mill Lane
    HG2 8HJ Harrogate
    North Yorkshire
    IrishCo Dir70451130001
    HAYWOOD, Timothy Paul
    The Yeoman House
    Acton
    DY13 9TF Stourport On Severn
    Worcestershire
    Amministratore
    The Yeoman House
    Acton
    DY13 9TF Stourport On Severn
    Worcestershire
    United KingdomBritishDirector62962370002
    HOGG, David Ribton
    Farleton
    282 Botley Road Burridge
    SO31 1BQ Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    Farleton
    282 Botley Road Burridge
    SO31 1BQ Southampton
    Hampshire
    BritishBusiness Executive2809630001
    JORDAN, Alan
    56 Chiltley Way
    GU30 7HE Liphook
    Hampshire
    Amministratore
    56 Chiltley Way
    GU30 7HE Liphook
    Hampshire
    IrishBusiness Executive73934080001
    LAYCOCK, Derek Francis
    The Fosse
    4 Fitzroy Road
    GU51 4JH Fleet
    Hampshire
    Amministratore
    The Fosse
    4 Fitzroy Road
    GU51 4JH Fleet
    Hampshire
    BritishBusiness Executive78294880001
    LILLIS, James Anthony
    10 Offington Drive
    Sutton
    13 Dublin
    Ireland
    Amministratore
    10 Offington Drive
    Sutton
    13 Dublin
    Ireland
    IrishBusiness Executive49070590001
    LYTLE, John Edward Patrick
    Littledale
    Cedar Road Hook Heath
    GU22 0JH Woking
    Surrey
    Amministratore
    Littledale
    Cedar Road Hook Heath
    GU22 0JH Woking
    Surrey
    BritishCompany Director11440670001
    MULLEN, Kenneth John
    Tonhil House
    Borrowby
    YO7 4QQ Thirsk
    North Yorkshire
    Amministratore
    Tonhil House
    Borrowby
    YO7 4QQ Thirsk
    North Yorkshire
    United KingdomScottishCompany Director146642810001
    ORAM, Trevor Sidney
    Mitford
    Strood Green
    RH14 0HN Wisborough Green
    West Sussex
    Amministratore
    Mitford
    Strood Green
    RH14 0HN Wisborough Green
    West Sussex
    BritishCompany Director16514370001
    PASSMAN, Jonathan Richard
    Stonefield Close
    Wigston Park Walsgrave
    CV2 2PZ Coventry
    6
    Amministratore
    Stonefield Close
    Wigston Park Walsgrave
    CV2 2PZ Coventry
    6
    BritishHead Of Legal122460330002
    POWELL, Alexander John
    The Croft Chichester Road
    GU29 9QE Midhurst
    West Sussex
    Amministratore
    The Croft Chichester Road
    GU29 9QE Midhurst
    West Sussex
    EnglandBritishBusiness Executive11440630001
    ROFF, Alan
    25 College Close
    PO9 6AJ Rowlands Castle
    Hampshire
    Amministratore
    25 College Close
    PO9 6AJ Rowlands Castle
    Hampshire
    EnglandBritishBusiness Executive205772150001
    SIMPSON, Stuart Douglas
    2 Wadham Gardens
    NW3 3DP London
    Amministratore
    2 Wadham Gardens
    NW3 3DP London
    EnglandBritishInvestment Banker99057720001
    WESTMAN, Lawrence
    Whitescross
    Foxrock
    IRISH Dublin 18
    Newpark House
    Ireland
    Amministratore
    Whitescross
    Foxrock
    IRISH Dublin 18
    Newpark House
    Ireland
    IrelandIrishBusiness Director241846320001

    O.L.C. (HOLDINGS) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage debenture
    Creato il 16 ago 1996
    Consegnato il 05 set 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 05 set 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mag 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 25 gen 1995
    Consegnato il 15 feb 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 feb 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 set 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Collateral debenture
    Creato il 25 gen 1995
    Consegnato il 30 gen 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from blackstone holdings limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 30 gen 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 set 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    O.L.C. (HOLDINGS) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    31 ott 2011Inizio della liquidazione
    18 dic 2012Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Julian Pitts
    Glendevon House Hawthorn Park
    Coal Road
    LS14 1PQ Leeds
    Praticante
    Glendevon House Hawthorn Park
    Coal Road
    LS14 1PQ Leeds
    David Frederick Wilson
    Begbies Traynor
    Glendevon House
    LS14 1PQ Hawthorn Park
    Coal Road Leeds
    Praticante
    Begbies Traynor
    Glendevon House
    LS14 1PQ Hawthorn Park
    Coal Road Leeds

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0