WICKES NOMINEE LIMITED

WICKES NOMINEE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWICKES NOMINEE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01874380
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di WICKES NOMINEE LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova WICKES NOMINEE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    MAZARS LLP
    45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di WICKES NOMINEE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    WICKES UK HOLDINGS LIMITED16 dic 198516 dic 1985
    WICKES INVESTMENTS LIMITED07 feb 198507 feb 1985
    SHINEFORE LIMITED27 dic 198427 dic 1984

    Quali sono gli ultimi bilanci di WICKES NOMINEE LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al30 giu 2015
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 mar 2016
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Quali sono le ultime deposizioni per WICKES NOMINEE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dettagli del direttore cambiati per Miss Deborah Grimason il 13 ott 2016

    2 pagineCH01

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagine4.71

    Indirizzo della sede legale modificato da Lodge Way House Lodge Way Harlestone Road Northampton Northamptonshire NN5 7UG a 45 Church Street Birmingham B3 2RT in data 06 gen 2016

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 21 dic 2015

    LRESSP

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 14 dic 2015

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio annuale redatto al 18 ott 2015 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 ott 2015

    Stato del capitale al 22 ott 2015

    • Capitale: GBP 335,012
    SH01

    Nomina di Miss Deborah Grimason come amministratore in data 10 set 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Anthony David Buffin come amministratore in data 10 set 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di John Peter Carter come amministratore in data 10 set 2015

    1 pagineTM01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 dic 2014 al 30 giu 2015

    1 pagineAA01

    Bilancio annuale redatto al 18 ott 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 nov 2014

    Stato del capitale al 04 nov 2014

    • Capitale: GBP 335,012
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    1 pagineAA

    Cessazione della carica di Andrew Stephen Pike come segretario in data 23 set 2014

    1 pagineTM02

    Nomina di Tp Directors Ltd come amministratore in data 19 set 2014

    2 pagineAP02

    Risoluzioni

    Resolutions
    16 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01

    Nomina di Anthony David Buffin come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 18 ott 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 nov 2013

    Stato del capitale al 04 nov 2013

    • Capitale: GBP 335,012
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    1 pagineAA

    Cessazione della carica di Paul Hampden Smith come amministratore

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di WICKES NOMINEE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GRIMASON, Deborah
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    Amministratore
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    EnglandBritish185755960002
    TP DIRECTORS LTD
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    Amministratore
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione03480295
    191205550001
    PIKE, Andrew Stephen
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Travis Perkins Plc
    Northamptonshire
    Segretario
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Travis Perkins Plc
    Northamptonshire
    British65678800002
    RIMMER, Barbara
    28 Chapel Lane
    Hale Barns
    WA15 0HN Altrincham
    Cheshire
    Segretario
    28 Chapel Lane
    Hale Barns
    WA15 0HN Altrincham
    Cheshire
    British76973560002
    STOKES-SMITH, Keith Reginald
    5a The Broadway
    Penn Road
    HP9 2PD Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Segretario
    5a The Broadway
    Penn Road
    HP9 2PD Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British75650590001
    ARCHER, William Ernest
    The Priory
    2 Astley Close
    WA16 8GJ Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    The Priory
    2 Astley Close
    WA16 8GJ Knutsford
    Cheshire
    British15170380004
    BATTERSBY, Geoffrey Brian
    13 15 Westcombe Park Road
    Blackheath
    SE3 7RE London
    Amministratore
    13 15 Westcombe Park Road
    Blackheath
    SE3 7RE London
    British41548740003
    BHOTE, Sanaya Homi
    50 Bonnersfield Lane
    HA1 2LE Harrow
    Middlesex
    Amministratore
    50 Bonnersfield Lane
    HA1 2LE Harrow
    Middlesex
    British72716110002
    BIRD, Richard Sidney
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Amministratore
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    British111500210001
    BUFFIN, Anthony David
    Lodge Way House
    Lodge Way Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    Lodge Way House
    Lodge Way Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritish178011680001
    CARTER, John Peter
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Amministratore
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    United KingdomBritish46226920007
    CORNER, Michael Richmond
    95 Castelnau
    Barnes
    SW13 London
    Amministratore
    95 Castelnau
    Barnes
    SW13 London
    British21206150001
    GRIMSEY, William
    The Capita Group Plc
    71 Victoria Street
    SW1H 0XA London
    Amministratore
    The Capita Group Plc
    71 Victoria Street
    SW1H 0XA London
    United KingdomBritish50647840002
    HAMPDEN SMITH, Paul Nigel
    Travis Perkins Plc, Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    Travis Perkins Plc, Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritish72135950007
    HORNE, Nicholas Paul Stewart
    4 Braemar Close
    GU7 1SA Godalming
    Surrey
    Amministratore
    4 Braemar Close
    GU7 1SA Godalming
    Surrey
    British983490001
    HOSKINS, William John
    3 Homewood Road
    AL1 4BE St. Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    3 Homewood Road
    AL1 4BE St. Albans
    Hertfordshire
    British49295070002
    LLEWELLYN, Trefor Wilmot
    Hill Farm House
    Ipsden
    OX10 6AD Wallingford
    Oxfordshire
    Amministratore
    Hill Farm House
    Ipsden
    OX10 6AD Wallingford
    Oxfordshire
    EnglandBritish107250730001
    PENNY, Michael William Harrison
    Windrush
    9 Downsway
    GU1 2YA Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Windrush
    9 Downsway
    GU1 2YA Guildford
    Surrey
    United KingdomBritish144262470001
    RICE, John Michael
    Wayside Cottage
    Street Lane Rodeheath
    ST7 3SN Cheshire
    Amministratore
    Wayside Cottage
    Street Lane Rodeheath
    ST7 3SN Cheshire
    British72718070001
    STOKES-SMITH, Keith Reginald
    5a The Broadway
    Penn Road
    HP9 2PD Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    5a The Broadway
    Penn Road
    HP9 2PD Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British75650590001
    STRADLING, Stuart Rhys
    68 Howards Lane
    Putney
    SW15 6QD London
    Amministratore
    68 Howards Lane
    Putney
    SW15 6QD London
    United KingdomBritish44265550001
    SWEETBAUM, Henry Alan
    11 Park Village West
    NW1 4AE London
    Amministratore
    11 Park Village West
    NW1 4AE London
    United KingdomAmerican10349960001
    WILSON, Geoffrey Charles
    Broadoaks
    237 Seabridge Lane
    ST5 3TB Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Amministratore
    Broadoaks
    237 Seabridge Lane
    ST5 3TB Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British72996700001

    WICKES NOMINEE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A mezzanine debenture
    Creato il 28 lug 2003
    Consegnato il 13 ago 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the issuer and each of the other guarantors to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ing Bank N.V. , London Branch, (As Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties)
    Transazioni
    • 13 ago 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Senior security accession deed
    Creato il 29 gen 2003
    Consegnato il 13 feb 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All money and liabilities due or to become due from each charging company and each of the other obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ing Bank N.V.London Branch,as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties
    Transazioni
    • 13 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Subordinated security accession deed
    Creato il 29 gen 2003
    Consegnato il 13 feb 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All money and liabilities due or to become due from each charging company and each of the other obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ing Bank N.V.London Branch,as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties
    Transazioni
    • 13 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 ago 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security accession deed between the company, focus do it all limited (the "parent") and ing bank N.V., london branch (the "security agent") supplemental to a debenture entered into pursuant to the subordinated loan agreement dated 29.12.00 between inter alia, the parent and the security agent
    Creato il 16 gen 2001
    Consegnato il 31 gen 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All money and liabilities now or hereafter due, owing or incurred to the secured parties (or any of them) by each charging company and each of the other obligors under the finance documents (or any of them) in whatsoever manner together with all interest accruing thereon and all costs, charges and expenses incurred by any of the secured parties
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ing Bank N.V.,London Branch
    Transazioni
    • 31 gen 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 giu 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 29 dic 2000
    Consegnato il 09 gen 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All money and liabilities due or to become due from each charging company (as defined) and each of the other obligors under the finance documents (as defined),to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Ing Bank N.V. London Branch (As Security Agent)
    Transazioni
    • 09 gen 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 feb 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security accession deed between wickes nominee limited, the parent (as defined) and ing bank N.V. london branch (being supplemental to a debenture dated 26TH september 2000)
    Creato il 27 ott 2000
    Consegnato il 06 nov 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All money and liabilities due or to become due from each charging company (as defined) and each of the other obligors (as defined) to the secured parties (as defined) under the finance documents (as defined) (or any of them)
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ing Bank N.V. London Branch
    Transazioni
    • 06 nov 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 feb 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 07 gen 1997
    Consegnato il 15 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies and liabilities due owing or incurred in any manner by each charging company to the chargee (as security trustee for and on behalf of the banks) in accordance with any applicable facilities agreement
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 set 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Limited recourse guarantee and debenture
    Creato il 12 dic 1996
    Consegnato il 20 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and all or any of the o f the companies named therein to the chargee as agent and trustee for the banks (as defined) under the facilities agreement (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 set 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 03 lug 1996
    Consegnato il 10 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All the new money liabilities (as defined therein) outstanding, due or owing or incurred by the charging companies (as defined therein) to the chargee
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 10 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 dic 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    WICKES NOMINEE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    21 dic 2015Inizio della liquidazione
    09 mag 2017Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Simon David Chandler
    C/O Mazars Llp 1st Floor
    Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Praticante
    C/O Mazars Llp 1st Floor
    Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Scott Christian Bevan
    Mazars Llp 45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    Praticante
    Mazars Llp 45 Church Street
    B3 2RT Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0