SPIRE WASHINGTON HOSPITAL LIMITED

SPIRE WASHINGTON HOSPITAL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSPIRE WASHINGTON HOSPITAL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01879848
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SPIRE WASHINGTON HOSPITAL LIMITED?

    • Attività delle case di cura mediche (86102) / Attività sanitarie e di assistenza sociale

    Dove si trova SPIRE WASHINGTON HOSPITAL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    3 Dorset Rise
    EC4Y 8EN London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SPIRE WASHINGTON HOSPITAL LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    GOLDSBOROUGH DEVELOPMENTS LIMITED26 mar 198526 mar 1985
    ZEDMORE BUILDING LIMITED22 gen 198522 gen 1985

    Quali sono gli ultimi bilanci di SPIRE WASHINGTON HOSPITAL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per SPIRE WASHINGTON HOSPITAL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Daniel Francis Toner il 06 giu 2014

    2 pagineCH01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 19 gen 2016

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Share premium cancelled 16/12/2015
    RES13

    Bilancio annuale redatto al 29 dic 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 gen 2016

    Stato del capitale al 07 gen 2016

    • Capitale: GBP 12,000,000
    SH01

    Cessazione della carica di Simon Gordon come amministratore in data 12 nov 2015

    1 pagineTM01

    Nomina di Spire Healthcare Limited come amministratore in data 02 nov 2015

    2 pagineAP02

    Cessazione della carica di Robert Roger come amministratore in data 02 nov 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    12 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Simon Gordon il 01 giu 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Robert Roger il 01 giu 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Robert Roger il 01 lug 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Simon Gordon il 01 lug 2015

    2 pagineCH01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Thames House Portsmouth Road Esher Surrey KT10 9AD United Kingdom a 42-50 Hersham Road Walton-on-Thames Surrey KT12 1RZ

    1 pagineAD02

    Bilancio annuale redatto al 29 dic 2014 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 gen 2015

    Stato del capitale al 05 gen 2015

    • Capitale: GBP 12,000,000
    SH01

    Soddisfazione dell'onere 21 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 29 dic 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 gen 2014

    Stato del capitale al 09 gen 2014

    • Capitale: GBP 12,000,000
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da * 120 Holborn London EC1N 2TD* in data 12 dic 2013

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 29 dic 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di SPIRE WASHINGTON HOSPITAL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    TONER, Daniel Francis
    Dorset Rise
    EC4Y 8EN London
    3
    Segretario
    Dorset Rise
    EC4Y 8EN London
    3
    British100270040001
    TONER, Daniel Francis
    Dorset Rise
    EC4Y 8EN London
    3
    Amministratore
    Dorset Rise
    EC4Y 8EN London
    3
    United KingdomBritish100270040003
    SPIRE HEALTHCARE LIMITED
    Dorset Rise
    EC4Y 8EN London
    3
    United Kingdom
    Amministratore
    Dorset Rise
    EC4Y 8EN London
    3
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione1522532
    202359590001
    BEAZLEY, Nicholas Tetley
    The Dower House
    Westmill
    SG9 9LY Buntingford
    Hertfordshire
    Segretario
    The Dower House
    Westmill
    SG9 9LY Buntingford
    Hertfordshire
    British105797560001
    MORRIS, David Richard
    22 Lee Lane East
    Horsforth
    LS18 5RE Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    22 Lee Lane East
    Horsforth
    LS18 5RE Leeds
    West Yorkshire
    British64514410001
    WALFORD, Arthur David
    94 London Road
    HA7 4NS Stanmore
    Middlesex
    Segretario
    94 London Road
    HA7 4NS Stanmore
    Middlesex
    British6658190001
    BARKER, Hilary Jane
    Flat B22 Herbal Hill Gardens
    9 Herbal Hill
    EC1R 5EJ London
    Amministratore
    Flat B22 Herbal Hill Gardens
    9 Herbal Hill
    EC1R 5EJ London
    British62838010001
    BEAZLEY, Nicholas Tetley
    The Dower House
    Westmill
    SG9 9LY Buntingford
    Hertfordshire
    Amministratore
    The Dower House
    Westmill
    SG9 9LY Buntingford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish105797560001
    BURNS, Robert Ian
    6 Netherfield Road
    AL5 2AG Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    6 Netherfield Road
    AL5 2AG Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish36584260002
    DAVIES, Julian Peter
    Timberlea, Warminster Road
    South Newton
    SP2 0QW Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    Timberlea, Warminster Road
    South Newton
    SP2 0QW Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritish29367700001
    DE GORTER, Jean Jacques, Dr
    Holborn
    EC1N 2TD London
    120
    Amministratore
    Holborn
    EC1N 2TD London
    120
    United KingdomFrench128865640001
    DONALD, Alan Charles
    13 Craven Gardens
    Wimbledon
    SW19 8LU London
    Amministratore
    13 Craven Gardens
    Wimbledon
    SW19 8LU London
    British58742090001
    DUGDALE, Michael Ian
    29 Magnolia Dene
    HP15 7QE Hazlemere
    Buckinghamshire
    Amministratore
    29 Magnolia Dene
    HP15 7QE Hazlemere
    Buckinghamshire
    British79570840001
    ELLERBY, Mark
    Burton Grange
    Burton Leonard
    HG3 3SU Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Burton Grange
    Burton Leonard
    HG3 3SU Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritish40582650004
    FOZARD, Ian
    The Old Brewhouse
    8a Waterside
    HG5 9AZ Knaresborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    The Old Brewhouse
    8a Waterside
    HG5 9AZ Knaresborough
    North Yorkshire
    EnglandBritish21934910001
    GORDON, Simon
    Dorset Rise
    EC4Y 8EN London
    3
    Amministratore
    Dorset Rise
    EC4Y 8EN London
    3
    United KingdomBritish162037020001
    GRAY, Duncan Archibald
    51 Exchange Building
    132 Commercial Street
    E1 6NG London
    Amministratore
    51 Exchange Building
    132 Commercial Street
    E1 6NG London
    EnglandBritish68845270002
    GREGORY, Fraser David
    9 Nightingale Shott
    TW20 9SU Egham
    Berkshire
    Amministratore
    9 Nightingale Shott
    TW20 9SU Egham
    Berkshire
    United KingdomBritish107664270001
    HAYES, Dominic Patrick Thomas
    The Old Presbytery
    Rudding Lane Follifoot
    HG3 1DQ Harrogate
    Yorkshire
    Amministratore
    The Old Presbytery
    Rudding Lane Follifoot
    HG3 1DQ Harrogate
    Yorkshire
    EnglandBritish126532450001
    HOLDEN, Dean Allan
    Spring House
    Spring Hill Fordcombe
    TN3 0SE Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    Spring House
    Spring Hill Fordcombe
    TN3 0SE Tunbridge Wells
    Kent
    British32671980002
    HOLLINGSWORTH, Clare Margaret
    House Farm
    Crowhurst Lane Crowhurst
    RH7 6LR Lingfield
    Mansion
    Surrey
    Amministratore
    House Farm
    Crowhurst Lane Crowhurst
    RH7 6LR Lingfield
    Mansion
    Surrey
    United KingdomBritish62952630002
    JONES, Richard James Edward
    Holborn
    EC1N 2TD London
    120
    Amministratore
    Holborn
    EC1N 2TD London
    120
    EnglandBritish133019680001
    KEE, Fergus Alexander
    The Old Cottage
    Howe Green
    SG13 8LH Hertford
    Amministratore
    The Old Cottage
    Howe Green
    SG13 8LH Hertford
    United KingdomIrish26911740008
    KENT, Benjamin David Jemphrey
    Fernleigh Lodge
    Northchurch Common
    HP4 1LR Berkhamsted
    Hertfordshire
    Amministratore
    Fernleigh Lodge
    Northchurch Common
    HP4 1LR Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritish93897360003
    MORRIS, David Richard
    22 Lee Lane East
    Horsforth
    LS18 5RE Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    22 Lee Lane East
    Horsforth
    LS18 5RE Leeds
    West Yorkshire
    British64514410001
    ROGER, Robert
    Dorset Rise
    EC4Y 8EN London
    3
    Amministratore
    Dorset Rise
    EC4Y 8EN London
    3
    United KingdomBritish151959030001
    SABOURN, Denis
    35 Boroughbridge Road
    HG5 0ND Knaresborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    35 Boroughbridge Road
    HG5 0ND Knaresborough
    North Yorkshire
    British22209730001
    SMITH, Graham
    Moor Lane
    LS297AF Burley In Wharfedale
    Briarfield
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Moor Lane
    LS297AF Burley In Wharfedale
    Briarfield
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish142125320001
    SMITH, Russell Stansfield
    64 Riverside Court
    Victoria Road
    BD18 3LZ Shipley
    Saltaire
    Amministratore
    64 Riverside Court
    Victoria Road
    BD18 3LZ Shipley
    Saltaire
    British809230004
    STEVENS, Geoffrey Robert
    Beech House
    3 Millhouses Court
    S11 9HZ Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    Beech House
    3 Millhouses Court
    S11 9HZ Sheffield
    South Yorkshire
    United KingdomBritish57380020001
    TAYLOR, Neil Robert
    Highfield
    Church Street
    HG5 8NR Goldsborough
    Knaresborough
    Amministratore
    Highfield
    Church Street
    HG5 8NR Goldsborough
    Knaresborough
    United KingdomBritish62846800003
    WALFORD, Arthur David
    94 London Road
    HA7 4NS Stanmore
    Middlesex
    Amministratore
    94 London Road
    HA7 4NS Stanmore
    Middlesex
    United KingdomBritish6658190001
    WHEATON, James Gordon
    The Long Barn, Mount Mill Farm
    Stratford Road, Wicken
    MK19 6DG Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    The Long Barn, Mount Mill Farm
    Stratford Road, Wicken
    MK19 6DG Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British77841040001
    WISE, Robert Jeffrey
    Holborn
    EC1N 2TD London
    120
    Amministratore
    Holborn
    EC1N 2TD London
    120
    United KingdomAustralian125754410002

    SPIRE WASHINGTON HOSPITAL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security accession deed
    Creato il 22 ott 2008
    Consegnato il 29 ott 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland (The Security Agent)
    Transazioni
    • 29 ott 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 ott 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A supplemental deed to the borrower debenture dated 17 july 2002
    Creato il 23 lug 2005
    Consegnato il 03 ago 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsosver under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The preference shares all dividends interest and other monies payable in respect. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Trustee (C.I.) Limited (as the Borrower Security Trustee for the Borrower Securedcreditors)
    Transazioni
    • 03 ago 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 ago 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 17 lug 2002
    Consegnato il 31 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Trustee (C.I.) Limited as Borrower Security Trustee (as Defined Therein)
    Transazioni
    • 31 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ago 2005Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 29 ago 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 16 lug 1996
    Consegnato il 20 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Tunbridge wells independent hospital ashurst park fordcombe tunbridge wells t/no K699273 and the proceeds of sale thereof with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 28 mar 1996
    Consegnato il 12 apr 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or goldsborough healthcare PLC to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a land on the east side of picktree lane washigton tyne & wear sunderland t/n ty 222310. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 12 apr 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 25 set 1995
    Consegnato il 12 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a harts house harts grove monkhams grove estate snakes lane woodford green. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 12 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 25 set 1995
    Consegnato il 06 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H land & buildings k/a yale hospital croesnewydd road wrexham t/no WA510296 and the proceeds of sale thereof with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 06 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment
    Creato il 25 set 1995
    Consegnato il 06 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the medium term loan facility letter dated 21ST july 1995
    Brevi particolari
    All rights in the work carried out in relation to land at acre street lindley huddersfield.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 06 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 07 ott 1993
    Consegnato il 15 ott 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H land on the east side of picktree lane washington tyne & wear. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank Plcas Agent & Trustee for Itself & Each of the Banks (As Defined in the Charge)
    Transazioni
    • 15 ott 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 12 ott 1992
    Consegnato il 21 ott 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever as defined in "the debenture"
    Brevi particolari
    Freehold goldsborough nursing home 76 wellington road enfield,middlesex title number ngl 58225 freehold 3 wetherby road,leeds title number WYK381268 1A wetherby road,leeds title number wyk 38221 see doc ref M565C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank Plcin Its Capacity as Agent and Trustee for Itselfand Each of the Banks
    Transazioni
    • 21 ott 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 dic 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 09 ott 1992
    Consegnato il 10 ott 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £7,050 due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    134 almsford drive harrogate.
    Persone aventi diritto
    • Vera Woods
    Transazioni
    • 10 ott 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mar 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 14 set 1992
    Consegnato il 15 set 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1000,00 due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    24 wentworth court harrogate north yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • Lady Ruth Madeleine Dawson
    Transazioni
    • 15 set 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mar 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 31 lug 1992
    Consegnato il 01 ago 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £23,050.00
    Brevi particolari
    2 esplanade court, st marys walk, harrogate, north yorkshire and garage.
    Persone aventi diritto
    • Jack Woolard
    • Constance Rayner Woolard
    Transazioni
    • 01 ago 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mar 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 15 lug 1992
    Consegnato il 16 lug 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £550 due from the company to the chargees
    Brevi particolari
    Flat 3 grayson house, harrogate, north yorkshire and garage.
    Persone aventi diritto
    • Arthur Knowlson Dytch
    • Sadie Elizabeth Dytch
    Transazioni
    • 16 lug 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mar 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 24 giu 1992
    Consegnato il 25 giu 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £ 12,050 and all other monies due from the company to the chargee under the terms of this deed
    Brevi particolari
    29 dorchester road,fixby,huddersfield.
    Persone aventi diritto
    • Faith Waide Crummack
    Transazioni
    • 25 giu 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ago 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 16 apr 1992
    Consegnato il 21 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £6,550 due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    9 grayson house, beech grove, harrogate and garage.
    Persone aventi diritto
    • Joan Pamela Paul
    Transazioni
    • 21 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 lug 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & trust debenture
    Creato il 06 mar 1991
    Consegnato il 20 mar 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the financing documents and the security documents (as defined)
    Brevi particolari
    Various properties as defined in form 395 ref M78.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank Plcas Trustee for Itself
    Transazioni
    • 20 mar 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 01 giu 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 17 dic 1990
    Consegnato il 21 dic 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    First fixed charge on all book and other debts, floating charge or all other the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 21 dic 1990Registrazione di un'ipoteca
    Letter of charge
    Creato il 06 set 1989
    Consegnato il 11 set 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from goldsborough limited and/or goldsborough homecare services (pendle) limited and/or goldsborough home care & nursing services limited and/or piper higginson home care limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any account or account(s) of the company in the bank's books.
    Persone aventi diritto
    • Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 set 1989Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 01 set 1987
    Consegnato il 04 set 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or goldsborough limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land having a frontage to ripon rd and swan rd. N. yorks.
    Persone aventi diritto
    • The Governor & Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 set 1987Registrazione di un'ipoteca
    Letter of charge
    Creato il 12 set 1985
    Consegnato il 02 ott 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the goldsborough limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any account or accounts of the company in the bank's books.
    Persone aventi diritto
    • The Governor & Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 02 ott 1985Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0