SIX BROADGATE LIMITED
Panoramica
Nome della società | SIX BROADGATE LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01881641 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di SIX BROADGATE LIMITED?
- Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni
Dove si trova SIX BROADGATE LIMITED?
Indirizzo della sede legale | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di SIX BROADGATE LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
BROADGATE (PHASE 4) PUBLIC LIMITED COMPANY | 03 lug 1986 | 03 lug 1986 |
JORDANS 214 PUBLIC LIMITED COMPANY | 30 gen 1985 | 30 gen 1985 |
Quali sono gli ultimi bilanci di SIX BROADGATE LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2021 |
Quali sono le ultime deposizioni per SIX BROADGATE LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Charles John Middleton come amministratore in data 31 mar 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Stato del capitale al 18 mar 2022
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Josephine Hayman come amministratore in data 09 mar 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Nick Taunt come amministratore in data 10 mar 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Gavin Bergin come amministratore in data 09 mar 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Bruce Michael James come amministratore in data 31 dic 2021 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 dic 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2021 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Gavin Bergin come amministratore in data 29 mar 2021 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 dic 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr Nick Taunt come amministratore in data 05 ott 2020 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Tom Robson come amministratore in data 11 set 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2020 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Josephine Hayman come amministratore in data 31 gen 2020 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Tom Robson come amministratore in data 31 gen 2020 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 dic 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2019 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 3 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di SIX BROADGATE LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED | Segretario | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom |
| 187856670001 | ||||||||||
MCNUFF, Jonathan Charles | Amministratore | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 205624050001 | ||||||||
BRAINE, Anthony | Segretario | 21 Woodville Road Ealing W5 2SE London | British | 32809000002 | ||||||||||
FORSHAW, Christopher Michael John | Segretario | 44 Kerris Way Lower Earley RG6 5UW Reading Berkshire | British | 1898090001 | ||||||||||
HALLAM, Jonathan Paul | Segretario | 11 Trinity Road SW19 8QT London | British | 36631180001 | ||||||||||
HUGHES, Paul | Segretario | Lark Rise 5 Greville Park Avenue KT21 2QS Ashtead Surrey | British | 23950030001 | ||||||||||
MORKEL, Alan Gaunson | Segretario | Bramble Cottage 1 Churn Lane Horsmonden TN12 8HL Tonbridge Kent | British | 2068470001 | ||||||||||
PENRICE, Victoria Margaret | Segretario | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | 190034800001 | |||||||||||
ADAM, Shenol | Amministratore | 13 Beech Drive N2 9NX London | British | Director Of Companies | 2068480001 | |||||||||
BARZYCKI, Sarah Morrell | Amministratore | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | United Kingdom | British | Head Of Finance | 58016770004 | ||||||||
BELL, Lucinda Margaret | Amministratore | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | England | British | Chartered Accountant | 32809050044 | ||||||||
BERGIN, Gavin | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Secretary | 251327820001 | ||||||||
BERRY, David Charles | Amministratore | Portland Dene Valley Way SL9 7PN Gerrards Cross Buckinghamshire | British | Chartered Accountant | 166550001 | |||||||||
BLACKBURN, David Michael | Amministratore | Lansdowne Road W11 3AL London 7 | England | British | Director Of Companies | 67601540001 | ||||||||
BOWDEN, Robert Edward | Amministratore | The Chase Ongar Road CM15 0DG Kelvedon Hatch Essex | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 152497530001 | ||||||||
BRADMAN, Godfrey Michael | Amministratore | 15 Hanover Terrace NW1 4RJ London | British | Chairman & Chief Executive-The Rosehaugh Grp | 2068500001 | |||||||||
CAMP, David John | Amministratore | 11 Walham Grove SW6 London | British | New Business Director | 4807190002 | |||||||||
CARTER, Simon Geoffrey | Amministratore | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | United Kingdom | British | Treasury Executive | 170891060001 | ||||||||
CLARKE, Peter Courtenay | Amministratore | Oakmeade Park Road SL2 4PG Stoke Poges Berkshire | United Kingdom | British | Chartered Secretary | 78691990003 | ||||||||
DANTZIC, Roy Matthew | Amministratore | 65 Springfield Road St Johns Wood NW8 0QJ London | British | Financial Director | 52294450003 | |||||||||
DOYLE, Eugene Francis | Amministratore | 2 Gombards AL3 5NW St. Albans Hertfordshire | United Kingdom | Irish | Associate Director | 73961570001 | ||||||||
GROSE, Benjamin Toby | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 146546000001 | ||||||||
HALLAM, Jonathan Paul | Amministratore | 11 Trinity Road SW19 8QT London | British | Solicitor | 36631180001 | |||||||||
HAYMAN, Josephine | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 266797860001 | ||||||||
HESTER, Stephen Alan Michael | Amministratore | 3 Ilchester Place W14 8AA London | British | Chief Executive | 51688320001 | |||||||||
JAMES, Bruce Michael | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | Head Of Secretariat | 226746900001 | ||||||||
JONES, Andrew Marc | Amministratore | Hazlewell Road Putney SW15 6LH London 2 | England | British | Company Director | 82020730004 | ||||||||
KALMAN, Stephen Lionel | Amministratore | 81 Eastbury Road HA6 3AP Northwood Middlesex | England | British | Chartered Surveyor | 1188110001 | ||||||||
KERSHAW, Peter | Amministratore | 34 Esher Park Avenue KT10 9NX Esher Surrey | British | Director Of Companies | 51322410001 | |||||||||
LIPTON, Stuart Anthony, Sir | Amministratore | 40 Queens Grove NW8 6HH London | England | British | Director Of Companies | 2068540001 | ||||||||
MANNION, Michael John Francis | Amministratore | 32 Acacia Way The Hollies DA15 8WW Sidcup Kent | United Kingdom | British | Civil Engineer | 57126040001 | ||||||||
METLISS, Cyril | Amministratore | 25 Foscote Road Hendon NW4 3SE London | British | Chartered Accountant | 3079600001 | |||||||||
MIDDLETON, Charles John | Amministratore | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | United Kingdom | British | Corporate Tax Executive | 79841030002 | ||||||||
RITBLAT, John, Sir | Amministratore | The Doric Villa 20 York Terrace East Regents Park NW1 4PT London | England | British | Chairman And Managing Director | 41694870001 | ||||||||
RITBLAT, Nicholas Simon Jonathan | Amministratore | 37 Queens Grove NW8 6HN London | United Kingdom | British | Company Director | 35758050004 |
Chi sono le persone con controllo significativo di SIX BROADGATE LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broadgate City Limited | 06 apr 2016 | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
SIX BROADGATE LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Group debenture | Creato il 23 nov 1992 Consegnato il 01 dic 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the "overide agreement" dated 23RD november 1992 and this charge | |
Brevi particolari See doc ref M99 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge | Creato il 23 nov 1992 Consegnato il 25 nov 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the debenture dated 8/7/87 as supplemented by an agreement dated 29/10/92 and under the loan agreement dated 8/7/87 | |
Brevi particolari Fixed equitable charge over the benefit and every interest hedging agreement pursuant to clause 7 of the override agreement dated 23/11/92 , the benefit of account no: 1133018 and all monies due in respect of the interest hedging account, the benefit of account no: 1115680 (see form 395 for full details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 08 lug 1987 Consegnato il 16 lug 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 2/4/85 and a deed of covenant dated 8/7/87 and under the terms of the charge. | |
Brevi particolari Moneys standing to the credit of account number 70200239 held by the company with barclays bank PLC and all other rights titles & benefits whatsoever present and future of the compnay therein or inrespect thereof (other than entitlement to interest accruing to such principal sum). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 08 lug 1987 Consegnato il 14 lug 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the loan agreement dated 8/7/87 and the deed of priority dated 8/7/87 and under the terms of the debenture. | |
Brevi particolari First all that f/h land comprised in a transfer dated 8/7/87 and secondly the land and airspace demised by a lease dated 8/7/87. (see form 395 for full details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
First fixed charge | Creato il 08 lug 1987 Consegnato il 10 lug 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or rosehaugh stanhope developments PLC to the chargee under the terms of an agreement dated 2/4/85 and a deed of covenant dated 8/7/87 and under the terms of this charge | |
Brevi particolari The principal sum for the time being maintained in the account in the name of the company at barclays bank PLC account no. 30200220 and all other rights titles and benefits whatsoever present and future of the company theron or in respect thereof (other than entitlement to interest accruing to such principal sum. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 08 lug 1987 Consegnato il 10 lug 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or rosehaugh stanhope developments PLC to the chargee under the terms of an agreement dated 2/4/85 and a deed of covenant dated 8/7/87 and under the terms of this charge. | |
Brevi particolari All that land on the site of the former broad street station, london EC2. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0