ADMINSTORE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàADMINSTORE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01882853
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ADMINSTORE LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova ADMINSTORE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ADMINSTORE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    EUROPA CONVENIENCE STORES LIMITED26 apr 198526 apr 1985
    ADMINSTORE LIMITED05 feb 198505 feb 1985

    Quali sono gli ultimi bilanci di ADMINSTORE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al29 feb 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per ADMINSTORE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    11 pagineLIQ13

    Indirizzo della sede legale modificato da Tesco House, Shire Park Kestrel Way Welwyn Garden City AL7 1GA United Kingdom a 1 More London Place London SE1 2AF in data 22 apr 2021

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato Tesco House Shire Park Kestrel Way Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1GA

    2 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a Tesco House Shire Park Kestrel Way Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1GA

    2 pagineAD02

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 24 feb 2021

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    6 pagineLIQ01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 24 feb 2021

    • Capitale: GBP 1.000000
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Sahre premium account cancelled 08/02/2021
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancel share prem a/c / dividend in specie 08/02/2021
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 29 feb 2020

    13 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 12 ott 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    legacy

    176 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Nomina di Lynda Jane Heywood come amministratore in data 10 gen 2020

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Bruce Marsh come amministratore in data 10 gen 2020

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Tesco Services Limited come amministratore in data 10 gen 2020

    1 pagineTM01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 23 feb 2019

    13 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 12 ott 2019 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di ADMINSTORE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    TESCO SECRETARIES LIMITED
    Shire Park
    Kestrel Way
    AL7 1GA Welwyn Garden City
    Tesco House
    United Kingdom
    Segretario
    Shire Park
    Kestrel Way
    AL7 1GA Welwyn Garden City
    Tesco House
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione08730224
    182118090001
    HEYWOOD, Lynda Jane
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Amministratore
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    EnglandBritish213408010001
    WELCH, Robert John
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Amministratore
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    United KingdomBritish212146700001
    O'KEEFE, Helen Jane
    New Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    Segretario
    New Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    British96031250001
    PATEL, Anil Gunvantbhai
    18 Spinnells Road
    Rayners Lane
    HA2 9RA Harrow
    Middlesex
    Segretario
    18 Spinnells Road
    Rayners Lane
    HA2 9RA Harrow
    Middlesex
    British6518780001
    SANKAR, Nadine Amanda
    90 Edbury Road
    WD1 2SB Watford
    Hertfordshire
    Segretario
    90 Edbury Road
    WD1 2SB Watford
    Hertfordshire
    British97385340001
    BELL, Robbie Ian
    101 Hemp Lane
    Wigginton
    HP23 6HE Tring
    Hertfordshire
    Amministratore
    101 Hemp Lane
    Wigginton
    HP23 6HE Tring
    Hertfordshire
    United KingdomBritish97384120001
    FIELD, Martin John
    42 Lygean Avenue
    SG12 7AR Ware
    Hertfordshire
    Amministratore
    42 Lygean Avenue
    SG12 7AR Ware
    Hertfordshire
    British71986450003
    HOLMES, Colin Peter
    Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    Amministratore
    Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    British86778500002
    IDDON, Michael James
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Tesco House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Tesco House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish147746220002
    LEAHY, Terence Patrick, Sir
    New Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    Amministratore
    New Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    United KingdomBritish183358310001
    LLOYD, Jonathan Mark
    New Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    Amministratore
    New Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    United KingdomBritish160028560001
    MARSH, Adrian Ross Thomas
    Delamare Road
    Cheshunt
    EN89SL Herts
    Tesco House
    England And Wales
    United Kingdom
    Amministratore
    Delamare Road
    Cheshunt
    EN89SL Herts
    Tesco House
    England And Wales
    United Kingdom
    United KingdomBritish157987530001
    MARSH, Bruce
    Shire Park
    Kestrel Way
    AL7 1GA Welwyn Garden City
    Tesco House
    United Kingdom
    Amministratore
    Shire Park
    Kestrel Way
    AL7 1GA Welwyn Garden City
    Tesco House
    United Kingdom
    United KingdomBritish209704350001
    MCMEIKAN, Kennedy
    Saint Rhadegund Villa
    82 Chesterton Road
    CB4 1ER Cambridge
    Amministratore
    Saint Rhadegund Villa
    82 Chesterton Road
    CB4 1ER Cambridge
    British90169080001
    MOORE, Paul Anthony
    Shire Park
    Kestrel Way
    AL7 1GA Welwyn Garden City
    Tesco House
    United Kingdom
    Amministratore
    Shire Park
    Kestrel Way
    AL7 1GA Welwyn Garden City
    Tesco House
    United Kingdom
    EnglandBritish194306140002
    NEVILLE-ROLFE, Lucy Jeanne, Ms.
    New Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    Amministratore
    New Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    United KingdomBritish148079740001
    PATEL, Jitendrakumar Maganbhai
    2 Hedgeside Road
    HA6 2NX Northwood
    Middlesex
    Amministratore
    2 Hedgeside Road
    HA6 2NX Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritish94807170001
    PATEL, Maheshkumar Mohanbhai
    9 Poles House Poles Park
    Hanbury Drive
    SG12 0UD Thundridge
    Hertfordshire
    Amministratore
    9 Poles House Poles Park
    Hanbury Drive
    SG12 0UD Thundridge
    Hertfordshire
    United KingdomBritish,155258730001
    PATEL, Nareshkumar Mohanbhai
    15 Broad Walk
    Winchmore Hill
    N21 3DA London
    Amministratore
    15 Broad Walk
    Winchmore Hill
    N21 3DA London
    British6518810001
    TESCO SERVICES LIMITED
    Shire Park
    Kestrel Way
    AL7 1GA Welwyn Garden City
    Tesco House
    United Kingdom
    Amministratore
    Shire Park
    Kestrel Way
    AL7 1GA Welwyn Garden City
    Tesco House
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione7600956
    175259630001
    TESCO SERVICES LIMITED
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Tesco House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Tesco House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione7600956
    175259630001

    Chi sono le persone con controllo significativo di ADMINSTORE LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Shire Park
    Kestrel Way
    AL7 1GA Welwyn Garden City
    Tesco House
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Shire Park
    Kestrel Way
    AL7 1GA Welwyn Garden City
    Tesco House
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleUnited Kingdom (England)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione00243011
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    ADMINSTORE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge (corporate)
    Creato il 28 feb 2002
    Consegnato il 07 mar 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The l/h property k/a 53-55 balham hill in the london borough of wandsworth t/n 34912. together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 07 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ott 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 05 dic 2001
    Consegnato il 06 dic 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 5 croxted road dulwich london SE21.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 dic 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ott 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 03 dic 2001
    Consegnato il 06 dic 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property 1-3 croxted road dulwich london SE21.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 dic 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ott 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 18 ott 2001
    Consegnato il 25 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a 25 clifton road maida vale london W9.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ott 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 18 ott 2001
    Consegnato il 25 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a 21 and 23 clifton road maida vale london W9 t/n NGL543702.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ott 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Third party legal charge
    Creato il 18 set 1998
    Consegnato il 25 set 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from europa foods limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a europa house northolt industrial estate northolt l/b of ealing t/n NGL75568. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 25 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ott 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 08 mag 1997
    Consegnato il 20 mag 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Barclays bank PLC re adminstore limited consideration charged business premium account number 10094064. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ott 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 08 mag 1997
    Consegnato il 20 mag 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Barclays bank PLC re adminstore limited 90% full drawdown trust business premium account number 50400718. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ott 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 08 mag 1997
    Consegnato il 20 mag 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Barclays bank PLC re adminstore limited cash cover charged business premium account number 60895857. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ott 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 03 nov 1994
    Consegnato il 04 nov 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 83 western road brighton t/n SX82457. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 04 nov 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ott 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 03 nov 1994
    Consegnato il 04 nov 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that f/h property k/a 83 western road in district of brighton and county of east sussex t/n SX82457 together with all buildings and fixtures. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 04 nov 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ott 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 04 mag 1994
    Consegnato il 11 mag 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    83 gloucester road and 18 stanhope mews west london borough of kensington and chelsea t/n NGL573219.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 mag 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ott 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 12 nov 1993
    Consegnato il 22 nov 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Ground floor shop & basement 110 baker street & ground floor shop & basement 112 baker street l/b of westminster.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 22 nov 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ott 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage deed
    Creato il 25 apr 1990
    Consegnato il 30 apr 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Sterling pounds 468,000 from the company to the chargee under the mortgage conditions
    Brevi particolari
    53-55 balham hill london T.n- 34912.
    Persone aventi diritto
    • Leamington Spa Building Society
    Transazioni
    • 30 apr 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 10 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 17 apr 1990
    Consegnato il 26 apr 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 53 and 55 balham hill title no 34912 tog with all plant and machinery the goodwill of the business and the benefit of licenses held.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Baroda
    Transazioni
    • 26 apr 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 23 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 29 mar 1990
    Consegnato il 10 apr 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Floating charge over all the. Undertaking and all property and assets.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 10 apr 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 11 ott 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 13 lug 1989
    Consegnato il 24 lug 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Bank Leumi (UK) PLC
    Transazioni
    • 24 lug 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 10 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 10 lug 1989
    Consegnato il 12 lug 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a europe house northolt industrial estate northolt middlesex title no ngl 75568 tog with all buildings & fixtures and the goodwill of the business and the benefit of licenses held. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Ucb Bank PLC
    Transazioni
    • 12 lug 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 10 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 31 mag 1989
    Consegnato il 13 giu 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property at 83, western road, brighton & all fixtures title no sx 87457 & goodwill of the business.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 13 giu 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 07 nov 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 06 apr 1989
    Consegnato il 12 apr 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Sterling pounds 300,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    F/H land with warehouse & office premises formerly k/a the beecham building rowdell road western avenue northolt middlesex title no ngl 75568.
    Persone aventi diritto
    • Guardian Assurance PLC
    Transazioni
    • 12 apr 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 13 giu 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Further charge
    Creato il 10 giu 1988
    Consegnato il 13 giu 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Sterling pounds 300,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    F/H warehouse and offices (formerly beechams buildings) rowdell road western avenue north west middlesex title no ngl 75568.
    Persone aventi diritto
    • Guardian Assurance PLC
    Transazioni
    • 13 giu 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 13 giu 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 10 mar 1988
    Consegnato il 14 mar 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Sterling pounds 1,800,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed.
    Brevi particolari
    F/H warehouse & offices (formerly beechams building) rowdell road, western ave northolt, middlesex ngl 75568.
    Persone aventi diritto
    • Guardian Assurance PLC
    Transazioni
    • 14 mar 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 13 giu 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee debenture
    Creato il 31 gen 1986
    Consegnato il 11 feb 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 feb 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 11 ott 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 08 mar 1985
    Consegnato il 18 mar 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Please see doc M8. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 18 mar 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 11 ott 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    ADMINSTORE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    24 feb 2021Inizio della liquidazione
    25 gen 2022Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praticante
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praticante
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0