UNIQUEAIR LIMITED
Panoramica
| Nome della società | UNIQUEAIR LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01885392 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di UNIQUEAIR LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova UNIQUEAIR LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di UNIQUEAIR LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| UNIQUE-AIR LIMITED | 19 giu 1985 | 19 giu 1985 |
| SUMMITSENSE LIMITED | 12 feb 1985 | 12 feb 1985 |
Quali sono gli ultimi bilanci di UNIQUEAIR LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per UNIQUEAIR LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 3 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 2 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 07 mar 2018
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 feb 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 feb 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 feb 2016 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 feb 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Joanne Sarah Finch come amministratore in data 26 set 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 feb 2014 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2013 | 6 pagine | AA | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Nomina di Mr David Nigel Evans come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Martin Purkess come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 feb 2013 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Nomina di Diane Mcintyre come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di UNIQUEAIR LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VODAFONE CORPORATE SECRETARIES LIMITED | Segretario | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | 75473330004 | |||||||
| EVANS, David Nigel | Amministratore | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | British | 134975040001 | |||||
| MCINTYRE, Diane Josephine, Cfo | Amministratore | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | British | 173703620001 | |||||
| JEFFERSON, Karen | Segretario | 8 Bailey Close SN9 5HU Pewsey Wiltshire | British | 79393480001 | ||||||
| O'BRIEN, Robert Paul David | Segretario | Inglenook Lower Church Street Cuddington HP18 0AS Aylesbury Buckinghamshire | British | 48842660001 | ||||||
| RIMMER, Michael Douglas | Segretario | 32 Watling Lane Dorchester On Thames OX10 7JG Wallingford Oxfordshire | British | 48355360001 | ||||||
| SCOTT, Stephen Roy | Segretario | Bracken House Bunces Shaw Farley Hill RG7 1UU Reading Berkshire | British | 25660590003 | ||||||
| ALLEN, Christian Philip Quentin | Amministratore | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | British | 123612980001 | ||||||
| BREWER, Stephen | Amministratore | Flat 10 Rushworth House Enborne Lodge Lane RG14 6RH Newbury Berkshire | British | 79186090002 | ||||||
| BROCKLEHURST, Nigel | Amministratore | 1 The Hollyhocks Reading Road, Harwell OX11 0LX Didcot Oxfordshire | British | 83126790001 | ||||||
| CHESWORTH, Paul | Amministratore | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | British | 99525280001 | ||||||
| COLLINS, Richard Alexander | Amministratore | Park House Lower End OX18 2QA Alvescot Oxfordshire | England | British | 243854360001 | |||||
| CREEDY, Peter Kevin | Amministratore | Pine Ridge Hollow Longdown Road, Lower Bourne GU10 3JT Farnham Surrey | United Kingdom | British | 61327890003 | |||||
| EDWARDS, Peter David | Amministratore | Hockets Oriental Road SL5 7AZ Sunninghill Berkshire | British | 1908570001 | ||||||
| EMBLETON, David Paul | Amministratore | 15 Cabot Drive Grange Park SN5 6HG Swindon Wiltshire | British | 39876670001 | ||||||
| EVANS, Mark | Amministratore | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | British | 127017870001 | ||||||
| FINCH, Joanne Sarah | Amministratore | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | British | 158146620001 | |||||
| HALFORD, Andrew Nigel | Amministratore | The Oxdrove House Burghclere RG20 9HJ Newbury Berkshire | British | 33951180005 | ||||||
| HANFORD, Raymond Clifford | Amministratore | Romney Cottage Park Horsley East Horsley KT24 5RZ Leatherhead Surrey | United Kingdom | British | 45868080001 | |||||
| HEMSWORTH, Francis | Amministratore | Goldthorn House Witney Road OX29 8HQ Freeland Oxon | United Kingdom | British | 90628710001 | |||||
| JONES, David Leslie | Amministratore | Three Oak Barn RH14 0PY Plaistow West Sussex | British | 83517310001 | ||||||
| KEATING, Desmond Patrick | Amministratore | Radley Cottage Southside OX5 3RT Steeple Aston Oxfordshire | British | 26675420001 | ||||||
| LANGSTON, Edward | Amministratore | 23 Manilla Road Clifton BS8 4EB Bristol Avon | Uk | British | 24471140001 | |||||
| LEE, Simon Christopher | Amministratore | Moorlands Harrow Road West RH4 3BH Dorking Surrey | United Kingdom | British | 86697870001 | |||||
| LEES, Robert James | Amministratore | 6 Old Nursery View Kennington OX1 5NT Oxford | British | 19687660002 | ||||||
| LEIGH, Michael Phillip | Amministratore | 1 Glendale Avenue HA8 8HF Edgware Middlesex | England | British | 57207070001 | |||||
| MOURGUE, Anthony John | Amministratore | 115 Coleherne Court Old Brompton Road SW5 0EB London | British | 17182830001 | ||||||
| NEILL, John Mitchell | Amministratore | Baddiant Alleyns Lane SL6 9AE Cookham Dean Berkshire | England | British | 27195420006 | |||||
| NOWAK, Thomas, Dr | Amministratore | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | German | 174443800001 | |||||
| PURKESS, Martin John | Amministratore | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | England | British | 139360020001 | |||||
| READ, Nicholas Jonathan | Amministratore | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | British | 87149560001 | |||||
| ROWLEY, Nicholas James | Amministratore | 22 Charlton Avenue KT12 5LE Walton On Thames Surrey | British | 32188470002 | ||||||
| RYDING, Peter John | Amministratore | Cuddy Thorne Cow Pool Berrick Salome OX10 6JJ Wallingford Oxfordshire | United Kingdom | British | 95144000001 | |||||
| SCHÄFER, Richard Wolfgang Henry | Amministratore | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 158146600001 | |||||
| SMITH, Andrew Paul | Amministratore | Little Park Hill White Hill Lane, Bletchingley RH1 4QY Redhill Surrey | British | 33025470005 |
Chi sono le persone con controllo significativo di UNIQUEAIR LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone Distribution Holdings Limited | 06 apr 2016 | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
UNIQUEAIR LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Floating charge and guarantee | Creato il 30 apr 1999 Consegnato il 10 mag 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due on any account whatsoever from each obligor (as defined) to any transaction party under each transaction document to which such obligor is a party | |
Brevi particolari A floating charge over all assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 18 dic 1998 Consegnato il 02 gen 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease dated 16TH february 1995 | |
Brevi particolari The sum of £20,000 in an interest earning account. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 22 gen 1998 Consegnato il 24 gen 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the provisions of a lease dated 14TH july 1995 | |
Brevi particolari The initial rent deposit of £44,062.50 together with accrued net interest thereon. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of guarantee & charge | Creato il 08 gen 1987 Consegnato il 14 gen 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to barclays de zoete wedd limited as trustee pursuant to the facility agreement dated 8/1/87 or the deed or any overdraft letter as depfined | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital (see for dated 8/1/87 for full details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0