TALKLAND COMMUNICATIONS LIMITED

TALKLAND COMMUNICATIONS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTALKLAND COMMUNICATIONS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01886147
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TALKLAND COMMUNICATIONS LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova TALKLAND COMMUNICATIONS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TALKLAND COMMUNICATIONS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    EUROPA COMMUNICATIONS LIMITED19 lug 198519 lug 1985
    EUROPA SECURITIES LIMITED12 mar 198512 mar 1985
    UNITING LIMITED14 feb 198514 feb 1985

    Quali sono gli ultimi bilanci di TALKLAND COMMUNICATIONS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per TALKLAND COMMUNICATIONS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 06 giu 2019

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Nomina di Mr Andrew Michael Yorston come amministratore in data 02 apr 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Diane Josephine Mcintyre come amministratore in data 16 mar 2019

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 feb 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2018

    5 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 14 in pieno

    1 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 feb 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 feb 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 15 feb 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 mar 2016

    Stato del capitale al 15 mar 2016

    • Capitale: GBP 100,102
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 15 feb 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 mar 2015

    Stato del capitale al 27 mar 2015

    • Capitale: GBP 100,102
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014

    5 pagineAA

    Cessazione della carica di Joanne Sarah Finch come amministratore in data 26 set 2014

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 15 feb 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 mar 2014

    Stato del capitale al 14 mar 2014

    • Capitale: GBP 100,102
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2013

    6 pagineAA

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 5Th Floor One Kingdom Street Paddington Central London W2 6BY United Kingdom

    1 pagineAD02

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    Chi sono gli amministratori di TALKLAND COMMUNICATIONS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    VODAFONE CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Segretario
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione2357692
    75473330004
    EVANS, David Nigel
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish134975040001
    YORSTON, Andrew Michael
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish257275320001
    GASPER, Suzanne Lynette Philomena
    118 Harrowdene Gardens
    TW11 0DL Teddington
    Middlesex
    Segretario
    118 Harrowdene Gardens
    TW11 0DL Teddington
    Middlesex
    British49781290001
    HOWIE, Philip Robert Sutherland
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Segretario
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British77939460004
    LAVER, John Michael
    Brook House Homestead Road
    TN8 6JD Edenbridge
    Kent
    Segretario
    Brook House Homestead Road
    TN8 6JD Edenbridge
    Kent
    British8207040001
    SCOTT, Stephen Roy
    Bracken House
    Bunces Shaw Farley Hill
    RG7 1UU Reading
    Berkshire
    Segretario
    Bracken House
    Bunces Shaw Farley Hill
    RG7 1UU Reading
    Berkshire
    British25660590003
    WRIGHT, Garth Howard
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Segretario
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British111162790001
    ALLEN, Christian Philip Quentin
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British123612980001
    BREWER, Stephen
    Flat 10 Rushworth House
    Enborne Lodge Lane
    RG14 6RH Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Flat 10 Rushworth House
    Enborne Lodge Lane
    RG14 6RH Newbury
    Berkshire
    British79186090002
    BROCKLEHURST, Nigel
    1 The Hollyhocks
    Reading Road, Harwell
    OX11 0LX Didcot
    Oxfordshire
    Amministratore
    1 The Hollyhocks
    Reading Road, Harwell
    OX11 0LX Didcot
    Oxfordshire
    British83126790001
    BRUNAIS, Alain
    47 Chemin De L'Ariel
    Louveciennes 78430
    France
    Amministratore
    47 Chemin De L'Ariel
    Louveciennes 78430
    France
    French34216290001
    CHESWORTH, Paul
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British99525280001
    EDWARDS, Peter David
    Hockets
    Oriental Road
    SL5 7AZ Sunninghill
    Berkshire
    Amministratore
    Hockets
    Oriental Road
    SL5 7AZ Sunninghill
    Berkshire
    British1908570001
    EVANS, Mark
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British127017870001
    FINCH, Joanne Sarah
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish158146620001
    FREEMAN, William Ian Bede
    Herons Cottage
    Ferry Lane, Medmenham
    SL7 2EZ Marlow
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Herons Cottage
    Ferry Lane, Medmenham
    SL7 2EZ Marlow
    Buckinghamshire
    EnglandBritish64442870001
    GRAY, Ian
    61 Bathurst Mews
    W2 2SB London
    Amministratore
    61 Bathurst Mews
    W2 2SB London
    United KingdomBritish50246030004
    HALFORD, Andrew Nigel
    The Oxdrove House
    Burghclere
    RG20 9HJ Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    The Oxdrove House
    Burghclere
    RG20 9HJ Newbury
    Berkshire
    British33951180005
    KEAYS, Helen Margaret
    Clematis Cottage
    Old Warwick Road Rowington
    CV35 7AA Warwick
    Warwickshire
    Amministratore
    Clematis Cottage
    Old Warwick Road Rowington
    CV35 7AA Warwick
    Warwickshire
    British55393460002
    KEY, Matthew David
    Yardley School Lane
    Seer Green
    HP9 2QJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Yardley School Lane
    Seer Green
    HP9 2QJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British62981720001
    LANGSTON, Edward
    23 Manilla Road
    Clifton
    BS8 4EB Bristol
    Avon
    Amministratore
    23 Manilla Road
    Clifton
    BS8 4EB Bristol
    Avon
    UkBritish24471140001
    LANGSTON, Edward
    23 Manilla Road
    Clifton
    BS8 4EB Bristol
    Avon
    Amministratore
    23 Manilla Road
    Clifton
    BS8 4EB Bristol
    Avon
    UkBritish24471140001
    LEE, Simon Christopher
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    Amministratore
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    United KingdomBritish86697870001
    MCINTYRE, Diane Josephine, Cfo
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish173703620001
    NOWAK, Thomas, Dr
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomGerman174443800001
    PURKESS, Martin John
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    EnglandBritish139360020001
    READ, Nicholas Jonathan
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish87149560001
    SCHÄFER, Richard Wolfgang Henry
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish158146600001
    SHERWOOD, Timothy Robin
    Berry Oaks
    12 Woodlands Avenue
    RG41 3HL Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    Berry Oaks
    12 Woodlands Avenue
    RG41 3HL Wokingham
    Berkshire
    United KingdomBritish104309090001
    TOURNON, Emanuele
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomItalian103542080002
    TOWNSEND, John Raymond
    Knowle House
    Chapel Corner Hamstead Marshall
    RG20 0HP Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Knowle House
    Chapel Corner Hamstead Marshall
    RG20 0HP Newbury
    Berkshire
    British95223480001
    WATSON, Ian
    School House
    Oakley Park Frilford Heath
    OX13 6QW Abingdon
    Oxfordshire
    Amministratore
    School House
    Oakley Park Frilford Heath
    OX13 6QW Abingdon
    Oxfordshire
    United KingdomBritish117671590001
    WEBB, Denys William
    Oakfield Stud
    Whitemoor Lane, Upper Basildon
    RG8 8SF Reading
    Berkshire
    Amministratore
    Oakfield Stud
    Whitemoor Lane, Upper Basildon
    RG8 8SF Reading
    Berkshire
    United KingdomBritish76074580001
    WHITTLE, John Richard
    54 Stirling Road
    BH3 7JH Bournemouth
    Dorset
    Amministratore
    54 Stirling Road
    BH3 7JH Bournemouth
    Dorset
    British69660920001

    Chi sono le persone con controllo significativo di TALKLAND COMMUNICATIONS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    06 apr 2016
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleUnited Kingdom (England)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione1759785
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    TALKLAND COMMUNICATIONS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of charge
    Creato il 12 set 1994
    Consegnato il 29 set 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the charge
    Brevi particolari
    Fixed charge all intellectual property and goodwill of the company present and future all book debts and other debts. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Vodafone Limited
    Transazioni
    • 29 set 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 nov 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 21 apr 1994
    Consegnato il 10 mag 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 10 mag 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 gen 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 20 apr 1989
    Consegnato il 09 mag 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to an agreement dated 19/4/89
    Brevi particolari
    All rights title and interest of the company (see form 395 for full details ref M570C).
    Persone aventi diritto
    • Quantum Leasing Limited.
    Transazioni
    • 09 mag 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 03 dic 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 03 mar 1988
    Consegnato il 17 mar 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Stocks shares & other securities all monies due to the company lent by it under the facility monies advanced by the charges.. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Gamlestaden Limited.
    Transazioni
    • 17 mar 1988Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 19 nov 1987
    Consegnato il 20 nov 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (See form M395 for full details). Undertaking and all property and assets.
    Persone aventi diritto
    • Gotabanken
    Transazioni
    • 20 nov 1987Registrazione di un'ipoteca
    Letter of absolute assignment
    Creato il 17 feb 1987
    Consegnato il 19 feb 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from europa leasing limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    All right, title, benefit and interest present and future in all monies whatsoever due or owing to the company under or by virtue of the lease agreements detailed on the form 395 relevant to this charge.
    Persone aventi diritto
    • Gota (UK) Limited
    Transazioni
    • 19 feb 1987Registrazione di un'ipoteca
    Letter of absolute assignment
    Creato il 19 nov 1986
    Consegnato il 21 nov 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from europa leasing limited to the charge on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    All right title benefit and interest present and future in all monies whatsoever due or owing to the company under by virtue of the lease agreements detailed on the form 395 relevant to this charge.
    Persone aventi diritto
    • Gota (UK) Limited
    Transazioni
    • 21 nov 1986Registrazione di un'ipoteca
    Letter of absolute assignment
    Creato il 13 ott 1986
    Consegnato il 15 ott 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to an agreement dated 7/2/86
    Brevi particolari
    All right, title, benefit and interest present and future in all monies whatsoever due or owing to the company under or by virtue of the lease agreements detailed on the form 395 relevant to this charge.
    Persone aventi diritto
    • Gota (UK) Limited.
    Transazioni
    • 15 ott 1986Registrazione di un'ipoteca
    Letter of absolute assignment
    Creato il 16 set 1986
    Consegnato il 19 set 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from europa leasing limited to the chargee pursuant to an agreement dated 7.2.86.
    Brevi particolari
    All right title benefit & interest of the company, both present and future in the lease specified on form M395.
    Persone aventi diritto
    • Gota (UK) Limited
    Transazioni
    • 19 set 1986Registrazione di un'ipoteca
    Letter of absolute assignment
    Creato il 15 ago 1986
    Consegnato il 21 ago 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to an agreement dated 7/2/86.
    Brevi particolari
    All right title benefit & interest of the company, both present and future in the lease specified on form M395.
    Persone aventi diritto
    • Gota (UK) Limited
    Transazioni
    • 21 ago 1986Registrazione di un'ipoteca
    Letter of absolute assignment
    Creato il 17 lug 1986
    Consegnato il 21 lug 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from europa leasing limited pursuant to an agreement dated 7/2/86 and master assignment agreement dated 13/2/86.
    Brevi particolari
    All right title benefit and interest of the company, present and future in the leases specified (see doc M27 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Gota (UK) Limited
    Transazioni
    • 21 lug 1986Registrazione di un'ipoteca
    Letter containing and absolute assignment
    Creato il 22 apr 1986
    Consegnato il 24 apr 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to an agreement dated 7/2/86.
    Brevi particolari
    All the right, title, benefit & interest of the company in and to all moneys owing to the company under the lease agreements as detailed in doc M26. (See doc M26 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Gota (UK) Limited
    Transazioni
    • 24 apr 1986Registrazione di un'ipoteca
    Letter
    Creato il 25 mar 1986
    Consegnato il 02 apr 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the right, title, benefit & interest of the company in and to all moneys owing to the company under the lease agreements as detailed on doc M25 (see doc M25 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Gota (UK) Limited
    Transazioni
    • 02 apr 1986Registrazione di un'ipoteca
    Master assignment agreement
    Creato il 13 feb 1986
    Consegnato il 03 mar 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the europa leasing limited under the terms of a facility agreement dated 7/2/86 to the chargee
    Brevi particolari
    By way of assignment all right title benefit and interest whatsoever under or by virtue of certain lease agreements lease purchase agreements and subscriber/lease agreements with all amounts standing to the credit of account no 30208312 with clydesdale bank PLC see doc M24 for full details.
    Persone aventi diritto
    • Gota (UK) Limited
    Transazioni
    • 03 mar 1986Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0