CELEBRUS TECHNOLOGIES PLC
Panoramica
| Nome della società | CELEBRUS TECHNOLOGIES PLC |
|---|---|
| Stato della società | Attiva |
| Forma giuridica | Società per azioni |
| Numero di società | 01892751 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CELEBRUS TECHNOLOGIES PLC?
- Altre attività di servizi nel campo delle tecnologie dell'informazione (62090) / Informazione e comunicazione
Dove si trova CELEBRUS TECHNOLOGIES PLC?
| Indirizzo della sede legale | Elmbrook House 18-19 Station Road TW16 6SB Sunbury-On-Thames England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CELEBRUS TECHNOLOGIES PLC?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| D4T4 SOLUTIONS PLC | 20 lug 2016 | 20 lug 2016 |
| I S SOLUTIONS PLC | 08 ago 1991 | 08 ago 1991 |
| INDUSTRIAL SYSTEMS SOLUTIONS LIMITED | 24 lug 1985 | 24 lug 1985 |
| BRIGHTBAY LIMITED | 06 mar 1985 | 06 mar 1985 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CELEBRUS TECHNOLOGIES PLC?
| Scaduto | No |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 31 mar 2026 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 set 2026 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2025 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per CELEBRUS TECHNOLOGIES PLC?
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 20 lug 2026 |
|---|---|
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 03 ago 2026 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 20 lug 2025 |
| Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per CELEBRUS TECHNOLOGIES PLC?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2025 | 111 pagine | AA | ||||||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 lug 2025 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||||||
Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2024 | 98 pagine | AA | ||||||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 lug 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 018927510007, creata il 24 mag 2024 | 16 pagine | MR01 | ||||||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Guerino Luigi Bruno, Iii il 02 apr 2024 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Guerino Luigi Bruno, Iii il 02 apr 2024 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Windmill House 91-93 Windmill Road Sunbury upon Thame Middlesex TW16 7EF a Elmbrook House 18-19 Station Road Sunbury-on-Thames TW16 6SB in data 02 apr 2024 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||||||
Cessazione della carica di Peter Anthony Simmonds come amministratore in data 31 mar 2024 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 018927510006, creata il 06 feb 2024 | 17 pagine | MR01 | ||||||||||||||||||
Nomina di Mr Thomas Kevin Skelton Jr come amministratore in data 15 dic 2023 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed D4T4 solutions PLC\certificate issued on 15/11/23 | 2 pagine | CERTNM | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Avviso di cambio di nome" | 2 pagine | CONNOT | ||||||||||||||||||
Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2023 | 101 pagine | AA | ||||||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 lug 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||||||
Nomina di Mrs Helen Patricia Gilder come amministratore in data 24 apr 2023 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||||||
Acquisto di azioni proprie. Azioni acquistate per la tesoreria:
| 4 pagine | SH03 | ||||||||||||||||||
Vendita o cessione di azioni di tesoreria. Capitale di tesoreria:
| 2 pagine | SH04 | ||||||||||||||||||
Acquisto di azioni proprie. Azioni acquistate per la tesoreria:
| 4 pagine | SH03 | ||||||||||||||||||
Acquisto di azioni proprie. Azioni acquistate per la tesoreria:
| 4 pagine | SH03 | ||||||||||||||||||
Acquisto di azioni proprie. Azioni acquistate per la tesoreria:
| 4 pagine | SH03 | ||||||||||||||||||
Vendita o cessione di azioni di tesoreria. Capitale di tesoreria:
| 2 pagine | SH04 | ||||||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di CELEBRUS TECHNOLOGIES PLC?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THORNE, James Henry | Segretario | 18-19 Station Road TW16 6SB Sunbury-On-Thames Elmbrook House England | 236096000001 | |||||||
| BIDDULPH, Monika, Dr | Amministratore | 18-19 Station Road TW16 6SB Sunbury-On-Thames Elmbrook House England | England | British | 189772790001 | |||||
| BRUNO, III, Guerino Luigi | Amministratore | 18-19 Station Road TW16 6SB Sunbury-On-Thames Elmbrook House England | United States | American | 286684320001 | |||||
| GILDER, Helen Patricia | Amministratore | 18-19 Station Road TW16 6SB Sunbury-On-Thames Elmbrook House England | England | British | 115851920001 | |||||
| MEHTA, Ashoni Kumar | Amministratore | 18-19 Station Road TW16 6SB Sunbury-On-Thames Elmbrook House England | England | British | 66703220002 | |||||
| SKELTON JR, Thomas Kevin | Amministratore | 18-19 Station Road TW16 6SB Sunbury-On-Thames Elmbrook House England | United States | American | 317222830001 | |||||
| WHITING, Peter Frederick | Amministratore | 18-19 Station Road TW16 6SB Sunbury-On-Thames Elmbrook House England | England | British | 166528660001 | |||||
| TINLING, Michael Leigh Scott | Segretario | Windmill House 91-93 Windmill Road Sunbury Upon Thame TW16 7EF Middlesex | British | 7913200002 | ||||||
| BOXALL, Mark Geoffrey | Amministratore | Windmill House 91-93 Windmill Road Sunbury Upon Thame TW16 7EF Middlesex | England | British | 140363260002 | |||||
| CLARK, Barrie Anderson | Amministratore | The Westwards Bradda Road IM9 6QA Port Erin Isle Of Man | Isle Of Man | British | 43076990002 | |||||
| DE SMITH, Michael John | Amministratore | 3 Garlinge Road Southborough TN4 0NR Tunbridge Wells Kent | British | 12924050001 | ||||||
| DODKINS, James Lloyd | Amministratore | Ilchester Cottage Church Road Farley SP5 1AA Salisbury Wiltshire | United Kingdom | British | 195901690001 | |||||
| ENGLISH, Peter David | Amministratore | Coombe Lane West KT2 7BX Kingston Upon Thames 10 Surrey | England | British | 3355360003 | |||||
| IRVINE, Charles Campbell | Amministratore | Windmill House 91-93 Windmill Road Sunbury Upon Thame TW16 7EF Middlesex | England | British | 265958850001 | |||||
| KEAR, Peter John | Amministratore | La Bergerie 9 Rue De La Mairie, St Martin De Juilers 17400 Charente Maritime France | France | British | 46085840006 | |||||
| LYTHALL, John | Amministratore | The Wisley 3 Hatchford Manor, Ockham Lane KT11 1LH Cobham Surrey | United Kingdom | British | 15080690003 | |||||
| MCDOWELL, Roger Steven | Amministratore | Carnworth Lodge 295 Ashley Road Hale WA14 3NH Altrincham Cheshire | England | British | 32998460005 | |||||
| SHINGLES, Godfrey Stephen | Amministratore | Windmill House 91-93 Windmill Road Sunbury Upon Thame TW16 7EF Middlesex | England | British | 12171340002 | |||||
| SIMMONDS, Peter Anthony | Amministratore | Windmill House 91-93 Windmill Road Sunbury Upon Thame TW16 7EF Middlesex | United Kingdom | British | 174909800001 | |||||
| SIMONS, Robert John Christopher | Amministratore | Villa D'Este Wokingham Road RG10 0RU Hurst Berkshire | British | 38848920001 | ||||||
| TINLING, Michael Leigh Scott | Amministratore | Thirby Horseshoe Lane Ash Vale GU12 5LJ Aldershot Hampshire | England | British | 7913200002 | |||||
| TOD, Mathew | Amministratore | Windmill House 91-93 Windmill Road Sunbury Upon Thame TW16 7EF Middlesex | United Kingdom | British | 223394980001 | |||||
| WARREN, Carmel Elizabeth | Amministratore | Windmill House 91-93 Windmill Road Sunbury Upon Thame TW16 7EF Middlesex | England | British | 80553580001 | |||||
| WEST, Jonathan Charles | Amministratore | 10 Borelli Mews GU9 7YZ Farnham Surrey | British | 16338070002 | ||||||
| VENTURE CAPITAL FUNDING LTD | Amministratore | 7 Tower Walk St Katharines Way E1 9UR London | 2962550002 |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0