CREST PACKAGING LIMITED

CREST PACKAGING LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCREST PACKAGING LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01896204
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CREST PACKAGING LIMITED?

    • (7415) /

    Dove si trova CREST PACKAGING LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    8 Baker Street
    London
    W1U 3LL
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CREST PACKAGING LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ELDONGRANT LIMITED18 mar 198518 mar 1985

    Quali sono gli ultimi bilanci di CREST PACKAGING LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al

    Quali sono le ultime deposizioni per CREST PACKAGING LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di conto finale prima della dissoluzione

    1 pagine4.43

    Nomina di un liquidatore

    1 pagine4.31

    Notifica di revoca dell'ordinanza di amministrazione

    4 pagine2.19

    Ordine del tribunale di liquidazione

    3 pagineCOCOMP

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore

    2 pagine2.15

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore

    2 pagine2.15

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore

    2 pagine2.15

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore

    2 pagine2.15

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore

    3 pagine2.15

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore

    3 pagine2.15

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore

    3 pagine2.15

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore

    3 pagine2.15

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore

    3 pagine2.15

    legacy

    2 pagine403b

    Notifica del risultato della riunione dei creditori

    3 pagine2.23

    Relazione sulle proposte dell'amministratore

    37 pagine2.21

    legacy

    1 pagine287

    Ordinanza di amministrazione

    4 pagine2.7

    Notifica dell'ordinanza di amministrazione

    1 pagine2.6

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    7 pagine363s

    legacy

    5 pagine395

    legacy

    1 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di CREST PACKAGING LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ROBINSON, David Thomas
    59 Lancaster Drive
    RH19 3XJ East Grinstead
    West Sussex
    Segretario
    59 Lancaster Drive
    RH19 3XJ East Grinstead
    West Sussex
    British60804830003
    BULLIVANT, Philip
    11 Rivermead
    St Marys Island
    ME4 3JR Chatham
    Kent
    Amministratore
    11 Rivermead
    St Marys Island
    ME4 3JR Chatham
    Kent
    British80893940001
    WEBB, Rodney Anson John
    Angley House Angley Park
    TN17 2PN Cranbrook
    Kent
    Amministratore
    Angley House Angley Park
    TN17 2PN Cranbrook
    Kent
    British2444280002
    BRANCH, Donald Matthew
    79 Chaffes Lane
    ME9 7BG Upchurch
    Kent
    Segretario
    79 Chaffes Lane
    ME9 7BG Upchurch
    Kent
    British44453330001
    KENNY, Edward Michael
    Boo House West Heath
    Limpsfield Common
    RH8 0QS Oxted
    Surrey
    Segretario
    Boo House West Heath
    Limpsfield Common
    RH8 0QS Oxted
    Surrey
    Irish47290840001
    LAWTON, Christopher Erskine
    22 Church Fields
    ME19 6RJ West Malling
    Kent
    Segretario
    22 Church Fields
    ME19 6RJ West Malling
    Kent
    British44540640001
    SUGDEN, Martin Leslie
    23 Station Road
    WD7 8JY Radlett
    Hertfordshire
    Segretario
    23 Station Road
    WD7 8JY Radlett
    Hertfordshire
    British63057200001
    WEBB, Rodney Anson John
    Angley House Angley Park
    TN17 2PN Cranbrook
    Kent
    Segretario
    Angley House Angley Park
    TN17 2PN Cranbrook
    Kent
    British2444280002
    WEBB, Rodney Anson John
    Spitzbrook House
    Collier Street
    TN12 9RH Tonbridge
    Kent
    Segretario
    Spitzbrook House
    Collier Street
    TN12 9RH Tonbridge
    Kent
    British2444280001
    BOWEN, Bertram Joseph
    1 The Birches
    Iffin Lane
    CT4 7BD Canterbury
    Kent
    Amministratore
    1 The Birches
    Iffin Lane
    CT4 7BD Canterbury
    Kent
    British28964390001
    COOK, Roy Joseph
    The Cottage
    The Street, Hartlip
    ME9 7TL Sittingbourne
    Kent
    Amministratore
    The Cottage
    The Street, Hartlip
    ME9 7TL Sittingbourne
    Kent
    British20121740002
    HARMAN, Albert George
    Valley View
    Primrose Lane South Street
    ME9 7QP Stockbury Sittingbourne
    Kent
    Amministratore
    Valley View
    Primrose Lane South Street
    ME9 7QP Stockbury Sittingbourne
    Kent
    British5418190002
    KENNY, Edward Michael
    Boo House West Heath
    Limpsfield Common
    RH8 0QS Oxted
    Surrey
    Amministratore
    Boo House West Heath
    Limpsfield Common
    RH8 0QS Oxted
    Surrey
    EnglandIrish47290840001
    LAWTON, Christopher Erskine
    22 Church Fields
    ME19 6RJ West Malling
    Kent
    Amministratore
    22 Church Fields
    ME19 6RJ West Malling
    Kent
    British44540640001
    POULTER, John William
    28 Sydney Road
    TW9 1UB Richmond
    Surrey
    Amministratore
    28 Sydney Road
    TW9 1UB Richmond
    Surrey
    British4333730002
    STEWART, Ian
    Ross Cottage Common Lane
    Hemmingford Abbots
    PE18 9AN Huntingdon
    Cambridgeshire
    Amministratore
    Ross Cottage Common Lane
    Hemmingford Abbots
    PE18 9AN Huntingdon
    Cambridgeshire
    British37746850001
    SUGDEN, Martin Leslie
    23 Station Road
    WD7 8JY Radlett
    Hertfordshire
    Amministratore
    23 Station Road
    WD7 8JY Radlett
    Hertfordshire
    British63057200001
    TEGNER, Ian Nicol
    44 Norland Square
    W11 4PZ London
    Amministratore
    44 Norland Square
    W11 4PZ London
    United KingdomBritish14223250001
    WEBB, Angela Delys
    Spitzbrook Lodge
    Collier Street
    TN12 9RH Tonbridge
    Kent
    Amministratore
    Spitzbrook Lodge
    Collier Street
    TN12 9RH Tonbridge
    Kent
    British20121730001

    CREST PACKAGING LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Creato il 30 mag 2002
    Consegnato il 12 giu 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All such rights to the repayment of the deposit meaning the debt(s) on the account(s) described in the schedule being the account with the bank denominated in sterling designated bus inv a/c and numbered 06226590 and any account(s) for the time being replacing the same and all interest owing in respect thereof and all deposits with the banks treasury division on the name of the bank re the company.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 12 giu 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 05 nov 2001
    Consegnato il 15 nov 2001
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Account number: barclays bank PLC re crest packaging limited, sor code: 20-54-11, account number: 30001430. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 05 nov 2001
    Consegnato il 15 nov 2001
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Account name: barclays bank PLC re crest packaging limited, sor code: 20-54-11, account number: 30001430. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    Guarantee and debenture
    Creato il 07 dic 1999
    Consegnato il 15 dic 1999
    In corso
    Importo garantito
    All monies and liabilities due or to become due from the company and any group company (as defined) to the chargee on any account whatsoever pursuant to clause 2.1 of the debenture
    Brevi particolari
    Land on the east side of hoath lane gillingham kent t/no: K101469 medway skill centre courtenay road gillingham kent t/no: K689661 and land and buildings on the south side of irthlingborough road wellingborough t/no: NN87085 .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Macash Limited
    Transazioni
    • 15 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 set 2003Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Legal charge
    Creato il 05 ago 1999
    Consegnato il 20 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Medway skill centre courteney road gillingham kent t/n K689861.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 dic 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 05 ago 1999
    Consegnato il 20 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 dic 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    First guarantee and debenture
    Creato il 01 dic 1998
    Consegnato il 15 dic 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 dic 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 apr 1997
    Consegnato il 10 mag 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land & buildings on the south side of irthlingborough road wellingborough northants.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 10 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 dic 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 15 dic 1992
    Consegnato il 29 dic 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    See doc ref M1027C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 29 dic 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 dic 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 02 apr 1992
    Consegnato il 10 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings to the east side of courteney road gillingham kent title no. K101469.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 10 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 dic 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 19 nov 1987
    Consegnato il 01 dic 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to barclays bank PLC under the terms of a loan facility letter dated 3/9/87.
    Brevi particolari
    Land & buildings on the east side of courteney road gillingham kent.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 01 dic 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 06 dic 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 10 mag 1985
    Consegnato il 30 mag 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at courteney road gillingham kent.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 30 mag 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 06 dic 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 10 mag 1985
    Consegnato il 30 mag 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at courteney road gillingham kent.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 30 mag 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 06 dic 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 10 mag 1985
    Consegnato il 21 mag 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or crest flexible packaging limited and/or crest cartons limited to the chargees under the terms of the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Mercantile Credit Company Limited
    • Barclays Mercantile Industrial Finance Limited
    • Mercantile Leasing Company Limited
    Transazioni
    • 21 mag 1985Registrazione di un'ipoteca
    Guarantee & debenture
    Creato il 10 mag 1985
    Consegnato il 17 mag 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 mag 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 06 dic 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 10 mag 1985
    Consegnato il 15 mag 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from the company and/or crest flexible packaging limited and/or crest cartons limited to the chargee under the terms of the agreement
    Brevi particolari
    A specific charge on uncalled capital f/hold and l/hold property buildings fixtures plant and machinery and book debts and a floating charge on undertaking and goodwill.
    Persone aventi diritto
    • Bowater Packaging LTD.
    Transazioni
    • 15 mag 1985Registrazione di un'ipoteca

    CREST PACKAGING LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    20 feb 2003Inizio dell'amministrazione
    09 ago 2007Amministrazione scaricata
    Ordine di amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Stanley Michaels
    Bdo Stoy Hayward
    8 Baker Street
    W1U 3LL London
    Praticante
    Bdo Stoy Hayward
    8 Baker Street
    W1U 3LL London
    Finbarr O'Connell
    Kpmg Corporate Recovery
    P O Box 695
    EC4Y 8BB 8 Salisbury Square
    London
    Praticante
    Kpmg Corporate Recovery
    P O Box 695
    EC4Y 8BB 8 Salisbury Square
    London
    2
    DataTipo
    18 feb 2010Conclusione della liquidazione
    25 giu 2007Data della petizione
    09 ago 2007Inizio della liquidazione
    24 mag 2010Data di scioglimento
    Liquidazione coatta
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Simon James Michaels
    Bdo Stoy Hayward
    8 Baker Street
    W1U 3LL London
    Praticante
    Bdo Stoy Hayward
    8 Baker Street
    W1U 3LL London
    Finbarr O'Connell
    Kpmg Corporate Recovery
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    Kpmg Corporate Recovery
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    The Official Receiver Or London
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    Praticante
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0