BARRON CONTROL PANELS LIMITED

BARRON CONTROL PANELS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBARRON CONTROL PANELS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01897219
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BARRON CONTROL PANELS LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova BARRON CONTROL PANELS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Glendevon House Hawthorn Park
    Coal Road
    LS14 1PQ Leeds
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BARRON CONTROL PANELS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MENDIP SWITCHGEAR LIMITED27 mag 198827 mag 1988
    MENDIP ENGINEERING SERVICES LIMITED20 mar 198520 mar 1985

    Quali sono gli ultimi bilanci di BARRON CONTROL PANELS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2008

    Quali sono le ultime deposizioni per BARRON CONTROL PANELS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    3 pagine4.71

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 14 dic 2009

    LRESSP

    Indirizzo della sede legale modificato da Yardley Court 11/12 Frederick Rd Edgbaston Birmingham West Midlands B15 1JD in data 23 dic 2009

    2 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 12 ott 2009 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital20 ott 2009

    Stato del capitale al 20 ott 2009

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Henri-Paul Laschkar il 16 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Neil Michael Croxson il 16 ott 2009

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    4 pagineAA

    legacy

    3 pagine288a

    legacy

    2 pagine288a

    Memorandum e Statuto

    10 pagineMA

    Risoluzioni

    Resolutions
    11 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    4 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    legacy

    2 pagine288a

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    4 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    Bilancio redatto al 31 dic 2005

    4 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di BARRON CONTROL PANELS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CROXSON, Neil Michael
    15 Kyle Way
    Nether Poppleton
    YO26 6RH York
    Amministratore
    15 Kyle Way
    Nether Poppleton
    YO26 6RH York
    UkBritish96469690002
    LASCHKAR, Henri-Paul
    23 Hyde Park Place
    W2 2LP London
    Flat 2
    Amministratore
    23 Hyde Park Place
    W2 2LP London
    Flat 2
    UkFrench139160640001
    CARTLIDGE, Gary John
    Hendre Loudwater Lane
    WD3 4AN Rickmansworth
    Hertfordshire
    Segretario
    Hendre Loudwater Lane
    WD3 4AN Rickmansworth
    Hertfordshire
    British11920020001
    CARTLIDGE, Gary John
    Hendre Loudwater Lane
    WD3 4AN Rickmansworth
    Hertfordshire
    Segretario
    Hendre Loudwater Lane
    WD3 4AN Rickmansworth
    Hertfordshire
    British11920020001
    EVETTS, John Graham
    72 Sycamore Avenue
    RM14 2HS Upminster
    Essex
    Segretario
    72 Sycamore Avenue
    RM14 2HS Upminster
    Essex
    Pollish/British56188860003
    JAMES, Simon Michael
    37 Brand Hill Drive
    Crofton
    WF4 1PF Wakefield
    Yorkshire
    Segretario
    37 Brand Hill Drive
    Crofton
    WF4 1PF Wakefield
    Yorkshire
    British111338120001
    JENKINSON, Roger Anthony
    Pollensa 3 Fledburgh Drive
    New Hall
    B76 1ED Sutton Coldfield
    West Midlands
    Segretario
    Pollensa 3 Fledburgh Drive
    New Hall
    B76 1ED Sutton Coldfield
    West Midlands
    British985860002
    SABIN, Douglas Harold
    8 Radcliffe Drive
    B62 8PJ Halesowen
    West Midlands
    Segretario
    8 Radcliffe Drive
    B62 8PJ Halesowen
    West Midlands
    British52697160001
    TALLIS, Aleksandra Jadwiga
    6 St Chads Grove
    LS6 3PN Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    6 St Chads Grove
    LS6 3PN Leeds
    West Yorkshire
    Polish34638000004
    TRIGGER, Roy
    48 Bartel Close
    Leverstock Green
    HP3 8LY Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Segretario
    48 Bartel Close
    Leverstock Green
    HP3 8LY Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    British11920010002
    CARTLIDGE, Gary John
    Hendre Loudwater Lane
    WD3 4AN Rickmansworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    Hendre Loudwater Lane
    WD3 4AN Rickmansworth
    Hertfordshire
    United KingdomBritish11920020001
    FORRESTER, Andrew John
    The Shieling
    70 Tiddington Road
    CV37 7BA Stratford Upon Avon
    Amministratore
    The Shieling
    70 Tiddington Road
    CV37 7BA Stratford Upon Avon
    United KingdomBritish97001960001
    LEE, Michael William George
    Forleas Hotley Bottom Lane
    Prestwood
    HP16 9PL Great Missenden
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Forleas Hotley Bottom Lane
    Prestwood
    HP16 9PL Great Missenden
    Buckinghamshire
    EnglandBritish14069700001
    LINGARD, George
    2 Hippisley Drive
    BS26 2DE Axbridge
    Somerset
    Amministratore
    2 Hippisley Drive
    BS26 2DE Axbridge
    Somerset
    British13818940001
    MC NAB, William Douglas
    57 Pelican Road
    Pamber Heath
    RG26 6EL Basingstoke
    Hampshire
    Amministratore
    57 Pelican Road
    Pamber Heath
    RG26 6EL Basingstoke
    Hampshire
    British23845420001
    MULLEN, Kenneth John
    Tonhil House
    Borrowby
    YO7 4QQ Thirsk
    North Yorkshire
    Amministratore
    Tonhil House
    Borrowby
    YO7 4QQ Thirsk
    North Yorkshire
    United KingdomScottish146642810001
    NICHOLS, Matt Ward, Mr.
    18 Sweetpool Lane
    Hagley
    DY8 2XH Stourbridge
    West Midlands
    Amministratore
    18 Sweetpool Lane
    Hagley
    DY8 2XH Stourbridge
    West Midlands
    EnglandBritish177829370001
    PASSMAN, Jonathan Richard
    Stonefield Close
    Wigston Park Walsgrave
    CV2 2PZ Coventry
    6
    Amministratore
    Stonefield Close
    Wigston Park Walsgrave
    CV2 2PZ Coventry
    6
    British122460330002
    WISHART, John Oliver
    14 Edwards Avenue
    South Ruislip
    HA4 6UZ Ruislip
    Middlesex
    Amministratore
    14 Edwards Avenue
    South Ruislip
    HA4 6UZ Ruislip
    Middlesex
    British12921240001

    BARRON CONTROL PANELS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 19 mar 1998
    Consegnato il 21 mar 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 21 mar 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 gen 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 14 apr 1992
    Consegnato il 25 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 25 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 gen 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 03 ott 1988
    Consegnato il 12 ott 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 ott 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 28 lug 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 11 lug 1986
    Consegnato il 23 lug 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge undertaking and all property and assets present and future including bookdebts uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 23 lug 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 28 lug 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    BARRON CONTROL PANELS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    14 dic 2009Inizio della liquidazione
    30 ott 2010Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Julian Pitts
    Glendevon House Hawthorn Park
    Coal Road
    LS14 1PQ Leeds
    Praticante
    Glendevon House Hawthorn Park
    Coal Road
    LS14 1PQ Leeds
    David Frederick Wilson
    Wilson Pitts
    Glendevon House
    LS14 1PQ Hawthorn Park
    Coal Road Leeds
    Praticante
    Wilson Pitts
    Glendevon House
    LS14 1PQ Hawthorn Park
    Coal Road Leeds

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0