SKI INVESTMENTS LIMITED

SKI INVESTMENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSKI INVESTMENTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01898047
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SKI INVESTMENTS LIMITED?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova SKI INVESTMENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di SKI INVESTMENTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per SKI INVESTMENTS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per SKI INVESTMENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    15 pagine4.71

    Indirizzo della sede legale modificato da 24 Bruton Place London W1J 6NE a 25 Farringdon Street London EC4A 4AB in data 29 giu 2015

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 23 dic 2014

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    10 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 13 ott 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 ott 2014

    Stato del capitale al 16 ott 2014

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01
    Note
    DataNota
    13 gen 2020Other The address of John Alexander Heller , former director of SKI INVESTMENTS LIMITED , was partially-suppressed on 13/01/2020 under section 1088 of the Companies Act 2006.

    Soddisfazione dell'onere 22 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 13 ott 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 ott 2013

    Stato del capitale al 17 ott 2013

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01
    Note
    DataNota
    13 gen 2020Other The address of John Alexander Heller , former director of SKI INVESTMENTS LIMITED , was partially-suppressed on 13/01/2020 under section 1088 of the Companies Act 2006.

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    12 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Company business 21/12/2012
    RES13

    Bilancio annuale redatto al 13 ott 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Note
    DataNota
    13 gen 2020Other The address of John Alexander Heller , former director of SKI INVESTMENTS LIMITED , was partially-suppressed on 13/01/2020 under section 1088 of the Companies Act 2006.

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Michael Aron Heller il 18 ott 2012

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    15 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da * Carlton House 22a St James's Square London SW1Y 4JH* in data 23 apr 2012

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 13 ott 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Note
    DataNota
    13 gen 2020Other The address of John Alexander Heller , former director of SKI INVESTMENTS LIMITED , was partially-suppressed on 13/01/2020 under section 1088 of the Companies Act 2006.

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    14 pagineAA

    Cessazione della carica di Michael Stevens come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Michael Stevens come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Ms Heather Anne Curtis come segretario

    1 pagineAP03

    Bilancio annuale redatto al 13 ott 2010 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Note
    DataNota
    13 gen 2020Other The address of John Alexander Heller , former director of SKI INVESTMENTS LIMITED , was partially-suppressed on 13/01/2020 under section 1088 of the Companies Act 2006.

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    13 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Amendment agreement 22/06/2010
    RES13

    Bilancio annuale redatto al 13 ott 2009 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Note
    DataNota
    13 gen 2020Other The address of John Alexander Heller , former director of SKI INVESTMENTS LIMITED , was partially-suppressed on 13/01/2020 under section 1088 of the Companies Act 2006.

    Chi sono gli amministratori di SKI INVESTMENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CURTIS, Heather Anne
    Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    25
    Segretario
    Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    25
    159674600001
    CORRY, Robert John
    Windlesham Mead
    Hatton Hill
    GU20 6AB Windlesham
    Surrey
    Amministratore
    Windlesham Mead
    Hatton Hill
    GU20 6AB Windlesham
    Surrey
    EnglandBritishChartered Accountant78731860001
    HELLER, John Alexander
    1 Clorane Gardens
    NW3 7PR London
    Amministratore
    1 Clorane Gardens
    NW3 7PR London
    United KingdomBritishDirector72581650001
    HELLER, Michael Aron, Sir
    Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    25
    Amministratore
    Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    25
    United KingdomBritishDirector44677700001
    GORDON, Ian Alfred
    Apartment 5
    12-18 Hill Street
    W1J 5NH London
    Segretario
    Apartment 5
    12-18 Hill Street
    W1J 5NH London
    British115651430001
    RATCLIFFE, Alan George
    74 Chancery Lane
    WC2A 1AD London
    Segretario
    74 Chancery Lane
    WC2A 1AD London
    British78329300001
    STEVENS, Michael Cecil
    31 Wallace Fields
    Ewell
    KT17 3AX Epsom
    Surrey
    Segretario
    31 Wallace Fields
    Ewell
    KT17 3AX Epsom
    Surrey
    British14672850001
    GORDON, Lorraine Denise
    326 Euro Towers
    Block 4 Euro Port Road
    FOREIGN Gibraltar
    Amministratore
    326 Euro Towers
    Block 4 Euro Port Road
    FOREIGN Gibraltar
    BritishCompany Director9892200002
    LENNARD, Sharon Gail
    15 Flood Street
    SW3 4PW London
    Amministratore
    15 Flood Street
    SW3 4PW London
    BritishCompany Director37034830002
    STEVENS, Michael Cecil
    31 Wallace Fields
    Ewell
    KT17 3AX Epsom
    Surrey
    Amministratore
    31 Wallace Fields
    Ewell
    KT17 3AX Epsom
    Surrey
    Great BritainBritishDirector14672850001

    SKI INVESTMENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 22 set 2006
    Consegnato il 26 set 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 26 set 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 set 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 26 set 2003
    Consegnato il 30 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Phelps cottage and gateway arcade, 355-357 upper street, islington t/n 238293. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 ott 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 12 set 2003
    Consegnato il 16 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The freehold property known as 35 silver street taunton street somerset title number ST158937. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) P.Lc.
    Transazioni
    • 16 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 12 set 2003
    Consegnato il 16 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The freehold property known as 33 silver street taunton somerset title number ST150618. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transazioni
    • 16 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment
    Creato il 05 dic 2000
    Consegnato il 18 dic 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and any company from time to time which is a holding company or subsidiary of the company and any subsidiary undertaking or associate of any such company ("group member") to the chargee as trustee for itself and the other lenders ("trustee") or the trustee, cgnu PLC any company which is or becomes a holding company of any such company of subsidiary or associate of any such company or holding company which lends or has lent to, or is at any time owed monies by, any group member ("lenders") or for or in respect of which any group member may be liable to the trustee or any lenders on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Assigned by way of charge all the rights titles benefits and interests of the company to all monies from time to time due owing or incurred to the company under the occupational lease/s in respect of:38-44 (even nos) middlesex street tower hamlets t/no.LN186341. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transazioni
    • 18 dic 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 giu 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of legal charge
    Creato il 05 dic 2000
    Consegnato il 18 dic 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and any company from time to time which is a holding company or subsidiary of the company and any subsidiary undertaking or associate of any such company ("group member") to the chargee as trustee for itself and the other lenders ("trustee") or the trustee, cgnu PLC any company which is or becomes a holding company of any such company of subsidiary or associate of any such company or holding company which lends or has lent to, or is at any time owed monies by, any group member ("lenders") or for or in respect of which any group member may be liable to the trustee or any lenders on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and buildings k/a 38-44 (even nos) middlesex street l/b of tower hamlets t/no.LN186341 together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenant's fixtures) and fitting thereon and all improvements and additions thereto and all easements rights and licences appurtenant thereto, all monies deposited with the trustee on the terms set out in schedule 6 to the deed, floating charge the whole of the property, assets, rights and revenues including the uncalled share capital (if any).
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transazioni
    • 18 dic 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 giu 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 05 dic 2000
    Consegnato il 16 dic 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Gateway arcade 355/356/357 upper street islington london t/no;-238293 all buildings fixtures (including trade fixtures), fixed plant and machinery from time to time thereon and all improvements and additions thereto all rental monies togethher with floating charge over undertaking all property and assets of the company not charged by way of fixed charge above.
    Persone aventi diritto
    • Arbuthnot Latham & Co. Limited
    Transazioni
    • 16 dic 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 nov 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge and floating charge
    Creato il 01 ago 1996
    Consegnato il 10 ago 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that f/h property k/a 38-44 middlesex street london E1 t/n LN186341 with all buildings fixtures fixed plant and machinery the gross rents and licences fees and by way of floating charge all undertaking property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Arbuthnot Latham & Co Limited
    Transazioni
    • 10 ago 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge and floating charge
    Creato il 01 ago 1996
    Consegnato il 10 ago 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a former public library corporation street taunton somerset including trade fixtures fixed plant and machinery with all gross rents and licence fees and by way of floating charge all undetaking property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Arbuthnot Latham & Co Limited
    Transazioni
    • 10 ago 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 10 nov 1994
    Consegnato il 29 nov 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the legal mortgage
    Brevi particolari
    F/H-400 and 402 coldharbour lane brixton t/n-tgl 46674 and assigns the goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Banks, P.L.C.
    • Aib Finance Limited
    Transazioni
    • 29 nov 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Collateral charge
    Creato il 31 mar 1993
    Consegnato il 15 apr 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £252,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a legal charge dated 22 february 1990
    Brevi particolari
    355,356 and 357 upper street islington. T/n-238293.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transazioni
    • 15 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over deposits
    Creato il 15 gen 1991
    Consegnato il 19 gen 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    The sum of £22 deposited or to be depositetd by the company in the companys account no. 86898/02.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Banks P.L.C.
    Transazioni
    • 19 gen 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 14 giu 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 feb 1990
    Consegnato il 27 feb 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £188,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee.
    Brevi particolari
    L/H unit 6 chieftain business park, wellingborough, northamptonshire.
    Persone aventi diritto
    • Commercial Union Life Assurance Company LTD
    Transazioni
    • 27 feb 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 30 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 22 feb 1990
    Consegnato il 14 mar 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £252,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge.
    Brevi particolari
    Underleasehold premises at 18 and 19 cronin courtyard,corby,northamptonshire.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Fire Insurance Society Limited
    Transazioni
    • 14 mar 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 19 ago 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 17 nov 1989
    Consegnato il 22 nov 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    31 carlton crescent southampton hampshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Banks. PLC.
    Transazioni
    • 22 nov 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 30 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 17 nov 1989
    Consegnato il 21 nov 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £461,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee, under the terms of the charge
    Brevi particolari
    F/H - 31 carlton crescent, southampton hampshire title no hp 195851.
    Persone aventi diritto
    • The Norwich Union Life Insurance Society
    Transazioni
    • 21 nov 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 30 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 giu 1989
    Consegnato il 20 giu 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Piece or parcel of land k/a units 18/19 cronin courtyard weldon south industrial estate corby northants. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Riggs a P Bank Limited
    Transazioni
    • 20 giu 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 30 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 mar 1989
    Consegnato il 03 apr 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 31 carlton crescent southampton hampshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Riggs a P Bank
    Transazioni
    • 03 apr 1989Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 30 mar 1989
    Consegnato il 03 apr 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 38-44 (even nos) middlesex street, london E1. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Riggs a P Bank
    Transazioni
    • 03 apr 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 24 nov 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 mar 1989
    Consegnato il 03 apr 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All monies from time to time standing to the credit of any current deposit or other account.
    Persone aventi diritto
    • Riggs A.P. Bank Limited
    Transazioni
    • 03 apr 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 30 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 24 feb 1988
    Consegnato il 25 feb 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings on south east side of packhouse road, gerrards cross in the county of buckinghamshire all, stocks, shares, securities. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Banks P.L.C.
    Transazioni
    • 25 feb 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 24 nov 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 24 feb 1988
    Consegnato il 25 feb 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H - 47 high street, tooting london SW17 all, stocks, shares, securities. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Banks P.L.C.
    Transazioni
    • 25 feb 1988Registrazione di un'ipoteca

    SKI INVESTMENTS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    23 dic 2014Inizio della liquidazione
    21 mar 2016Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Matthew Robert Haw
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Praticante
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Karen Ann Spears
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Praticante
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0