SHUKCO 321 LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSHUKCO 321 LTD
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01898264
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SHUKCO 321 LTD?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova SHUKCO 321 LTD?

    Indirizzo della sede legale
    Sita House
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Berkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SHUKCO 321 LTD?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SITA MR COVENTRY LIMITED05 set 200705 set 2007
    EASCO (MIDLANDS) LIMITED11 lug 199611 lug 1996
    KEITH ALLEN METALS LIMITED22 mar 198522 mar 1985

    Quali sono gli ultimi bilanci di SHUKCO 321 LTD?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per SHUKCO 321 LTD?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per SHUKCO 321 LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di David Courtenay Palmer-Jones come amministratore in data 03 giu 2015

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Christophe Andre Bernard Chapron il 01 set 2015

    2 pagineCH01

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed sita mr coventry LIMITED\certificate issued on 14/07/15
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name14 lug 2015

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 03 giu 2015

    RES15

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 14 lug 2015

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Risoluzioni

    Resolutions
    6 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 03 giu 2015

    RES15

    Bilancio annuale redatto al 01 ott 2014 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 ott 2014

    Stato del capitale al 08 ott 2014

    • Capitale: GBP 5,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 ott 2013 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital02 ott 2013

    Stato del capitale al 02 ott 2013

    • Capitale: GBP 5,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    9 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 ott 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    17 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 ott 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    18 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Appoint auditors 22/09/2010
    RES13

    Bilancio annuale redatto al 01 ott 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Mark Hedley Thompson il 01 ott 2010

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Christophe Andre Bernard Chapron il 01 ott 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr David Courtenay Palmer-Jones il 01 ott 2010

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di SHUKCO 321 LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    THOMPSON, Mark Hedley
    Sita House
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Berkshire
    Segretario
    Sita House
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Berkshire
    British135450680001
    CHAPRON, Christophe Andre Bernard
    Sita House
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    Sita House
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Berkshire
    EnglandFrench122645500006
    ALLEN, Eileen Elizabeth
    62 Ambleside Way
    CV11 6AU Nuneaton
    Warwickshire
    Segretario
    62 Ambleside Way
    CV11 6AU Nuneaton
    Warwickshire
    British20600240001
    CUBITT, Richard
    23 Mill Road
    NR11 6DS Aylsham
    Segretario
    23 Mill Road
    NR11 6DS Aylsham
    British114403390001
    MCKENNA-MAYES, Graham Arthur
    38 Bremer Road
    TW18 4HU Staines
    Middlesex
    Segretario
    38 Bremer Road
    TW18 4HU Staines
    Middlesex
    British220314290001
    ALLEN, Eileen Elizabeth
    62 Ambleside Way
    CV11 6AU Nuneaton
    Warwickshire
    Amministratore
    62 Ambleside Way
    CV11 6AU Nuneaton
    Warwickshire
    British20600240001
    ALLEN, Keith
    62 Ambleside Way
    CV11 6AU Nuneaton
    Warwickshire
    Amministratore
    62 Ambleside Way
    CV11 6AU Nuneaton
    Warwickshire
    British20609560001
    BILLIG, Neil Jonathan
    The Old Post Office
    Bawburgh Road
    NR9 5AG Marlingford
    Norfolk
    Amministratore
    The Old Post Office
    Bawburgh Road
    NR9 5AG Marlingford
    Norfolk
    British15677460002
    CUBITT, Richard
    23 Mill Road
    NR11 6DS Aylsham
    Amministratore
    23 Mill Road
    NR11 6DS Aylsham
    EnglandBritish114403390001
    HJORT, Per-Anders
    Flat 76
    21 Sheldon Square
    W2 6DS Paddington London
    Amministratore
    Flat 76
    21 Sheldon Square
    W2 6DS Paddington London
    Swedish121832680001
    MC DONALD, Sidney Thomas
    126 Vinecote Road
    Longford
    CV6 6EB Coventry
    West Midlands
    Amministratore
    126 Vinecote Road
    Longford
    CV6 6EB Coventry
    West Midlands
    British20609570001
    PALMER-JONES, David Courtenay
    Sita House
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    Sita House
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Berkshire
    United KingdomBritish125070620001
    SERRUYS, Andre Paul
    The Old Rectory
    Whinburgh
    NR19 1QS Dereham
    Norfolk
    Amministratore
    The Old Rectory
    Whinburgh
    NR19 1QS Dereham
    Norfolk
    British33476230001
    TROWER, Gordon Leslie
    26 Wordsworth Road
    Bedworth
    CV12 9HB Nuneaton
    Warwickshire
    Amministratore
    26 Wordsworth Road
    Bedworth
    CV12 9HB Nuneaton
    Warwickshire
    British20609580002

    SHUKCO 321 LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 06 set 2005
    Consegnato il 09 set 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 09 set 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 feb 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 28 lug 2003
    Consegnato il 31 lug 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 31 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 30 set 2002
    Consegnato il 08 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 08 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 30TH january 2001
    Creato il 29 mag 2002
    Consegnato il 01 giu 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 01 giu 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 30 gen 2001
    Consegnato il 02 feb 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 02 feb 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 17 ott 1997
    Consegnato il 18 ott 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 18 ott 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 giu 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0