Q.E.D. ENVIRONMENTAL SYSTEMS LIMITED
Panoramica
Nome della società | Q.E.D. ENVIRONMENTAL SYSTEMS LIMITED |
---|---|
Stato della società | Attiva |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01898734 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di Q.E.D. ENVIRONMENTAL SYSTEMS LIMITED?
- fabbricazione di apparecchiature elettroniche per misurazione, collaudo, ecc., non per il controllo dei processi industriali (26511) / Industrie manifatturiere
Dove si trova Q.E.D. ENVIRONMENTAL SYSTEMS LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Unit 3 Cyan Park Jimmy Hill Way CV2 4QP Coventry West Midlands United Kingdom |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di Q.E.D. ENVIRONMENTAL SYSTEMS LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
GEOTECHNICAL INSTRUMENTS (U.K.) LIMITED | 25 mar 1985 | 25 mar 1985 |
Quali sono gli ultimi bilanci di Q.E.D. ENVIRONMENTAL SYSTEMS LIMITED?
Scaduto | Sì |
---|---|
Prossimi bilanci | |
Fine del prossimo esercizio al | 30 giu 2024 |
Scadenza dei prossimi bilanci il | 31 mar 2025 |
Ultimi bilanci | |
Ultimi bilanci redatti al | 30 dic 2022 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per Q.E.D. ENVIRONMENTAL SYSTEMS LIMITED?
Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 02 lug 2025 |
---|---|
Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 16 lug 2025 |
Ultima dichiarazione di conferma | |
Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 02 lug 2024 |
Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per Q.E.D. ENVIRONMENTAL SYSTEMS LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Modifica dei dettagli di Gema Switzerland Gmbh come persona con controllo significativo il 15 nov 2023 | 2 pagine | PSC05 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 02 lug 2024 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Cessazione della carica di Shannon Elizabeth Quirk come amministratore in data 06 giu 2024 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 mag 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2023 al 30 giu 2024 | 1 pagine | AA01 | ||
Soddisfazione dell'onere 9 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||
Bilancio redatto al 30 dic 2022 | 27 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 mag 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Nomina di Shannon Elizabeth Quirk come amministratore in data 01 mar 2023 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Francis Joseph Brixius Jr. come amministratore in data 01 mar 2023 | 1 pagine | TM01 | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2021 | 27 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 mag 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 25 dic 2020 | 27 pagine | AA | ||
Nomina di Joseph James Humke come segretario in data 01 lug 2021 | 2 pagine | AP03 | ||
Nomina di Joseph James Humke come amministratore in data 01 lug 2021 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Karen Park Gallivan come segretario in data 01 lug 2021 | 1 pagine | TM02 | ||
Cessazione della carica di Karen Park Gallivan come amministratore in data 01 lug 2021 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Francis Joseph Brixius Jr. come amministratore in data 10 giu 2021 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di David Myers Lowe come amministratore in data 10 giu 2021 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Mark William Sheahan come amministratore in data 10 giu 2021 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 mag 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 27 dic 2019 | 19 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 mag 2020 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Modifica dei dettagli di Landtec Europe Limited come persona con controllo significativo il 11 nov 2019 | 2 pagine | PSC05 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 mag 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Chi sono gli amministratori di Q.E.D. ENVIRONMENTAL SYSTEMS LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUMKE, Joseph James | Segretario | 11th Avenue Ne Minneapolis 88 Minnesota 55413 United States | 284813560001 | |||||||
HUMKE, Joseph James | Amministratore | Minneapolis Minnesota 88 11th Avenue Ne United States | United States | American | Director | 284812250001 | ||||
LOWE, David Myers | Amministratore | 11th Avenue Ne Minneapolis 88 Minnesota 55413 United States | United States | British | Director | 284273640001 | ||||
BISHOP, Owen David | Segretario | Sovereign House Queensway CV31 3JR Leamington Spa Warwickshire | British | 11001620001 | ||||||
GALLIVAN, Karen Park, Ms. | Segretario | 11th Avenue Ne 55413 Minneapolis 88 Minnesota United States | 205211760001 | |||||||
SHERIDAN, Barry Roger | Segretario | 16 Bullimore Grove CV8 2QF Kenilworth Warwickshire | British | 64865240001 | ||||||
AGUILAR, Ceazar | Amministratore | 18434 Moss Road Riverside California Usa | Usa | American | Director | 117372210001 | ||||
BILLINGHAM, Steve | Amministratore | Queensway CV31 3JR Leamington Spa Sovereign House Warwickshire | United Kingdom | British | Managing Director | 117008390002 | ||||
BISHOP, Owen David | Amministratore | Sovereign House Queensway CV31 3JR Leamington Spa Warwickshire | United Kingdom | British | Accountant | 11001620001 | ||||
BRIXIUS JR., Francis Joseph | Amministratore | 11th Avenue Ne Minneapolis 88 Minnesota 55413 United States | United States | American | Director | 284273850001 | ||||
CUMMINS, Christopher | Amministratore | 1472 Stanford Court Santa Ana California 92705 Usa | United States | American | Director | 117372250001 | ||||
DRAPER, Bruce William | Amministratore | 4 Laertes Grove Heathcote CV34 6EL Warwick Warwickshire | United Kingdom | British | Engineer | 72252530001 | ||||
GALLIVAN, Karen Park, Ms. | Amministratore | 11th Avenue Ne 55413 Minneapolis 88 Minnesota United States | United States | American | Attorney | 191797070001 | ||||
JONES, David Ernest, Mister | Amministratore | 51 Mill Crescent Southam CV33 0LN Leamington Spa Warwickshire | British | Production Manager | 8556070001 | |||||
KAVANAGH, Dean Peter | Amministratore | Sovereign House Queensway CV31 3JR Leamington Spa Warwickshire | England | British | Programme Director | 157390400001 | ||||
KITCHEN, David Michael | Amministratore | 45 Hamilton Avenue Hurlinesham FOREIGN Johannesburg 2196 South Africa | British | Engineer | 72249050004 | |||||
LANGRIDGE, Sam Malcolm, Dr | Amministratore | 35 Rocks Park Road TN22 2AT Uckfield East Sussex | British | Director | 60963690001 | |||||
MIDLANE, Stephen Roy | Amministratore | 3 Nolene Street Constantia Kloof 1709 South Africa | South African | Group Financial Director | 63148130001 | |||||
QUIRK, Shannon Elizabeth | Amministratore | 11 Avenue Ne Minneapolis 88 Mn 55401-4322 United States | United States | American | Attorney | 306926920001 | ||||
RILEY, Roger | Amministratore | Sovereign House Queensway CV31 3JR Leamington Spa Warwickshire | United Kingdom | British | Director | 117373010001 | ||||
ROTHE, Christian Edward, Mr. | Amministratore | 11th Avenue Ne 55413 Minneapolis 88 Minnesota United States | United States | American | Chief Financial Officer | 205247460001 | ||||
SCHOFIELD, Timothy Charles | Amministratore | 32 Lapsley Drive OX16 1EW Banbury Oxfordshire | British | Engineer | 90709360001 | |||||
SHEAHAN, Mark William | Amministratore | 11th Avenue Ne 55413 Minneapolis 88 Mn United States | United States | American | Finance And Accounting | 249801340001 | ||||
SHERIDAN, Barry Roger | Amministratore | 16 Bullimore Grove CV8 2QF Kenilworth Warwickshire | British | Accountant | 64865240001 | |||||
SIDOR, Richard | Amministratore | 1821 Rossmont Drive Redlands California 92373 Usa | United States | American | Director | 117372400001 | ||||
SMITH, Mark James | Amministratore | 121a Froome Road Atholl Sandton FOREIGN Johannesburg 2196 South Africa | South African | Managing Director | 63148160001 | |||||
TONKINS, Thomas Charles | Amministratore | 11 Wellington Drive CV37 7HJ Stratford Upon Avon Warwickshire | British | Sales Manager | 70931390001 | |||||
TOOLEY, Jamie J | Amministratore | 13398 Canyon Heights Yucaipa California 92399 Usa | United States | American | Director | 117372130001 | ||||
WATSON, Anthony Keith | Amministratore | Sovereign House Queensway CV31 3JR Leamington Spa Warwickshire | United Kingdom | British | Operations Director | 99078740001 | ||||
WEEKS, Robert Clement | Amministratore | Tall Pines 27 High Street CV35 8BU Barford Warwickshire | British | Mechanical Engineer | 78534660001 | |||||
ZITO, Paul Michael | Amministratore | 321 Wildberry Road PA 15238 Pittsburgh Pennsylvania Usa | American | Eutrepreneur | 79075570001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di Q.E.D. ENVIRONMENTAL SYSTEMS LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Graco Inc. | 03 ago 2016 | 88 - 11th Avenue Ne 55413 Minneapolis 88 - 11th Avenue Ne Mn United States | No | ||||
| |||||||
Natura del controllo
|
Q.E.D. ENVIRONMENTAL SYSTEMS LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creato il 21 ott 1998 Consegnato il 29 ott 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge | Creato il 27 gen 1994 Consegnato il 01 feb 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever supplemental to a fixed and floating charge dated 28 july 1989 | |
Brevi particolari Fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company; and all patents patent applications inventions trade marks trade names etc. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Credit agreement | Creato il 14 set 1993 Consegnato il 18 set 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £27528.43 due from the company to the chargee under the terms of the agreement | |
Brevi particolari All right title and interest in and to all sums payable under the insurances particulars of which are set out on the reverse to form 395. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 23 mar 1993 Consegnato il 30 mar 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari The undertaking of the company and all the company's property and assets both present and future including the company's uncalled capital for the time being. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Collateral chattel mortgage | Creato il 23 dic 1991 Consegnato il 24 dic 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from measurement techniques LTD to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Matsoura 16 tool machining centre & other named chattels...see form 395 for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Chattel mortgage | Creato il 22 gen 1991 Consegnato il 24 gen 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Matsoura 16 tool machining centre serial no 80071276 takumatsu 1A lathe serial no 8409313 takumatsu 2A lathe serial no 8503504 station house, old warwick road, leamington spa, warwickshire CV31 3HR. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fixed and floating charge | Creato il 28 lug 1989 Consegnato il 09 ago 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book & other debts, uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Collateral debenture | Creato il 28 lug 1989 Consegnato il 02 ago 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys now due or hereafter to become due, or from time to time accruing due from jolix limited to 3I PLC on any account whatsoever. | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 09 ott 1985 Consegnato il 18 ott 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over the company's estate or interest in all f/h or l/h properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0