CASSIS TRAVEL SERVICES LIMITED

CASSIS TRAVEL SERVICES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCASSIS TRAVEL SERVICES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01900904
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CASSIS TRAVEL SERVICES LIMITED?

    • Attività delle agenzie di viaggio (79110) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova CASSIS TRAVEL SERVICES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    East House
    109 South Worple Way
    SW14 8TN London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di CASSIS TRAVEL SERVICES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per CASSIS TRAVEL SERVICES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital11 feb 2016

    Stato del capitale al 11 feb 2016

    • Capitale: GBP 90,000
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Melanie Ruth Rom il 31 dic 2015

    2 pagineCH01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 giu 2015

    8 pagineAA

    Nomina di Melanie Ruth Rom come amministratore in data 17 feb 2015

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 feb 2015

    Stato del capitale al 10 feb 2015

    • Capitale: GBP 90,000
    SH01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 apr 2015 al 30 giu 2015

    1 pagineAA01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 apr 2014

    6 pagineAA

    Varie

    Section 519
    1 pagineMISC

    Nomina di Mr Edward Richard Rom come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di Mr John Albert Mcewan come amministratore

    3 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da * 55 Loudoun Road London NW8 0DL* in data 01 apr 2014

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Mark Scott come segretario

    3 pagineTM02

    Cessazione della carica di Robert Kovacs come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Michele Montgomery come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Anthony Russell come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Mark Scott come amministratore

    2 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 feb 2014

    Stato del capitale al 07 feb 2014

    • Capitale: GBP 90,000
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Michele Montgomery il 31 dic 2013

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Robert Kovacs il 31 dic 2013

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Mark Martin Scott il 31 dic 2013

    2 pagineCH01

    Soddisfazione dell'onere 9 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    1 pagineMR04

    Chi sono gli amministratori di CASSIS TRAVEL SERVICES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MCEWAN, John Albert
    109 South Worple Way
    SW14 8TN London
    East House
    England
    Amministratore
    109 South Worple Way
    SW14 8TN London
    East House
    England
    EnglandBritish11956090001
    ROM, Edward Richard
    109 South Worple Way
    SW14 8TN London
    East House
    England
    Amministratore
    109 South Worple Way
    SW14 8TN London
    East House
    England
    EnglandBritish81968090002
    ROM, Melanie Ruth
    109 South Worple Way
    SW14 8TN London
    East House
    Amministratore
    109 South Worple Way
    SW14 8TN London
    East House
    EnglandBritish174439800001
    BOUVIER, Graham John
    Apartment 405
    118 Southwark Bridge Road
    SE1 0BQ London
    Segretario
    Apartment 405
    118 Southwark Bridge Road
    SE1 0BQ London
    British117533510001
    BROWN, Simon
    30 Coval Road
    SW14 7RL London
    Segretario
    30 Coval Road
    SW14 7RL London
    British6846640003
    BROWN, Simon
    25a Lyhon Road
    EN5 5XH New Barnet
    Herts
    Segretario
    25a Lyhon Road
    EN5 5XH New Barnet
    Herts
    Irish6846640001
    FORBES, Pamela Delores
    121 Connaught Road
    Brookwood
    GU24 0EU Woking
    Surrey
    Segretario
    121 Connaught Road
    Brookwood
    GU24 0EU Woking
    Surrey
    British72643400001
    GEORGIOU, Vassos
    Anndiville 29 Woodhill Avenue
    SL9 8DP Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Segretario
    Anndiville 29 Woodhill Avenue
    SL9 8DP Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British63025640002
    LAVILLES, Michael
    273 Conway Crescent
    UB6 8JG Greenford
    Middlesex
    Segretario
    273 Conway Crescent
    UB6 8JG Greenford
    Middlesex
    Australian58021980001
    SADEGHI, Gillian
    6 Couchill Drive
    EX12 2JG Seaton
    Devon
    Segretario
    6 Couchill Drive
    EX12 2JG Seaton
    Devon
    British98863440001
    SCOTT, Mark Martin
    55 Loudoun Road
    London
    NW8 0DL
    Segretario
    55 Loudoun Road
    London
    NW8 0DL
    British25893930004
    BOUVIER, Graham John
    Apartment 405
    118 Southwark Bridge Road
    SE1 0BQ London
    Amministratore
    Apartment 405
    118 Southwark Bridge Road
    SE1 0BQ London
    British117533510001
    BROWN, Simon
    30 Coval Road
    SW14 7RL London
    Amministratore
    30 Coval Road
    SW14 7RL London
    British6846640003
    DIMOND, William John
    167 Park Close
    KT12 1EW Walton On Thames
    Surrey
    Amministratore
    167 Park Close
    KT12 1EW Walton On Thames
    Surrey
    British74014680001
    GEORGIOU, Vassos
    55 Loudoun Road
    London
    NW8 0DL
    Amministratore
    55 Loudoun Road
    London
    NW8 0DL
    British63025640002
    GREENE, Stephen Paul
    Tregarthen 10 Rose Walk
    CR8 3LG Purley
    Surrey
    Amministratore
    Tregarthen 10 Rose Walk
    CR8 3LG Purley
    Surrey
    British1989160001
    HARRIS, David Kenneth
    11 Kent Terrace
    NW1 4RP London
    Amministratore
    11 Kent Terrace
    NW1 4RP London
    British35570220001
    HUMPHREYS, Richard Alan
    1 Stanford Road
    W8 5PP London
    Amministratore
    1 Stanford Road
    W8 5PP London
    EnglandBritish25414410001
    KOVACS, Robert
    55 Loudoun Road
    London
    NW8 0DL
    Amministratore
    55 Loudoun Road
    London
    NW8 0DL
    UsaAmerican74014730002
    LEIGH, Geoffrey Norman, Sir
    38 Belgrave Square
    SW1X 8NT London
    Amministratore
    38 Belgrave Square
    SW1X 8NT London
    British62389840001
    MONTGOMERY, Michele
    55 Loudoun Road
    London
    NW8 0DL
    Amministratore
    55 Loudoun Road
    London
    NW8 0DL
    UsaAmerican50247410002
    PRESS, Steven Ross
    84 Walton Street
    SW3 2HH London
    Amministratore
    84 Walton Street
    SW3 2HH London
    British17409020001
    RICK, Diane Jennifer
    11 Kent Terrace
    Regents Park
    NW1 4RP London
    Amministratore
    11 Kent Terrace
    Regents Park
    NW1 4RP London
    Irish77607270001
    RUSSELL, Anthony David
    55 Loudoun Road
    London
    NW8 0DL
    Amministratore
    55 Loudoun Road
    London
    NW8 0DL
    United KingdomBritish42783150001
    SCOTT, Mark Martin
    55 Loudoun Road
    London
    NW8 0DL
    Amministratore
    55 Loudoun Road
    London
    NW8 0DL
    United KingdomBritish25893930004

    CASSIS TRAVEL SERVICES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge of deposit
    Creato il 14 dic 2011
    Consegnato il 20 dic 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All amounts now and in the future credited to account number 10234977 with the bank.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 dic 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Charge of deposit
    Creato il 06 apr 2010
    Consegnato il 23 apr 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All deposits now and in the future credited to account designation 10153977 with the bank and any deposit or account of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 23 apr 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 05 feb 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge of deposit
    Creato il 08 gen 2002
    Consegnato il 11 gen 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The deposit initially of £139,195 credited to account designation 8121532 with the bank and any addition to that deposit and any deposit or account from time to time of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 11 gen 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 feb 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge over credit balances
    Creato il 03 apr 2001
    Consegnato il 14 apr 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The sum of £132,160.00 together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on account numbered 8121532.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 14 apr 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 feb 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge over credit balances
    Creato il 23 dic 1998
    Consegnato il 31 dic 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to a guarantee for a bond in favour abta for £110,178
    Brevi particolari
    The sum of £146,178 together with interest accrued now or to be held by the bank on an account numbered 8121532.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 31 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 feb 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge over credit balances
    Creato il 24 gen 1997
    Consegnato il 04 feb 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to a guarantee bond dated 20 december 1996 in favour of association of british travel agents for £83,171
    Brevi particolari
    The sum of £125,171 together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 8121532.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 feb 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 feb 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge over credit balances
    Creato il 16 ago 1996
    Consegnato il 30 ago 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to a bond dated 1 july 1996 in favour of the association of british travel agents limited for £52,922
    Brevi particolari
    The sum of £94,922 together with interest accrued now or to be held by national westmister bank PLC on an account numbered 8121532 and earmarked or designated by reference to the company.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 30 ago 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 feb 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge over credit balances
    Creato il 24 ago 1993
    Consegnato il 03 set 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in ralation to a bond dated 18/5/93 in favour of abta for £20,000
    Brevi particolari
    The sum of £20,000 together with interest accrued now or to be held by the bank on an account no 60626720 & designated by ref to the company.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 set 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 feb 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge over credit balances
    Creato il 09 ott 1992
    Consegnato il 14 ott 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to a bank guarantee in favour of sharps individual bedrooms limited for £21,000 dated 13/05/92 and also a bank guarantee in favour of sonal limited for £21,000 dated 13TH may 1992
    Brevi particolari
    The sum of £42,000 tog: with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account no: 60586761 and designated by reference to the company.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ott 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 feb 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed and floating charge
    Creato il 09 ott 1992
    Consegnato il 14 ott 1992
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ott 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 01 lug 1985
    Consegnato il 09 lug 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (See doc M6). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Credit Lyonwais Bank Nederland N.V.
    Transazioni
    • 09 lug 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 22 ott 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0