INOCO LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàINOCO LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01902327
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di INOCO LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova INOCO LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    2 Duke Street
    St James's, 1st Floor
    SW1Y 6BN London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di INOCO LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    INOCO PUBLIC LIMITED COMPANY03 apr 198503 apr 1985

    Quali sono gli ultimi bilanci di INOCO LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per INOCO LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 apr 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Yvonne Kelsey come segretario in data 26 nov 2021

    1 pagineTM02

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2020

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 apr 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2019

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 apr 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da 2 Duke Street C/O Blackfish Capital Ltd, 1st Floor London SW1Y 6BN England a 2 Duke Street St James's, 1st Floor London SW1Y 6BN in data 29 apr 2020

    1 pagineAD01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2018

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 apr 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2017

    5 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da 5 Savile Row London W1S 3PB a 2 Duke Street C/O Blackfish Capital Ltd, 1st Floor London SW1Y 6BN in data 16 ago 2018

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 apr 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2016

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 apr 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2015

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 23 apr 2016 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital13 mag 2016

    Stato del capitale al 13 mag 2016

    • Capitale: GBP 20,651,520
    SH01

    Cessazione della carica di Harley James Rowland come amministratore in data 31 mar 2016

    1 pagineTM01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2014

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 23 apr 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 mag 2015

    Stato del capitale al 05 mag 2015

    • Capitale: GBP 20,651,520
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2013

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 23 apr 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 apr 2014

    Stato del capitale al 23 apr 2014

    • Capitale: GBP 20,651,520
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da * C/O Blackfish Services 5 Savile Row London W1S 3PB United Kingdom* in data 14 apr 2014

    1 pagineAD01

    Chi sono gli amministratori di INOCO LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ROBESON, Graham John
    Duke Street
    St James's, 1st Floor
    SW1Y 6BN London
    2
    England
    Amministratore
    Duke Street
    St James's, 1st Floor
    SW1Y 6BN London
    2
    England
    United KingdomBritishCompany Director147389920001
    BAYLEY, Kate
    143 Erskine Crescent
    N17 9PS London
    Segretario
    143 Erskine Crescent
    N17 9PS London
    British79510000001
    CAUSTON, Richard Ian
    Shelton
    Rohais, St. Peter Port
    GY1 1YW Guernsey
    Channel Islands
    Segretario
    Shelton
    Rohais, St. Peter Port
    GY1 1YW Guernsey
    Channel Islands
    British97060270001
    KELSEY, Yvonne
    Duke Street
    St James's, 1st Floor
    SW1Y 6BN London
    2
    England
    Segretario
    Duke Street
    St James's, 1st Floor
    SW1Y 6BN London
    2
    England
    185118270001
    MILLER, David
    1 Chiltern Road
    SG4 9PL Hitchin
    Hertfordshire
    Segretario
    1 Chiltern Road
    SG4 9PL Hitchin
    Hertfordshire
    British59650030005
    MILLER, David
    17 Isbets Dale
    Taverham
    NR8 6XA Norwich
    Segretario
    17 Isbets Dale
    Taverham
    NR8 6XA Norwich
    British59650030002
    SMITH, Michael David Langford
    Flat 10
    77 Clapham Common Southside
    SW4 9DG London
    Segretario
    Flat 10
    77 Clapham Common Southside
    SW4 9DG London
    South African66613940002
    WOOLRICH, Kevin
    7 Turner Close
    NR18 0NP Wymondham
    Norfolk
    Segretario
    7 Turner Close
    NR18 0NP Wymondham
    Norfolk
    British47103250002
    YUILL, Andrew
    c/o Blackfish Services
    Savile Row
    W1S 3PB London
    5
    United Kingdom
    Segretario
    c/o Blackfish Services
    Savile Row
    W1S 3PB London
    5
    United Kingdom
    Other135815640001
    HUDD, David Leslie
    97 Gunterstone Road
    W14 9BT London
    Amministratore
    97 Gunterstone Road
    W14 9BT London
    EnglandBritishChartered Accountant26032950002
    JAMES, Jeremy Edward
    Gaiters Bishops Walk
    Shirley Hills
    CR0 5BA Addington
    Surrey
    Amministratore
    Gaiters Bishops Walk
    Shirley Hills
    CR0 5BA Addington
    Surrey
    BritishCompany Director35230430001
    LEAN, Venetia Monique
    Warboys House
    Warboys Road
    KT2 7LS Kingston Upon Thames
    Surrey
    Amministratore
    Warboys House
    Warboys Road
    KT2 7LS Kingston Upon Thames
    Surrey
    LuxembourgBritishCompany Director121698060001
    MORAN, Derek Joseph
    Dorrien Lodge March Road
    KT13 8XA Weybridge
    Surrey
    Amministratore
    Dorrien Lodge March Road
    KT13 8XA Weybridge
    Surrey
    EnglandCanadianAccountant5332280002
    ROBESON, Graham John
    The Old Vicarage
    NR12 9HN East Ruston
    Norfolk
    Amministratore
    The Old Vicarage
    NR12 9HN East Ruston
    Norfolk
    United KingdomBritishCompany Director147389920001
    ROWLAND, David John
    3 Zenobia Mansions
    Queens Club Gardens
    W14 9TD London
    Amministratore
    3 Zenobia Mansions
    Queens Club Gardens
    W14 9TD London
    BritishCompany Director53183700002
    ROWLAND, David John
    49 Avenue De L Annonciade
    MC98000 Monte-Carlo
    Monaco
    Amministratore
    49 Avenue De L Annonciade
    MC98000 Monte-Carlo
    Monaco
    BritishInvestor53183700001
    ROWLAND, Harley James
    Savile Row
    W1S 3PB London
    5
    England
    Amministratore
    Savile Row
    W1S 3PB London
    5
    England
    LuxembourgBritishCompany Director125919200005
    ROWLAND, Jonathan David
    24 Lattimer Place
    W4 2UB London
    Amministratore
    24 Lattimer Place
    W4 2UB London
    BritishCompany Director55523310001

    Chi sono le persone con controllo significativo di INOCO LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr David John Rowland
    Duke Street
    St James's, 1st Floor
    SW1Y 6BN London
    2
    England
    06 apr 2016
    Duke Street
    St James's, 1st Floor
    SW1Y 6BN London
    2
    England
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: Guernsey
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    INOCO LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Standard security which was presented for registration in scotland
    Creato il 28 nov 1995
    Consegnato il 12 dic 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All and whole the subjects comprising 65-71 (odd numbers) south bridge street airdrie t/n LAN48752.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 12 dic 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 20 feb 1995
    Consegnato il 24 feb 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a 923 stockport road levenshulme manchester. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 24 feb 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 15 feb 1995
    Consegnato il 21 feb 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a units 1 & 2 howdenshire way howden humberside. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 21 feb 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 feb 1995
    Consegnato il 10 feb 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 11 the walk rochdale greater manchester. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 10 feb 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 feb 1995
    Consegnato il 10 feb 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 45 oxford street, ripley derbyshire. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 10 feb 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 feb 1995
    Consegnato il 10 feb 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 1 high street leominster hereford and worcester. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 10 feb 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 feb 1995
    Consegnato il 10 feb 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land on the south west side of new road attelborough norfolk (now K.a units 1A and 1B haverscroft industrial estate attelborough norfolk). Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 10 feb 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 feb 1995
    Consegnato il 10 feb 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and buildings on the south eas side of henry lane, bardney lincolnshire (now k/a units 1A, 1B and 2A-e alma martin way industrial estate bardney). Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 10 feb 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 ott 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 feb 1995
    Consegnato il 10 feb 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a units 1A, and 1B and 2A to 2D ruskington small business centre fen road, ruskington, lincolnshire. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 10 feb 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 ott 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 feb 1995
    Consegnato il 10 feb 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a 310 coventry road, small heath birmingham west midlands. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 10 feb 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 feb 1995
    Consegnato il 10 feb 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 3 ye market selsdon road croydon. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 10 feb 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 feb 1995
    Consegnato il 10 feb 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a units 1, 2A, 2B and 5 greenfield park industrial estate willowburn avenue, alnwick northumberland. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 10 feb 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 05 dic 1994
    Consegnato il 20 dic 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    10 winchley square preston.
    Persone aventi diritto
    • Leopold Joseph & Sons Limited
    Transazioni
    • 20 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 05 dic 1994
    Consegnato il 20 dic 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    1 dale street liverpool.
    Persone aventi diritto
    • Leopold Joseph & Sons Limited
    Transazioni
    • 20 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of memorandum of terms of deposit
    Creato il 02 giu 1994
    Consegnato il 07 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All or any sums for the time being deposited by the company to the credit opf the account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Leopold Joseph & Sons Limited
    Transazioni
    • 07 giu 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 giu 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 mar 1994
    Consegnato il 14 mar 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    5/7 wellgate rotherham west yorkshire t/no.SYK291226.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 mar 1994
    Consegnato il 14 mar 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    267 high street sutton l/b of sutton t/no.SGL538728.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 mar 1994
    Consegnato il 14 mar 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    14-18 carlton street castleford west yorkshire t/no.WYK468430.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 mar 1994
    Consegnato il 14 mar 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Units 1A-e, 2 & 3 faraday road business park littleport cambs t/no.CB133016.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 mar 1994
    Consegnato il 14 mar 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    39 euston road morecambe lancs t/no. LA576994.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 ott 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 mar 1994
    Consegnato il 14 mar 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    5A-e and 6A-d heather road skegness lincs.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 ott 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 mar 1994
    Consegnato il 14 mar 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Units 4A & b and 5A & b fleet road holbeach lincs.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 ott 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignation of rent
    Creato il 07 dic 1993
    Consegnato il 21 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to a standard security and a floating charge both dated 24TH may 1988
    Brevi particolari
    All rents and other sums payable under the leases. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • United Dominions Trust Limited
    Transazioni
    • 21 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 giu 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of rents
    Creato il 15 nov 1993
    Consegnato il 03 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All rents, licences fees and other like sums payable under each and all of the leases underleases and licences. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • United Dominions Trust Limited
    Transazioni
    • 03 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 giu 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 nov 1993
    Consegnato il 11 nov 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that f/h property k/a land and buildings at rink road ryde isle of wight t/nos. IW11248 and IW20145.
    Persone aventi diritto
    • Standard Chartered Bank
    Transazioni
    • 11 nov 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0