CELEBRATION CARDS LIMITED

CELEBRATION CARDS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCELEBRATION CARDS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01904100
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CELEBRATION CARDS LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova CELEBRATION CARDS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Century House
    Wakefield 41 Industrial Estate
    WF2 0XG Wakefield
    West Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di CELEBRATION CARDS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 gen 2023

    Quali sono le ultime deposizioni per CELEBRATION CARDS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    2 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 gen 2023

    5 pagineAA

    Nomina di Mr Matthias Alexander Seeger come amministratore in data 22 mag 2023

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Adam John Dury come amministratore in data 31 gen 2023

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Kristian Brian Lee come amministratore in data 31 gen 2023

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 gen 2022

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 gen 2021

    5 pagineAA

    Cessazione della carica di Paul Stephen Moody come amministratore in data 08 mar 2021

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Darcy Willson-Rymer come amministratore in data 08 mar 2021

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 gen 2020

    5 pagineAA

    Cessazione della carica di Christopher Robbert Beck come amministratore in data 20 ott 2020

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Paul Stephen Moody come amministratore in data 30 giu 2020

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 gen 2019

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 gen 2018

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Darren Bryant come amministratore in data 31 lug 2017

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Kristian Brian Lee come amministratore in data 31 lug 2017

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 gen 2017

    5 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di CELEBRATION CARDS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DURY, Adam John
    Century House
    Wakefield 41 Industrial Estate
    WF2 0XG Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    Century House
    Wakefield 41 Industrial Estate
    WF2 0XG Wakefield
    West Yorkshire
    EnglandBritish201215790001
    SEEGER, Matthias Alexander
    Century House
    Wakefield 41 Industrial Estate
    WF2 0XG Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    Century House
    Wakefield 41 Industrial Estate
    WF2 0XG Wakefield
    West Yorkshire
    EnglandGerman309574790001
    WILLSON-RYMER, Darcy
    Century House
    Wakefield 41 Industrial Estate
    WF2 0XG Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    Century House
    Wakefield 41 Industrial Estate
    WF2 0XG Wakefield
    West Yorkshire
    EnglandBritish280585620001
    ELLIS, Helen
    88 Moorside
    BD19 6JX Cleckheaton
    West Yorkshire
    Segretario
    88 Moorside
    BD19 6JX Cleckheaton
    West Yorkshire
    British94871680002
    LONGSTAFFE, Andrew David
    Century House
    Wakefield 41 Industrial Estate
    WF2 0XG Wakefield
    West Yorkshire
    Segretario
    Century House
    Wakefield 41 Industrial Estate
    WF2 0XG Wakefield
    West Yorkshire
    British197462400001
    MOSELEY, Lorna Irene
    2 Stradbroke Drive
    IG7 5QX Chigwell
    Essex
    Segretario
    2 Stradbroke Drive
    IG7 5QX Chigwell
    Essex
    British12323760001
    SIMPER, Rita
    33 Ashbourne Road
    EN10 7DE Broxbourne
    Hertfordshire
    Segretario
    33 Ashbourne Road
    EN10 7DE Broxbourne
    Hertfordshire
    British59408890001
    BECK, Christopher Robbert
    Century House
    Wakefield 41 Industrial Estate
    WF2 0XG Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    Century House
    Wakefield 41 Industrial Estate
    WF2 0XG Wakefield
    West Yorkshire
    United KingdomBritish134957850001
    BRYANT, Darren
    Brunel Road
    Wakefield 41 Industrial Estate
    WF2 0XG Wakefield
    Century House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Brunel Road
    Wakefield 41 Industrial Estate
    WF2 0XG Wakefield
    Century House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish141067760001
    HAYES, Richard John
    Century House
    Wakefield 41 Industrial Estate
    WF2 0XG Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    Century House
    Wakefield 41 Industrial Estate
    WF2 0XG Wakefield
    West Yorkshire
    United KingdomBritish89681770002
    HOYLE, Dean
    Park Drive
    WF14 9NQ Mirfield
    14
    West Yorkshire
    Amministratore
    Park Drive
    WF14 9NQ Mirfield
    14
    West Yorkshire
    United KingdomBritish89681900001
    LEE, Kristian Brian
    Century House
    Wakefield 41 Industrial Estate
    WF2 0XG Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    Century House
    Wakefield 41 Industrial Estate
    WF2 0XG Wakefield
    West Yorkshire
    EnglandBritish160887440001
    MOODY, Paul Stephen
    Century House
    Wakefield 41 Industrial Estate
    WF2 0XG Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    Century House
    Wakefield 41 Industrial Estate
    WF2 0XG Wakefield
    West Yorkshire
    EnglandBritish271684570001
    MOSELEY, Frank Ernest
    2 Stradbroke Drive
    IG7 5QX Chigwell
    Essex
    Amministratore
    2 Stradbroke Drive
    IG7 5QX Chigwell
    Essex
    British10308550001

    Chi sono le persone con controllo significativo di CELEBRATION CARDS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Sportswift Limited
    Brunel Road
    Wakefield 41 Industrial Estate
    WF2 0XG Wakefield
    Century House
    England
    06 apr 2016
    Brunel Road
    Wakefield 41 Industrial Estate
    WF2 0XG Wakefield
    Century House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House England And Wales
    Numero di registrazione03493972
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    CELEBRATION CARDS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Rent deposit deed
    Creato il 09 ott 2003
    Consegnato il 15 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The deposit being an initial deposit of £16,250 together with a sum equivalent to vat of £2,843.75 and each and every debt represented by it. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Life Assurance Company Limited
    Transazioni
    • 15 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 dic 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 29 apr 1996
    Consegnato il 16 mag 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/Hold property known as 9 the quintins north street hailsham east sussex with all rights,licences,guarantees,deeds,etc; the goodwill of business and any rental/other money payable. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 16 mag 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 dic 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 24 mar 1995
    Consegnato il 30 mar 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a unit 3B biggin gate 11-16 biggin street dover kent t/no.K75178. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 30 mar 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 dic 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 24 mar 1995
    Consegnato il 30 mar 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a unit 3, 30-36 st anns road harrow middx. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 30 mar 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 dic 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 24 mar 1995
    Consegnato il 30 mar 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a 87 eltham high street, eltham, london SE9 1TD. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 30 mar 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 05 set 1994
    Consegnato il 13 set 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company; and all patents patent applications inventions trade marks trade names etc.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 13 set 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 gen 1994
    Consegnato il 20 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The l/h property being or k/a unit 7 coleman house maidstone kent. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 20 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 21 apr 1993
    Consegnato il 01 mag 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    101 west street fareham hampshire, together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property; and the benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 01 mag 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 21 apr 1993
    Consegnato il 01 mag 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    58 london road north end portsmouth, together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property; and the benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 01 mag 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 27 lug 1992
    Consegnato il 29 lug 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/Hold lands being unit 2,the pavilion high st,tonbridge,kent with all fixtures and fittings;the benefits of all rights licences and the goodwill of business.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 29 lug 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 dic 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 apr 1992
    Consegnato il 25 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 30 high street, ramsgate, kent with the benefit of licences and goodwill. See form 395 relevant to this charge.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 25 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 apr 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 apr 1992
    Consegnato il 25 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit 49, the walnuts shopping centre, orpington, kent with the benefit of licences and goodwill. See form 395 relevant to this charge.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 25 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 dic 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 apr 1992
    Consegnato il 25 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 55 high street, gosport, hampshire, with the benefit of licences and goodwill. See form 395 relevant to this charge.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 25 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 dic 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 04 mar 1992
    Consegnato il 05 mar 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    13 wolsey walk woking surrey.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 05 mar 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 04 set 1991
    Consegnato il 05 set 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/Hold - 77 high street, bromley.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 05 set 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 23 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 24 giu 1991
    Consegnato il 25 giu 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit 30 the centre margate.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 25 giu 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 21 dic 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 24 giu 1991
    Consegnato il 25 giu 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 162 high street lewisham.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 25 giu 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 23 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 17 apr 1991
    Consegnato il 18 apr 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Leasehold property kown as 85 high street putney.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 18 apr 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 23 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 mar 1991
    Consegnato il 14 mar 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    85 high street putney & 7 taken house london SW15.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 14 mar 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 23 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 10 gen 1990
    Consegnato il 23 gen 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    162 high street lewisham.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 23 gen 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 23 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 10 gen 1990
    Consegnato il 23 gen 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    13 wolsey walk woking surrey.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 23 gen 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 23 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 26 mag 1989
    Consegnato il 30 mag 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property 6 montague street worthing west sussex title no:- wfx 127167.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 30 mag 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 23 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 11 apr 1989
    Consegnato il 17 apr 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H- shop units level 1 queen square house queen square brighton t/no esx 139550.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 17 apr 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 15 apr 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 gen 1988
    Consegnato il 28 gen 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H- 6 montague street, worthing west sussex.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 28 gen 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 23 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 dic 1987
    Consegnato il 15 gen 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit a 74/76 new road gravesend kent.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 15 gen 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 21 dic 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0