HPM & ADDO LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHPM & ADDO LTD
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01906031
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HPM & ADDO LTD?

    • altre attività di stampa n.c.a. (18129) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova HPM & ADDO LTD?

    Indirizzo della sede legale
    Fourth Floor Toronto Square
    Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HPM & ADDO LTD?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HILLPRINT MEDIA LIMITED21 ott 200321 ott 2003
    HILLPRINT LIMITED10 gen 198910 gen 1989
    THOMAS HILL PRINT (1985) LIMITED10 set 198510 set 1985
    FERDOM LIMITED17 apr 198517 apr 1985

    Quali sono gli ultimi bilanci di HPM & ADDO LTD?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2013

    Quali sono le ultime deposizioni per HPM & ADDO LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Nomina di un amministratore

    pagine2.12B

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione in data 27 gen 2016

    21 pagine2.35B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 30 ott 2015

    21 pagine2.24B

    Indirizzo della sede legale modificato da 9th Floor Bond Court Leeds LS1 2JZ a Fourth Floor Toronto Square Toronto Street Leeds LS1 2HJ in data 26 ott 2015

    2 pagineAD01

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 30 apr 2015

    19 pagine2.24B

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    1 pagineF2.18

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    30 pagine2.17B

    Indirizzo della sede legale modificato da Prime House Park 2000 Heighington Lane Business Park Newton Aycliffe County Durham DL5 6AR a 9Th Floor Bond Court Leeds LS1 2JZ in data 15 dic 2014

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Soddisfazione dell'onere 019060310010 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 019060310009 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 10 ott 2014 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 ott 2014

    Stato del capitale al 23 ott 2014

    • Capitale: GBP 79,000
    SH01

    Cessazione della carica di Richard Thomas Mortimer come segretario in data 30 set 2014

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Richard Thomas Mortimer come amministratore in data 30 set 2014

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 09 giu 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 lug 2014

    Stato del capitale al 23 lug 2014

    • Capitale: GBP 79,000
    SH01

    Nomina di Mr Keiran John Bayley come amministratore in data 31 mag 2014

    2 pagineAP01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Richard Thomas Mortimer il 31 mag 2014

    2 pagineCH01

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed hillprint media LIMITED\certificate issued on 16/06/14
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name16 giu 2014

    Risoluzione di cambio di nome della società il 16 giu 2014

    RES15
    change-of-name16 giu 2014

    Cambio di nome" per delibera

    NM01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2013

    10 pagineAA

    Iscrizione dell'ipoteca 019060310010

    7 pagineMR01

    Cessazione della carica di Richard Lister come amministratore

    1 pagineTM01

    Iscrizione dell'ipoteca 019060310009

    7 pagineMR01

    Bilancio annuale redatto al 09 giu 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 lug 2013

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 04 lug 2013

    SH01

    Chi sono gli amministratori di HPM & ADDO LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BAYLEY, Keiran John
    Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    Fourth Floor Toronto Square
    Amministratore
    Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    Fourth Floor Toronto Square
    EnglandBritish181397910002
    CONNELL, Valerie
    Eden Road
    DL5 5QY Newton Aycliffe
    29
    Co Durham
    Segretario
    Eden Road
    DL5 5QY Newton Aycliffe
    29
    Co Durham
    British137583350001
    GROVES, Peter
    8 Limpton Gate
    Spitalfields
    TS15 9JA Yarm
    Cleveland
    Segretario
    8 Limpton Gate
    Spitalfields
    TS15 9JA Yarm
    Cleveland
    British37554590001
    JACKSON, Terence George
    Glengarry
    395 Thornaby Road Thornaby Village
    TS17 8QN Stockton On Tees
    Segretario
    Glengarry
    395 Thornaby Road Thornaby Village
    TS17 8QN Stockton On Tees
    British74363830001
    MORTIMER, Richard Thomas
    Prime House
    Park 2000 Heighington Lane
    DL5 6AR Business Park Newton Aycliffe
    County Durham
    Segretario
    Prime House
    Park 2000 Heighington Lane
    DL5 6AR Business Park Newton Aycliffe
    County Durham
    171064410001
    ANTHONY, John Newsam
    Delegate Cottage
    Fellside
    NE46 1RB Hexham
    Northumberland
    Amministratore
    Delegate Cottage
    Fellside
    NE46 1RB Hexham
    Northumberland
    United KingdomBritish37840020002
    CONNELL, Valerie
    Prime House
    Park 2000 Heighington Lane
    DL5 6AR Business Park Newton Aycliffe
    County Durham
    Amministratore
    Prime House
    Park 2000 Heighington Lane
    DL5 6AR Business Park Newton Aycliffe
    County Durham
    EnglandBritish154038790001
    DRENNAN, Margaret
    22 Riverside
    South Church
    DL14 6XT Bishop Auckland
    County Durham
    Amministratore
    22 Riverside
    South Church
    DL14 6XT Bishop Auckland
    County Durham
    British62255560002
    DRENNAN, Margaret
    22 Riverside
    South Church
    DL14 6XT Bishop Auckland
    County Durham
    Amministratore
    22 Riverside
    South Church
    DL14 6XT Bishop Auckland
    County Durham
    British62255560002
    GREEN, Peter
    37 The Vale
    Elm Tree Farm
    TS19 0XL Stockton On Tees
    Cleveland
    Amministratore
    37 The Vale
    Elm Tree Farm
    TS19 0XL Stockton On Tees
    Cleveland
    EnglandBritish49133370001
    GROVES, Peter
    8 Limpton Gate
    Spitalfields
    TS15 9JA Yarm
    Cleveland
    Amministratore
    8 Limpton Gate
    Spitalfields
    TS15 9JA Yarm
    Cleveland
    United KingdomBritish37554590001
    JACKSON, Terence George
    Glengarry
    395 Thornaby Road Thornaby Village
    TS17 8QN Stockton On Tees
    Amministratore
    Glengarry
    395 Thornaby Road Thornaby Village
    TS17 8QN Stockton On Tees
    British74363830001
    LISTER, Richard Lyle
    38 Russell Street
    Waterhouses
    DH7 9AR Durham
    County Durham
    Amministratore
    38 Russell Street
    Waterhouses
    DH7 9AR Durham
    County Durham
    EnglandBritish122586320001
    METCALFE, Caroline Mary
    315 Durham Road
    NE9 5AH Gateshead
    Tyne & Wear
    Amministratore
    315 Durham Road
    NE9 5AH Gateshead
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish63638760001
    MORTIMER, Richard Thomas
    Prime House
    Park 2000 Heighington Lane
    DL5 6AR Business Park Newton Aycliffe
    County Durham
    Amministratore
    Prime House
    Park 2000 Heighington Lane
    DL5 6AR Business Park Newton Aycliffe
    County Durham
    EnglandBritish12349090001
    SMITH, Ian Paul
    The Ldoge
    The Stables
    PH4 4GD West Herrington
    Sunderland
    Amministratore
    The Ldoge
    The Stables
    PH4 4GD West Herrington
    Sunderland
    British62255580002
    TAYLOR, Antony John
    Prime House
    Park 2000 Heighington Lane
    DL5 6AR Business Park Newton Aycliffe
    County Durham
    Amministratore
    Prime House
    Park 2000 Heighington Lane
    DL5 6AR Business Park Newton Aycliffe
    County Durham
    EnglandBritish22432000001
    VASS, Christopher Gareth
    Prime House
    Park 2000 Heighington Lane
    DL5 6AR Business Park Newton Aycliffe
    County Durham
    Amministratore
    Prime House
    Park 2000 Heighington Lane
    DL5 6AR Business Park Newton Aycliffe
    County Durham
    United KingdomBritish14263320001

    HPM & ADDO LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 20 dic 2013
    Consegnato il 23 dic 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    2004 heidelberg CD74-5 + l-c five colour offset printing press with coating unit serial no. 450705. all the company’s present or future indebtedness to city business finance LTD whether solely or jointly with any other person or persons and whether as principle or surety or actually or contingently, together with any other costs, charges and legal expenses (on a full indemnity basis) charged or incurred by city business finance LTD; including those arising from city business finance LTD perfecting or enforcing or attempting to enforce the said charge or any other security (and it’s rights thereunder) held by city business finance LTD from time to time. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • City Business Finance LTD T/a Print Finance
    Transazioni
    • 23 dic 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 29 ott 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 06 dic 2013
    Consegnato il 06 dic 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    2001 muller martini presto saddle stitcher s/N.NN9452 Z0508690, apollo compensating stacker s/N.NN26099, 2004 heidelberg stahl RFH66 th/kh folder s/N.fh.habo.00259, 2004 heidelberg polar 92X guillotine s/N.7411215, 2002 heidelberg polar 115E s/N.7231426, 1981 heidelberg gto-52 press s/N.675427, 2001 norpak 2001 polyprocessor s/N.0006038.. All the company’s present or future indebtedness to city business finance LTD whether solely or jointly with any other person or persons and whether as principle or surety or actually or contingently, together with any other costs, charges and legal expenses (on a full indemnity basis) charged or incurred by city business finance LTD; including those arising from city business finance LTD perfecting or enforcing or attempting to enforce the said charge or any other security (and it’s rights thereunder) held by city business finance LTD from time to time.. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • City Business Finance LTD T/a Print Finance
    Transazioni
    • 06 dic 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 29 ott 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Chattel mortgage
    Creato il 12 apr 2012
    Consegnato il 14 apr 2012
    In corso
    Importo garantito
    £38,500 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Asset make - norpak model - 2001 polyprocessor chassis/serial number registration number - 0902062. asset make - polar- 2MODEL - guilotine model 92X chassis/serial number registration number - 7417215.
    Persone aventi diritto
    • Trustees of Hillprint LTD Directors Pension Scheme
    Transazioni
    • 14 apr 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Chattel mortgage
    Creato il 04 lug 2008
    Consegnato il 19 lug 2008
    In corso
    Importo garantito
    £30,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Muller martini presto saddle stitcher equipped with four compact feeders type 1551 folder feeder 1528 and belt delivery behind trimmer machine serial no KA508690.
    Persone aventi diritto
    • Richard Thomas Mortimer Peter Groves Margaret Drennan and North East Trustees Limited in Their Capacity as Trustees of Hillprint Limited Directors Pension Scheme
    Transazioni
    • 19 lug 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    All assets debenture
    Creato il 27 giu 2008
    Consegnato il 02 lug 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 02 lug 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 28 ott 1999
    Consegnato il 02 nov 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Gmac Commercial Credit Limited
    Transazioni
    • 02 nov 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed charge
    Creato il 16 giu 1998
    Consegnato il 20 giu 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of hire purchase agreement numbered 70/216/ils/17055652-2
    Brevi particolari
    First fixed charge over heidelberg mo press with print unit serial no 602031, muller martini 1509 saddle stitching line 6 stations 3 feeders type 1516 1522 trimmer & box delivery no;-99 20668 0853 stahl automatic folding machine T52-f/t 46782 199049 stahl folding machine T52-f 36999 157144 and polar mohr 115 guillotine 4531 443.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 20 giu 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 07 apr 1986
    Consegnato il 17 apr 1986
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold & l/hold property, bldgs and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery, bookdebts, goodwill uncalled capital undertakings and assets and all the property described in the schedule attached to doc M14 (see for full details).
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 17 apr 1986Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 07 apr 1986
    Consegnato il 09 apr 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £36,750.
    Brevi particolari
    Land and buildings at cockton hill bishop auckland durham.
    Persone aventi diritto
    • The County Council of Durham
    Transazioni
    • 09 apr 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 22 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 07 apr 1986
    Consegnato il 25 mag 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £41,215.25
    Brevi particolari
    F/Hold printing works at cockton hill bishop auckland co. Durham. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Thos. Hill Print Limited
    Transazioni
    • 25 mag 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 26 mar 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    HPM & ADDO LTD ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    31 ott 2014Inizio dell'amministrazione
    27 gen 2016Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Lee Van Lockwood
    9th Floor Bond Court
    LS1 2JZ Leeds
    Praticante
    9th Floor Bond Court
    LS1 2JZ Leeds
    Robert Alexander Henry Maxwell
    9th Floor Bond Court
    LS1 2JZ Leeds
    Praticante
    9th Floor Bond Court
    LS1 2JZ Leeds

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0