HADEN MACLELLAN LIMITED

HADEN MACLELLAN LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHADEN MACLELLAN LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01906781
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HADEN MACLELLAN LIMITED?

    • (7415) /

    Dove si trova HADEN MACLELLAN LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HADEN MACLELLAN LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HADEN GROUP LIMITED20 nov 198520 nov 1985
    MANUGOOD PLC17 mag 198517 mag 1985
    MANUGOOD LIMITED19 apr 198519 apr 1985

    Quali sono gli ultimi bilanci di HADEN MACLELLAN LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2003

    Quali sono le ultime deposizioni per HADEN MACLELLAN LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    16 pagineLIQ14

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 giu 2018

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 dic 2017

    6 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 giu 2017

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 dic 2016

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 giu 2016

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 dic 2015

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 giu 2015

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 dic 2014

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 giu 2014

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 dic 2013

    5 pagine4.68

    Ordinanza giudiziaria in materia di insolvenza

    Court order insolvency:court order replacement of liquidator
    35 pagineLIQ MISC OC

    Avviso di cessazione di funzioni come liquidatore volontario

    1 pagine4.40

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 giu 2013

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 dic 2012

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 giu 2012

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 dic 2011

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 giu 2011

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 dic 2010

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 giu 2010

    5 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da * 1 Snow Hill London EC1A 2DH* in data 14 lug 2010

    2 pagineAD01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 dic 2009

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 giu 2009

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 dic 2008

    5 pagine4.68

    Chi sono gli amministratori di HADEN MACLELLAN LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CULLIFORD, John David
    7 Cheveridge Close
    B91 3TT Solihull
    West Midlands
    Segretario
    7 Cheveridge Close
    B91 3TT Solihull
    West Midlands
    BritishChartered Accountant30684700001
    CULLIFORD, John David
    7 Cheveridge Close
    B91 3TT Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    7 Cheveridge Close
    B91 3TT Solihull
    West Midlands
    BritishDirector30684700001
    DARGATZ, Kenneth Carl
    4334 South Bat Drive
    Orchard Lake
    48323 Michigan
    Amministratore
    4334 South Bat Drive
    Orchard Lake
    48323 Michigan
    AmericanCompany Director68203270001
    TAYLOR, Keith Charles
    18 Stoneleigh Road
    B91 1DG Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    18 Stoneleigh Road
    B91 1DG Solihull
    West Midlands
    EnglandBritishDirector53569070001
    LYONS, Robert Eric
    9 Thetford Road
    KT3 5DN New Malden
    Surrey
    Segretario
    9 Thetford Road
    KT3 5DN New Malden
    Surrey
    British72020001
    PARKER, Michael Jonathon
    Ealy House
    Duntisbourne Abbots
    GL7 7JW Cirencester
    Gloucestershire
    Segretario
    Ealy House
    Duntisbourne Abbots
    GL7 7JW Cirencester
    Gloucestershire
    British121925520001
    GREGORY, Rodney William
    68 Station Road
    Hatton
    CV35 8XJ Warwick
    Warwickshire
    Amministratore
    68 Station Road
    Hatton
    CV35 8XJ Warwick
    Warwickshire
    BritishDirector12693600001
    HAWLEY, Melvyn
    Avenue Farm Old Hay Lane
    Dore
    S17 3AT Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    Avenue Farm Old Hay Lane
    Dore
    S17 3AT Sheffield
    South Yorkshire
    BritishCompany Director1451530001
    KIMBER, John Robert
    125 Beverley Gardens
    Pinkneys Green
    SL6 6ST Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    125 Beverley Gardens
    Pinkneys Green
    SL6 6ST Maidenhead
    Berkshire
    BritishAccountant70147560001
    LYONS, Robert Eric
    9 Thetford Road
    KT3 5DN New Malden
    Surrey
    Amministratore
    9 Thetford Road
    KT3 5DN New Malden
    Surrey
    BritishCompany Director72020001
    MAYHEAD, Clive Douglas
    The Grange
    Bagwell Lane
    RG27 8DB Winchfield
    Hampshire
    Amministratore
    The Grange
    Bagwell Lane
    RG27 8DB Winchfield
    Hampshire
    BritishCompany Director10567100002
    REED, Nigel George
    Northlands 22 Cotterstock Road
    Oundle
    PE8 5HA Peterborough
    Amministratore
    Northlands 22 Cotterstock Road
    Oundle
    PE8 5HA Peterborough
    United KingdomBritishAccountant98838870001
    SIMONIS, Peter George
    Cheyne Cottage 65 Royal Hospital Road
    SW3 4HS London
    Amministratore
    Cheyne Cottage 65 Royal Hospital Road
    SW3 4HS London
    BritishCompany Director13339350001
    TAYLOR, Richard Ernest
    Briars Court
    Chapel Road
    RH8 0SX Oxted
    Surrey
    Amministratore
    Briars Court
    Chapel Road
    RH8 0SX Oxted
    Surrey
    BritishCompany Director67170590001
    THOMPSON, Michael Andre
    Chestnut House
    Church Road West Hanningfield
    CM2 8UJ Chelmsford
    Essex
    Amministratore
    Chestnut House
    Church Road West Hanningfield
    CM2 8UJ Chelmsford
    Essex
    EnglandBritishDirector117868900001

    HADEN MACLELLAN LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 21 apr 1994
    Consegnato il 10 mag 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 10 mag 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security interest agreement
    Creato il 21 apr 1994
    Consegnato il 10 mag 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All monies standing to the credit of the company with the royal bank of scotland (guernsey) limited.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 10 mag 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental legal charge
    Creato il 12 dic 1990
    Consegnato il 14 dic 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the debenture dated 12/1/89.
    Brevi particolari
    2-14 (even nos.) rosebery st and 535-545 (odd nos.) buxton rd and land & buildings on the north east side of buxton rd, stockport cheshire. T/no. Gm 103408.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC.
    Transazioni
    • 14 dic 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 15 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 12 gen 1989
    Consegnato il 23 gen 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 4TH & 5TH floor swan office centre, coventry office road, yardley, birmingham T.no. Wm 185644 l/h unit 6 & offices, argyle way industrial estate, argyle road, stevenage hertfordshire (T. nos hd 136675 & hd 136676) and/or the proceeds of sale thereof together with all buildings, fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery (please see form 395 for full details of l/h property). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 23 gen 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 15 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 ago 1988
    Consegnato il 25 ago 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    4TH floor, york towers, york road, leeds. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 25 ago 1988Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 12 nov 1987
    Consegnato il 24 nov 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Basement ground and first to eighth floors somerton house, 141, euston road, london NW1 title no - ln 248272.. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 24 nov 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 15 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 30 ott 1987
    Consegnato il 10 nov 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 10 nov 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 15 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 ago 1986
    Consegnato il 19 ago 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee arising out of a letter of credit of even date.
    Brevi particolari
    United states treasury notes and all dividends or interest thereon, and all rights, moneys and entitlements arising therefrom.
    Persone aventi diritto
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York
    Transazioni
    • 19 ago 1986Registrazione di un'ipoteca
    Deed of charge
    Creato il 19 lug 1985
    Consegnato il 02 ago 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a deed of guarantee d/d 19 july 1985 and this charge
    Brevi particolari
    All the interest beneficial and legal, which the chargor may from time to time have in any shares or the right to allotment of securities together with all dividends, distributions or other income payable or made in respect of such securities.
    Persone aventi diritto
    • The Prudential Insurance Company of America
    Transazioni
    • 02 ago 1985Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 19 lug 1985
    Consegnato il 31 lug 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee including moneys due under the terms of an agreement and a guarantee of even date.
    Brevi particolari
    All distributions made or payable in respect of the interest of the company in the shares of securities of haden PLC. (See doc no M32).
    Persone aventi diritto
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York.
    Transazioni
    • 31 lug 1985Registrazione di un'ipoteca

    HADEN MACLELLAN LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    26 feb 2019Data di scioglimento
    28 giu 2006Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    David Alan Rolph
    Moore Stephens Llp
    1 Snow Hill
    EC1A 2DH London
    Praticante
    Moore Stephens Llp
    1 Snow Hill
    EC1A 2DH London
    Jeremy Mark Willmont
    Moore Stephens
    1 Snow Hill
    EC1A 2DH London
    Praticante
    Moore Stephens
    1 Snow Hill
    EC1A 2DH London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0