TULLETT PREBON (UK) LIMITED

TULLETT PREBON (UK) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTULLETT PREBON (UK) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01908771
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TULLETT PREBON (UK) LIMITED?

    • Amministrazione dei mercati finanziari (66110) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova TULLETT PREBON (UK) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    135 Bishopsgate
    EC2M 3TP London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TULLETT PREBON (UK) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PREBON MARSHALL YAMANE (UK) LIMITED01 giu 199901 giu 1999
    PREBON YAMANE (UK) LIMITED31 lug 199231 lug 1992
    BABCOCK FULTON PREBON LIMITED10 apr 199010 apr 1990
    BABCOCK & BROWN (KW) LIMITED15 giu 198915 giu 1989
    BABCOCK & BROWN (MONEY MARKET) LIMITED16 lug 198616 lug 1986
    MONEY MARKET AGENCIES LIMITED16 gen 198616 gen 1986
    PRECIS (456) LIMITED26 apr 198526 apr 1985

    Quali sono gli ultimi bilanci di TULLETT PREBON (UK) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per TULLETT PREBON (UK) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    7 pagineLIQ13

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 10 dic 2021

    LRESSP

    Dichiarazione di conformità presentata il 24 nov 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 ott 2021 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 dic 2020 al 30 dic 2020

    1 pagineAA01

    Indirizzo della sede legale modificato da Floor 2 155 Bishopsgate London EC2M 3TQ England a 135 Bishopsgate London EC2M 3TP in data 07 mag 2021

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

    1 pagineAA

    Stato del capitale al 04 dic 2020

    • Capitale: GBP 0.10
    3 pagineSH19

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 ott 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Cancel share prem a/c 22/04/2020
    RES13

    Risoluzioni

    Resolutions
    26 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10
    capital

    Risoluzione di rimozione dei diritti di prelazione

    RES11
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 ott 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Andrew Ren-Yiing Chen come amministratore in data 23 ott 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Paul James Ashley come amministratore in data 27 set 2019

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    1 pagineAA

    Modifica dei dettagli di Prebon Yamane International Limited come persona con controllo significativo il 31 dic 2018

    2 paginePSC05

    Indirizzo della sede legale modificato da Tower 42 Level 37 25 Old Broad Street London EC2N 1HQ a Floor 2 155 Bishopsgate London EC2M 3TQ in data 31 dic 2018

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 16 ott 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    1 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Robin James Stewart il 17 lug 2018

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di TULLETT PREBON (UK) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CHEN, Andrew Ren-Yiing
    EC2M 3TP London
    135 Bishopsgate
    England
    Amministratore
    EC2M 3TP London
    135 Bishopsgate
    England
    EnglandBritish225251990001
    STEWART, Robin James
    EC2M 3TP London
    135 Bishopsgate
    England
    Amministratore
    EC2M 3TP London
    135 Bishopsgate
    England
    EnglandBritish161299680001
    ANKERS, Peter
    104 Meridian Place
    Marsh Wall
    E14 9FF London
    Segretario
    104 Meridian Place
    Marsh Wall
    E14 9FF London
    British56413750001
    ANKERS, Peter
    104 Meridian Place
    Marsh Wall
    E14 9FF London
    Segretario
    104 Meridian Place
    Marsh Wall
    E14 9FF London
    British56413750001
    BRILL, Tiffany Fern
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    Segretario
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    218151560001
    CHALLEN, Nicola
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    Segretario
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    Other119903660002
    DE FREITAS, Maria Teresa
    Flat 1 47 Lloyd Baker Street
    WC1X 9AA London
    Segretario
    Flat 1 47 Lloyd Baker Street
    WC1X 9AA London
    British95153090009
    DEARLOVE, Juliet Mary
    Churchgate House
    15 Churchgate Street
    CM17 0JT Old Harlow
    Essex
    Segretario
    Churchgate House
    15 Churchgate Street
    CM17 0JT Old Harlow
    Essex
    British72784040001
    DYER BARTLETT, Diana
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    Segretario
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    177123560001
    HOSKINS, Justin Wilbert
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    Segretario
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    171912470001
    MAYHILL, Geoffrey Ronald
    1 The Avenue
    Kew
    TW9 2AL Richmond
    Surrey
    Segretario
    1 The Avenue
    Kew
    TW9 2AL Richmond
    Surrey
    British812670009
    PEEL, Alistair Charles
    Deep Acres
    HP6 5NX Amersham
    6
    Bucks
    England
    Segretario
    Deep Acres
    HP6 5NX Amersham
    6
    Bucks
    England
    British90844500002
    SHAW, Gary Allan
    63a Cambray Road
    SW12 0ER London
    Segretario
    63a Cambray Road
    SW12 0ER London
    British67579830001
    DAVID VENUS & COMPANY LLP
    Hersham Road
    KT12 1RZ Walton-On-Thames
    42-50
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Hersham Road
    KT12 1RZ Walton-On-Thames
    42-50
    Surrey
    United Kingdom
    Forma giuridicaLIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
    Tipo di documento di identificazioneExtra-SEE
    Autorità legaleCOMPANIES ACT 2006
    Numero di registrazioneOC309455
    131429630001
    ASHLEY, Paul James
    Bishopsgate
    EC2M 3TQ London
    155
    United Kingdom
    Amministratore
    Bishopsgate
    EC2M 3TQ London
    155
    United Kingdom
    EnglandBritish332150410001
    BATEMAN, Richard Harrison
    Mabbs Hill Farmhouse
    Stonegate
    TN5 7EF Wadhurst
    East Sussex
    Amministratore
    Mabbs Hill Farmhouse
    Stonegate
    TN5 7EF Wadhurst
    East Sussex
    British1478010001
    BOLTON, Marcus Peregrine
    High Barn
    Sutton Place, Abinger Hammer
    RH5 6RP Dorking
    Surrey
    Amministratore
    High Barn
    Sutton Place, Abinger Hammer
    RH5 6RP Dorking
    Surrey
    EnglandBritish84102400001
    BRIGHT, Steven Lee
    35 Forest Way
    IG8 0QB Woodford Green
    Essex
    Amministratore
    35 Forest Way
    IG8 0QB Woodford Green
    Essex
    British104678480001
    BUIK, David Barlow
    22 Regents Park Road
    NW1 7TX London
    Amministratore
    22 Regents Park Road
    NW1 7TX London
    Canadian2294590001
    BURNETT, Michael Arthur
    65 Ellerby Street
    SW6 6EU London
    Amministratore
    65 Ellerby Street
    SW6 6EU London
    British32574310001
    CALVERT, John Michael
    Brick House Farm
    Cherry Street, Duton Hill
    CM6 2EE Dunmow
    Essex
    Amministratore
    Brick House Farm
    Cherry Street, Duton Hill
    CM6 2EE Dunmow
    Essex
    British68355150001
    COMPAS, Felix George
    265 Edgwarebury Lane
    HA8 8QL Edgware
    Middlesex
    Amministratore
    265 Edgwarebury Lane
    HA8 8QL Edgware
    Middlesex
    British32574320002
    CORKER, Stephen Roger
    10 Monmouth Road
    W2 5SB London
    Amministratore
    10 Monmouth Road
    W2 5SB London
    United KingdomBritish43964780001
    COSTELLO, Kevin
    91 Free Trade Wharf 340 The Highway
    E1 9ET London
    Amministratore
    91 Free Trade Wharf 340 The Highway
    E1 9ET London
    British32574330002
    DAWES, Cindy Jane
    Brook House
    Torland Drive
    KT22 0JA Oxshott
    Surrey
    Amministratore
    Brook House
    Torland Drive
    KT22 0JA Oxshott
    Surrey
    United KingdomUnited Kingdom74822120001
    DUCKWORTH, Stephen Charles
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    Amministratore
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    EnglandBritish69519860001
    DUNKLEY, Paul Simon
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    Amministratore
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    EnglandBritish138694990001
    GARTHWAITE, Ian Dudley
    Flat 4 4 Addison Crescent
    W14 8JP London
    Amministratore
    Flat 4 4 Addison Crescent
    W14 8JP London
    British32034890001
    GIORDANO, Anthony
    Apartment 204
    Cardomom Building 31 Shad Thames
    SE1 2YR London
    Amministratore
    Apartment 204
    Cardomom Building 31 Shad Thames
    SE1 2YR London
    British32574350001
    GOLDBERG, David Howard
    47 Ventnor Drive
    N20 8BT London
    Amministratore
    47 Ventnor Drive
    N20 8BT London
    British67412280001
    GRANAT, Ian James
    Wychbold
    Church Road Tattingstone
    IP9 2NA Ipswich
    Suffolk
    Amministratore
    Wychbold
    Church Road Tattingstone
    IP9 2NA Ipswich
    Suffolk
    British104761410001
    HARNETT, Geoffrey Victor
    2d Thorney Crescent
    Morgans Walk
    SW11 3TR London
    Amministratore
    2d Thorney Crescent
    Morgans Walk
    SW11 3TR London
    British56333090001
    HAWKINS, James Patrick Fitzgerald
    Gosias Grange
    Thaxted Road Wimbish
    CB10 2UZ Saffron Walden
    Essex
    Amministratore
    Gosias Grange
    Thaxted Road Wimbish
    CB10 2UZ Saffron Walden
    Essex
    British32574370001
    HEATH, Jeremy Richard
    Ruffroof
    40 Lucastes Avenue
    RH16 1JY Haywards Heath
    West Sussex
    Amministratore
    Ruffroof
    40 Lucastes Avenue
    RH16 1JY Haywards Heath
    West Sussex
    United KingdomBritish32574380001
    HOCKEY, Joseph Max
    3 South Terrace
    High Street
    DA4 0DF Farningham
    Kent
    Amministratore
    3 South Terrace
    High Street
    DA4 0DF Farningham
    Kent
    British78982470001

    Chi sono le persone con controllo significativo di TULLETT PREBON (UK) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Prebon Yamane International Limited
    155 Bishopsgate
    EC2M 3TQ London
    Floor 2
    England
    06 apr 2016
    155 Bishopsgate
    EC2M 3TQ London
    Floor 2
    England
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House (England And Wales)
    Numero di registrazione2619854
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    TULLETT PREBON (UK) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Supplemental security agreement
    Creato il 12 gen 2009
    Consegnato il 15 gen 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies not exceeding £12,500,000.00 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first floating charge all assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Trustees of the Tullett Liberty Pension Scheme (The Trustees)
    Transazioni
    • 15 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Supplemental security agreement
    Creato il 12 gen 2009
    Consegnato il 15 gen 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies not exceeding £12,500,000.00 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first floating charge all assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Trustees of Prebon Yamane (Ex K-W) Pension Scheme (the Trustees)
    Transazioni
    • 15 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of novation and amendment
    Creato il 15 nov 2007
    Consegnato il 20 nov 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from tullet prebon group limited under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Floating charge all its assets on the terms of the security agreement as amended by the deed,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Trustees of the Prebon Yamane (Ex K-W) Pension Scheme (Trustees)
    Transazioni
    • 20 nov 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Security agreement
    Creato il 29 gen 2007
    Consegnato il 16 feb 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and the principal employer not exceeding £12,500,000 under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first floating charge all assets,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Trustees of the Tullett Liberty Pension Scheme
    Transazioni
    • 16 feb 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Security agreement
    Creato il 29 gen 2007
    Consegnato il 13 feb 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the principal employer to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    First floating charge all its assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Trustees of the Prebon Yamane (Ex K-W) Pension Scheme
    Transazioni
    • 13 feb 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Terms of business agreement
    Creato il 06 mar 2001
    Consegnato il 27 mar 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement
    Brevi particolari
    By way of first, fixed charge and pledge over all securities, documents of or entering title to property, cash or other assets of any nature held by or subject to the control of fcl by way of deposit or margin (or any nominee or custodian of fcl) for the account of the client (including without limitation, the benefit of all contractual rights and obligations and any proceeds of sale and any securities or other assets which fcl has agreed to hold as custodian) and by way of general lien and right of set-off.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Fortis Clearing London Limited
    Transazioni
    • 27 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 giu 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 17 gen 1986
    Consegnato il 20 gen 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts. (See doc no M17).
    Persone aventi diritto
    • Aidamoor Limited
    Transazioni
    • 20 gen 1986Registrazione di un'ipoteca

    TULLETT PREBON (UK) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    10 dic 2021Inizio della liquidazione
    14 mar 2023Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Laura May Waters
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Steven Sherry
    Pricewaterhousecoopers Llp, 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp, 7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0