FRASERS FB (UK) DEVELOPMENTS LIMITED

FRASERS FB (UK) DEVELOPMENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàFRASERS FB (UK) DEVELOPMENTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01909445
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di FRASERS FB (UK) DEVELOPMENTS LIMITED?

    • (7011) /

    Dove si trova FRASERS FB (UK) DEVELOPMENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    81 Cromwell Road
    London
    SW7 5BW
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di FRASERS FB (UK) DEVELOPMENTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    FAIRBRIAR DEVELOPMENTS LIMITED03 giu 199603 giu 1996
    FAIRBRIAR INVESTMENTS LIMITED04 set 198504 set 1985
    SWANMIGHT LIMITED29 apr 198529 apr 1985

    Quali sono gli ultimi bilanci di FRASERS FB (UK) DEVELOPMENTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per FRASERS FB (UK) DEVELOPMENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Cessazione della carica di Valsec Company Secretarial Services Limited come segretario

    1 pagineTM02

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 22 mag 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 giu 2011

    Stato del capitale al 16 giu 2011

    • Capitale: GBP 101
    SH01

    Bilancio redatto al 30 set 2010

    11 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Removal of share capital 23/12/2010
    RES13

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Sect 551 ca 2006 23/12/2010
    RES13

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed fairbriar developments LIMITED\certificate issued on 19/01/11
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name19 gen 2011

    Avviso di cambio di nome"

    CONNOT

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 23 dic 2010

    RES15

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 23 dic 2010

    • Capitale: GBP 100
    3 pagineSH01

    Cessazione della carica di Valad Secretarial Services Limited come segretario

    2 pagineTM02

    Nomina di Valsec Company Secretarial Services Limited come segretario

    3 pagineAP04

    Bilancio redatto al 30 set 2009

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 22 mag 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Valad Secretarial Services Limited il 22 mag 2010

    2 pagineCH04

    Dettagli del direttore cambiati per Dr Stanley Swee Han Quek il 01 ott 2009

    3 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Simon John Patrick Lear il 01 ott 2009

    3 pagineCH01

    Bilancio redatto al 30 set 2008

    13 pagineAA

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    2 pagine288c

    Bilancio redatto al 30 set 2007

    12 pagineAA

    legacy

    2 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di FRASERS FB (UK) DEVELOPMENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    NG, Seng Khoon
    101 Coldershaw Road
    W13 9DU London
    Segretario
    101 Coldershaw Road
    W13 9DU London
    British90211410001
    LEAR, Simon John Patrick
    Cromwell Road
    SW7 5BW London
    81
    Amministratore
    Cromwell Road
    SW7 5BW London
    81
    United KingdomBritish138750860001
    QUEK, Stanley Swee Han, Dr
    Cromwell Road
    SW7 5BW London
    81
    Amministratore
    Cromwell Road
    SW7 5BW London
    81
    SingaporeSingaporean123800250001
    BALCHIN, Mark Nicholas
    6 Fleming Close
    GU14 8BT Farnborough
    Hampshire
    Segretario
    6 Fleming Close
    GU14 8BT Farnborough
    Hampshire
    British812680001
    BALCHIN, Mark Nicholas
    6 Fleming Close
    GU14 8BT Farnborough
    Hampshire
    Segretario
    6 Fleming Close
    GU14 8BT Farnborough
    Hampshire
    British812680001
    STAFFORD, Rodney Frank John
    8a The Glade
    KT22 9TH Fetcham
    Surrey
    Segretario
    8a The Glade
    KT22 9TH Fetcham
    Surrey
    British34094600001
    WRIGHT, Gordon Nicholson
    8 Mossway
    HP9 1TG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Segretario
    8 Mossway
    HP9 1TG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British38011750001
    VALAD SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Melville Street
    EH3 7NS Edinburgh
    4a
    Scotland
    Segretario
    Melville Street
    EH3 7NS Edinburgh
    4a
    Scotland
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazioneSC219311
    133355520001
    VALSEC COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Segretario
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione7307485
    154199770001
    BALCHIN, Mark Nicholas
    6 Fleming Close
    GU14 8BT Farnborough
    Hampshire
    Amministratore
    6 Fleming Close
    GU14 8BT Farnborough
    Hampshire
    UkBritish812680001
    COOMBES, William Frederick
    Windles
    Bangor Road North
    LL57 Ivor Heath
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Windles
    Bangor Road North
    LL57 Ivor Heath
    Buckinghamshire
    British18604620001
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Amministratore
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritish35117250001
    HANKINSON, Derek William
    Foxlea Manor
    Dorneywood Road
    SL1 8PS Burnham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Foxlea Manor
    Dorneywood Road
    SL1 8PS Burnham
    Buckinghamshire
    British822380001
    MCBRIDE, Stephen Paul
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    Amministratore
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    United KingdomBritish56953000002
    MCCABE, Kevin Charles
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    British109250000001
    NESBITT, Peter Victor
    76 Reedham Drive
    CR8 4DS Purley
    Surrey
    Amministratore
    76 Reedham Drive
    CR8 4DS Purley
    Surrey
    British27564990001
    PAIRMAN, Lynda Annette
    Ballagawne Cottage Ballagawne Road
    Colby
    IM9 4AZ Castletown
    Isle Of Man
    Amministratore
    Ballagawne Cottage Ballagawne Road
    Colby
    IM9 4AZ Castletown
    Isle Of Man
    British132910006
    VAN REYK, Philip
    Cherry Tree House
    Chequers Lane
    RG27 0NT Eversley
    Hampshire
    Amministratore
    Cherry Tree House
    Chequers Lane
    RG27 0NT Eversley
    Hampshire
    EnglandBritish76943220003
    WOOD-PENN, Richard Cecil
    3 Glebe Road
    Cogenhoe
    NN7 1NR Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    3 Glebe Road
    Cogenhoe
    NN7 1NR Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritish99981260001
    WRIGHT, Gordon Nicholson
    8 Mossway
    HP9 1TG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    8 Mossway
    HP9 1TG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British38011750001

    FRASERS FB (UK) DEVELOPMENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 19 ago 1996
    Consegnato il 21 ago 1996
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property being part of the land comprised in title no. K555760. fixed charges on all buildings and other structures on the property, any goodwill, all plant machinery and other items affixed to the property and the proceeds of any claim made under any insurance policy relating to the property. Assignment of the rental sums. Floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or at the property.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 21 ago 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    Charge
    Creato il 31 gen 1996
    Consegnato il 02 feb 1996
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the beneficial interest in relation to the f/h property situate at and k/a home farm home farm lane tunbridge wells kent t/n k 446173.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 02 feb 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 29 giu 1993
    Consegnato il 08 lug 1993
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 08 lug 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 18 giu 1990
    Consegnato il 20 giu 1990
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 20 giu 1990Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0