FRANK HOULGATE DECORATORS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | FRANK HOULGATE DECORATORS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01910151 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di FRANK HOULGATE DECORATORS LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova FRANK HOULGATE DECORATORS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | c/o CLC GROUP LTD Unit 2 Northbrook Industrial Estate Vincent Avenue SO16 6PB Southampton |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di FRANK HOULGATE DECORATORS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2014 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per FRANK HOULGATE DECORATORS LIMITED?
| Bilancio annuale |
|
|---|
Quali sono le ultime deposizioni per FRANK HOULGATE DECORATORS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Nomina di Mr Richard Simon Armitage come amministratore in data 04 mar 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Malcolm John White come amministratore in data 04 mar 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Malcolm John White come segretario in data 04 mar 2016 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 17 ott 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2014 | 12 pagine | AA | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da C/O C/O Clc Group Ltd Unit 2 Vincent Avenue Southampton Hampshire SO16 6PQ a C/O Clc Group Ltd Unit 2 Northbrook Industrial Estate Vincent Avenue Southampton SO16 6PB in data 05 mag 2015 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 3 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 17 ott 2014 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2013 | 10 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 17 ott 2013 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2012 | 12 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 17 ott 2012 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2011 | 11 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 17 ott 2011 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2010 | 13 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 17 ott 2010 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Malcolm John White il 01 gen 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2009 | 15 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 17 ott 2009 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * C/O Clc Group Plc, Vincent Avenue, Southampton Hampshire SO16 6PQ* in data 19 ott 2009 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Peter Benjamin Thomas Armitage il 01 ott 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Malcolm John White il 01 ott 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di FRANK HOULGATE DECORATORS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMITAGE, Peter Benjamin Thomas | Amministratore | c/o Clc Group Ltd Northbrook Industrial Estate Vincent Avenue SO16 6PB Southampton Unit 2 England | England | British | 72943340001 | |||||
| ARMITAGE, Richard Simon | Amministratore | c/o Clc Group Ltd Northbrook Industrial Estate Vincent Avenue SO16 6PB Southampton Unit 2 | England | British | 146747640001 | |||||
| EAVES, Terence Joseph | Segretario | 86 Spencer Road PO33 3AH Ryde Isle Of Wight | British | 125796830001 | ||||||
| HOULGATE, Julie | Segretario | The Elms Farrer Lane Oulton LS26 8JW Leeds West Yorkshire | British | 1504990001 | ||||||
| ILES, Mark Willmott | Segretario | 209 Cutbush Lane Townhill Park SO18 2GF Southampton Hampshire | British | 23509110002 | ||||||
| WHITE, Malcolm John | Segretario | c/o Clc Group Ltd Northbrook Industrial Estate Vincent Avenue SO16 6PB Southampton Unit 2 England | British | 110398690001 | ||||||
| BELL, Anthony Gary | Amministratore | 9 The Crescent Guiseley LS20 8JY Leeds | British | 39874660001 | ||||||
| EAVES, Terence Joseph | Amministratore | 86 Spencer Road PO33 3AH Ryde Isle Of Wight | England | British | 125796830001 | |||||
| HOULGATE, Frank | Amministratore | The Elms Farrer Lane LS26 8JW Oulton Leeds | British | 17119780001 | ||||||
| HOULGATE, Julie | Amministratore | The Elms Farrer Lane Oulton LS26 8JW Leeds West Yorkshire | British | 1504990001 | ||||||
| ILES, Mark Willmott | Amministratore | 209 Cutbush Lane Townhill Park SO18 2GF Southampton Hampshire | United Kingdom | British | 23509110002 | |||||
| WHITE, Malcolm John | Amministratore | c/o Clc Group Ltd Northbrook Industrial Estate Vincent Avenue SO16 6PB Southampton Unit 2 England | United Kingdom | British | 110398690002 |
FRANK HOULGATE DECORATORS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee & debenture | Creato il 01 dic 2004 Consegnato il 21 dic 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 29 mag 1992 Consegnato il 04 giu 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 2 beza street hunslet leeds west yorkshire title no. Wyk 56896 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 06 nov 1989 Consegnato il 16 nov 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Orchard house, 1 elmfield farrar lane, oulton title no wyk 186133 and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0