COVENTRY NEWSPAPERS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | COVENTRY NEWSPAPERS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01917810 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di COVENTRY NEWSPAPERS LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova COVENTRY NEWSPAPERS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | One Canada Square Canary Wharf E14 5AP London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di COVENTRY NEWSPAPERS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| PROPERTY BUREAU LIMITED(THE) | 02 lug 1985 | 02 lug 1985 |
| MARCHDREW LIMITED | 30 mag 1985 | 30 mag 1985 |
Quali sono gli ultimi bilanci di COVENTRY NEWSPAPERS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 27 dic 2020 |
Quali sono le ultime deposizioni per COVENTRY NEWSPAPERS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 02 mar 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 27 dic 2020 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 02 mar 2021 con aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 29 dic 2019 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 02 mar 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 dic 2018 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr James Joseph Mullen come amministratore in data 16 ago 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Simon Richard Fox come amministratore in data 16 ago 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformit à presentata il 01 mar 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr Simon Jeremy Ian Fuller come amministratore in data 01 mar 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Vijay Lakhman Vaghela come amministratore in data 01 mar 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per T M Directors Limited il 04 mag 2018 | 1 pagine | CH02 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per T M Secretaries Limited il 04 mag 2018 | 1 pagine | CH04 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 mar 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 01 gen 2017 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 mar 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 27 dic 2015 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 mar 2016 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 28 dic 2014 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 mar 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Chi sono gli amministratori di COVENTRY NEWSPAPERS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REACH SECRETARIES LIMITED | Segretario | Canada Square Canary Wharf E14 5AP London One United Kingdom |
| 82853180002 | ||||||||||
| FULLER, Simon Jeremy Ian | Amministratore | Canary Wharf E14 5AP London One Canada Square United Kingdom | England | British | 181763320002 | |||||||||
| MULLEN, James Joseph | Amministratore | One Canada Square Canary Wharf E14 5AP London | England | Scottish | 91567460002 | |||||||||
| REACH DIRECTORS LIMITED | Amministratore | Canada Square Canary Wharf E14 5AP London One United Kingdom |
| 82853130002 | ||||||||||
| APPLETON, David Neil | Segretario | 2 Colledge Close Brinklow CV23 0NT Coventry Warwickshire | British | 52329620001 | ||||||||||
| PAYNE, Carolyn Sarah | Segretario | 37 Whitecroft Road B26 3RD Birmingham | British | 44120670001 | ||||||||||
| VICKERS, Paul Andrew | Segretario | 10 Pembroke Villas The Green TW9 1QF Richmond-Upon-Thames Surrey | British | 146096300001 | ||||||||||
| WHITEHOUSE, John | Segretario | 231 Streetsbrook Road B91 1HE Solihull West Midlands | British | 39146610002 | ||||||||||
| AITKEN, Geraldine | Amministratore | 1 Clydesdale Court Kings Lane CV37 0LZ Snitterfield Warwickshire | British | 73882830001 | ||||||||||
| ALLWOOD, Charles John | Amministratore | Park Farm The Twist Wigginton HP23 6DU Tring Hertfordshire | England | British | 35681240003 | |||||||||
| APPLETON, David Neil | Amministratore | 2 Colledge Close Brinklow CV23 0NT Coventry Warwickshire | British | 52329620001 | ||||||||||
| BURTON, Royston Walter | Amministratore | 89 Corbett Road Hollywood B47 5LT Birmingham | British | 44120740001 | ||||||||||
| DAY, Philip Julian | Amministratore | 42 Heath Croft Road B75 6RW Sutton Coldfield West Midlands | British | 14092200001 | ||||||||||
| EWING, Margaret | Amministratore | Maraval Hamm Court KT13 8YG Weybridge Surrey | British | 68009020001 | ||||||||||
| FOX, Simon Richard | Amministratore | One Canada Square Canary Wharf E14 5AP London | United Kingdom | British | 58101280002 | |||||||||
| HADDOW, Andrew David Charles | Amministratore | 68 Pinewoods Avenue Hagley DY9 0JF Stourbridge West Midlands | British | 54060210001 | ||||||||||
| HUTCHBY, Michael | Amministratore | 26 Sunnyhill LE10 2SB Hinckley Leicestershire | British | 61630410001 | ||||||||||
| KIRBY, Alan Alwyne | Amministratore | 48 Bawnmore Road Bilton CV22 7QW Rugby Warwickshire | United Kingdom | British | 148157770001 | |||||||||
| LESTER, Vernon David Walter | Amministratore | 26 East Mount Road YO2 2BD York North Yorkshire | British | 51985920001 | ||||||||||
| MASON, Daniel Cavner | Amministratore | 72 Church Road Erdington B24 9BD Birmingham | British | 38365090002 | ||||||||||
| OAKLEY, Christopher John | Amministratore | Random Wood Ling Lane, Scarcroft LS14 3HY Leeds West Yorkshire | British | 68410390001 | ||||||||||
| PAYNE, Carolyn Sarah | Amministratore | 37 Whitecroft Road B26 3RD Birmingham | British | 44120670001 | ||||||||||
| POWLES, Sharon Susan | Amministratore | Thurleycroft Common Lane, Mappleborough Green B80 7DP Studley Warwickshire | British | 108225810001 | ||||||||||
| VAGHELA, Vijay Kumar Lakhman Meghji | Amministratore | One Canada Square Canary Wharf E14 5AP London | England | British | 60412210002 | |||||||||
| VICKERS, Paul Andrew | Amministratore | One Canada Square Canary Wharf E14 5AP London | England | British | 146096300001 | |||||||||
| VICKERS, Paul Andrew | Amministratore | 10 Pembroke Villas The Green TW9 1QF Richmond-Upon-Thames Surrey | England | British | 146096300001 | |||||||||
| WELLS, Stephen David | Amministratore | 7 Jacksons Meadow Bidford On Avon B50 4HQ Alcester Warwickshire | British | 53321720002 | ||||||||||
| WEST, Denise May | Amministratore | 642 Streetsbrook Road B91 1LB Solihull West Midlands | British | 52930570001 | ||||||||||
| WHITEHOUSE, John | Amministratore | 231 Streetsbrook Road B91 1HE Solihull West Midlands | British | 39146610002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di COVENTRY NEWSPAPERS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Hinckley Times Limited | 06 apr 2016 | Canary Wharf E14 5AP London One Canada Square England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
COVENTRY NEWSPAPERS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 16 mar 1990 Consegnato il 20 mar 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys due to the banks or any of them or standard chartered bank for itself and as agent and trustee for the banks by midland newspapers limited under the facility agreement dated 2/3/90 or by the company pursuant to a guarantee dated 16/3/90 made in favour of the agent or by midland or any guarantor (as defined) under any financing documents (as defined) | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital building fixtures fixed plant and machinery (for full details see form 395) see 395 for details. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0