ABBEY NATIONAL BUSINESS OFFICE EQUIPMENT LEASING LIMITED
Panoramica
| Nome della società | ABBEY NATIONAL BUSINESS OFFICE EQUIPMENT LEASING LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Liquidazione |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01918522 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ABBEY NATIONAL BUSINESS OFFICE EQUIPMENT LEASING LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova ABBEY NATIONAL BUSINESS OFFICE EQUIPMENT LEASING LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Griffins Suite 011 Unit2 94a Wycliffe Road NN1 5JF Northampton |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ABBEY NATIONAL BUSINESS OFFICE EQUIPMENT LEASING LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| FIRST NATIONAL OFFICE EQUIPMENT LEASING LIMITED | 30 dic 1998 | 30 dic 1998 |
| LOMBARD OFFICE EQUIPMENT LEASING LIMITED | 31 lug 1985 | 31 lug 1985 |
| TRUMPVIEW LIMITED | 03 giu 1985 | 03 giu 1985 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ABBEY NATIONAL BUSINESS OFFICE EQUIPMENT LEASING LIMITED?
| Scaduto | No |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 31 dic 2025 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 set 2026 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2024 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per ABBEY NATIONAL BUSINESS OFFICE EQUIPMENT LEASING LIMITED?
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 01 mar 2026 |
|---|---|
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 15 mar 2026 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 01 mar 2025 |
| Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per ABBEY NATIONAL BUSINESS OFFICE EQUIPMENT LEASING LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indirizzo della sede legale modificato da 2 Triton Square Regents Place London NW1 3AN a Griffins Suite 011 Unit2 94a Wycliffe Road Northampton NN1 5JF in data 19 gen 2026 | 3 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 2 Triton Square Regent's Place London NW1 3AN a 2 Triton Square Regents Place London NW1 3AN in data 06 gen 2026 | 3 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 6 pagine | LIQ01 | ||||||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2024 | 4 pagine | AA | ||||||||||||||
Nomina di Ms Rosamund Martha Rule come amministratore in data 17 apr 2025 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 mar 2025 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Nameeta Pai come amministratore in data 22 nov 2024 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2023 | 4 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 mar 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Memorandum e Statuto | 32 pagine | MA | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Dichiarazione degli oggetti sociali | 2 pagine | CC04 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Stephen David Affleck come amministratore in data 08 ago 2023 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Lee Thomas Grant come amministratore in data 08 ago 2023 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2022 | 4 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 mar 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2021 | 4 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 mar 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Stephen David Affleck come amministratore in data 31 dic 2021 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Rachel Jane Morrison come amministratore in data 31 dic 2021 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 29 ott 2021 con aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020 | 4 pagine | AA | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Gavin Raymond White come amministratore in data 23 lug 2021 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di ABBEY NATIONAL BUSINESS OFFICE EQUIPMENT LEASING LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANDER SECRETARIAT SERVICES LIMITED | Segretario | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 United Kingdom |
| 171739990001 | ||||||||||
| GRANT, Lee Thomas | Amministratore | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 United Kingdom | United Kingdom | British | 312322560001 | |||||||||
| RULE, Rosamund Martha | Amministratore | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 United Kingdom | United Kingdom | British | 297165190001 | |||||||||
| BROMLEY, Heidi Elizabeth | Segretario | 40 Hitchings Way RH2 8EW Reigate Surrey | British | 33605720002 | ||||||||||
| LEWIS, Derek John | Segretario | 7 The Adelaide Higham ME3 7LU Rochester Kent | British | 34423910001 | ||||||||||
| STRANAGHAN, Patricia Ann | Segretario | Flat 1 25 Somers Road RH2 9DY Reigate Surrey | British | 39114460001 | ||||||||||
| ABBEY NATIONAL NOMINEES LIMITED | Segretario | 2 Triton Square Regents Place NW1 3AN London Abbey National House | 133901580001 | |||||||||||
| ABBEY NATIONAL SECRETARIAT SERVICES LIMITED | Segretario | Abbey National House 2 Triton Square Regent's Place NW1 3AN London | 61749570003 | |||||||||||
| AFFLECK, Stephen David | Amministratore | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 United Kingdom | United Kingdom | British | 213797030002 | |||||||||
| COLES, Shaun Patrick | Amministratore | Chaplin Walk Great Cornard CO10 0YT Sudbury 4 Suffolk | United Kingdom | British | 95706540001 | |||||||||
| ELLWOOD, Michael | Amministratore | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 3 | United Kingdom | British | 162422770001 | |||||||||
| GREEN, David Martin | Amministratore | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 United Kingdom | United Kingdom | British | 157202700001 | |||||||||
| HOCKEY MORLEY, Gary | Amministratore | 69 Westbury Road HA6 3DA Northwood Middlesex | British | 78595520001 | ||||||||||
| HONEY, Andrew Roland | Amministratore | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 | United Kingdom | British | 151306350001 | |||||||||
| JACKSON, Mark Cunliffe | Amministratore | Triton Square Regents Place NW1 3AN London 2 | England | British | 96878690002 | |||||||||
| JOHNSON, Jeffrey | Amministratore | Hill House 28 Maldon Road Danbury CM3 4QH Chelmsford Essex | British | 103077710001 | ||||||||||
| MABERLY, Michael Alan | Amministratore | Endellion Money Row Green Holyport SL6 2NA Maidenhead Berkshire | British | 1288990001 | ||||||||||
| MORLEY, Anthony Nigel | Amministratore | 24 Wood End Road AL5 3ED Harpenden Hertfordshire | British | 2951350001 | ||||||||||
| MORRISON, Rachel Jane | Amministratore | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 United Kingdom | England | British | 79351960007 | |||||||||
| MURLEY, Timothy Cornelius | Amministratore | Lower Ground Floor Flat 135 Gloucester Avenue Primrose Hill NW1 8LA London | British | 94288090003 | ||||||||||
| PAI, Nameeta | Amministratore | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 | United Kingdom | Australian | 285803270001 | |||||||||
| PATEL, Shashin | Amministratore | 91 Chester Drive HA2 7PX Harrow Middlesex | England | British | 79860270001 | |||||||||
| ROOME, Harry Mccrea | Amministratore | The Duchies Mill Lane, Pirbright GU24 0BT Woking Surrey | England | British | 64898180001 | |||||||||
| ROUGIER, Alan Toby | Amministratore | Triton Square Regents Place NW1 3AN London 2 | United Kingdom | British | 108954830002 | |||||||||
| SCOTT, John Stearn | Amministratore | Three Elms Common Gate Road WD3 5JR Chorleywood Hertfordshire | United Kingdom | British | 7126810001 | |||||||||
| SMART, James Ramsay | Amministratore | 13 Alexandra Drive MK16 0ES Newport Pagnell Buckinghamshire | British | 57425040001 | ||||||||||
| STAMPER, Christopher Paul | Amministratore | 11 Cedar Drive Fetcham KT22 9ET Leatherhead Surrey | England | British | 37053220002 | |||||||||
| STEWART, David Howat | Amministratore | 6 Carew Lodge Carew Road HA6 3NH Northwood Middlesex | England | British | 108672850001 | |||||||||
| WHITE, Gavin Raymond | Amministratore | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 United Kingdom | United Kingdom | British | 202413360001 | |||||||||
| WRIGHT, Jason Leslie | Amministratore | Sandford Lodge 21 Reading Road OX10 9DS Wallingford Oxfordshire | British | 72145280003 |
Chi sono le persone con controllo significativo di ABBEY NATIONAL BUSINESS OFFICE EQUIPMENT LEASING LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander Equity Investments Limited | 14 mag 2018 | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Abbey National Treasury Services Overseas Holdings | 06 apr 2016 | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 United Kingdom | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Santander Uk Plc | 06 apr 2016 | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 United Kingdom | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
ABBEY NATIONAL BUSINESS OFFICE EQUIPMENT LEASING LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0