MORTGAGE FUNDING CORPORATION PLC
Panoramica
| Nome della società | MORTGAGE FUNDING CORPORATION PLC |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società per azioni |
| Numero di società | 01921487 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di MORTGAGE FUNDING CORPORATION PLC?
- Intermediazione finanziaria non classificata altrove (64999) / Attività finanziarie e assicurative
Dove si trova MORTGAGE FUNDING CORPORATION PLC?
| Indirizzo della sede legale | 1 Bridgewater Place Water Lane LS11 5QR Leeds West Yorkshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di MORTGAGE FUNDING CORPORATION PLC?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| MORTGAGE FUNDING CORPORATION LIMITED | 11 giu 1985 | 11 giu 1985 |
Quali sono gli ultimi bilanci di MORTGAGE FUNDING CORPORATION PLC?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per MORTGAGE FUNDING CORPORATION PLC?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 13 pagine | LIQ13 | ||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato Paragon House 51 Homer Road Solihull West Midlands B91 3QJ | 2 pagine | AD03 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 51 Homer Road Solihull West Midlands B91 3QJ a 1 Bridgewater Place Water Lane Leeds West Yorkshire LS11 5QR in data 18 mar 2019 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 5 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 05 nov 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2017 | 13 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 05 nov 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di The Paragon Group of Companies Plc come persona con controllo significativo il 21 set 2017 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2016 | 12 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 05 nov 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Keith Graham Allen il 01 lug 2016 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2015 | 11 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 05 nov 2015 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Mr Keith Graham Allen come amministratore in data 23 set 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2014 | 11 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 05 nov 2014 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di John Gemmell come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Miss Pandora Sharp come segretario | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di John Gemmell come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Richard James Woodman come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2013 | 12 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 05 nov 2013 con elenco completo degli azionisti | 12 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Chi sono gli amministratori di MORTGAGE FUNDING CORPORATION PLC?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHARP, Pandora | Segretario | Water Lane LS11 5QR Leeds 1 Bridgewater Place West Yorkshire | 188710030001 | |||||||
| ALLEN, Keith Graham | Amministratore | Water Lane LS11 5QR Leeds 1 Bridgewater Place West Yorkshire | England | British | 189271650002 | |||||
| SHELTON, Richard Dominic | Amministratore | Water Lane LS11 5QR Leeds 1 Bridgewater Place West Yorkshire | England | British | 79139430001 | |||||
| WOODMAN, Richard James | Amministratore | Water Lane LS11 5QR Leeds 1 Bridgewater Place West Yorkshire | England | British | 166716710001 | |||||
| CHAPMAN, Christopher Paul | Segretario | 1 Motts Close Watton At Stone SG14 3TR Hertford Hertfordshire | British | 74024200001 | ||||||
| GEMMELL, John Grigor | Segretario | Homer Road B91 3QJ Solihull 51 West Midlands | British | 84111440004 | ||||||
| MATON, Steven Roger | Segretario | 20 Longland Drive Totteridge N20 8HE London | British | 41681860001 | ||||||
| MEDLOCK, Alexander William | Segretario | 24 Cornwallis Avenue Beltinge CT6 6UQ Herne Bay Kent | British | 46466260001 | ||||||
| WELLMAN, Gillian Margaret | Segretario | 9 Ormonde Place Old Avenue KT13 0PE Weybridge Surrey | British | 80029900001 | ||||||
| GEMMELL, John Grigor | Amministratore | Homer Road B91 3QJ Solihull 51 West Midlands | United Kingdom | British | 84111440004 | |||||
| HAIRE, Roderick Fulton | Amministratore | 79 Westbury Road HA6 3DA Northwood Middlesex | British | 41732910001 | ||||||
| HANRATTY, John Joseph | Amministratore | 21 Kingslawn Close Howards Lane Putney SW15 6QJ London | United Kingdom | British | 12553730001 | |||||
| LOVERING, Roger Vincent | Amministratore | 2 Foxhanger Gardens GU22 7BQ Woking Surrey | England | British | 28922470001 | |||||
| LUBOFF, Mark Edward | Amministratore | 6 Bolingbroke Grove SW11 6ES London | England | British | 55875890001 | |||||
| OWEN, David Robert | Amministratore | Dorset Cottage The Hildens Westcott RH4 3JX Dorking Surrey | British | 60864210002 | ||||||
| RAIKES, Anthony Francis | Amministratore | Pond House High Street TN5 6AA Wadhurst East Sussex | British | 74100440004 | ||||||
| ROGERS, Paul Robert | Amministratore | 2 Zig Zag Road CR8 5EL Kenley Surrey | England | British | 53567140002 | |||||
| ROSS, Geoffrey Michael | Amministratore | The Pond House 9 Lakeside Crescent CM14 4JB Brentwood Essex | British | 70812190001 | ||||||
| SHARMAN, Norman John | Amministratore | 3 Edenham Close Lower Earley RG6 3TH Reading Berkshire | British | 52184590001 | ||||||
| SMITH, Stephen Howard | Amministratore | 59 Chestnut Springs Lydiard Millicent SN5 9NB Swindon Wiltshire | British | 42550950001 | ||||||
| WARD, Anthony John | Amministratore | Maynards Appledore Road Leigh Green TN30 7DE Tenterden Kent | England | British | 106674440001 | |||||
| WAUD, Christopher Graham | Amministratore | Sethorns Brownhill Road BH25 5TT New Milton Hampshire | British | 63563910001 | ||||||
| WHITTALL, Harry John | Amministratore | 41 Baldock Road SG8 5BJ Royston Hertfordshire | British | 34641400001 | ||||||
| WILMINGTON TRUST SP SERVICES (LONDON) LIMITED | Amministratore | Tower 42 (Level 11) International Financial Centre 25 Old Broad Street EC2N 1HQ London | 24311810024 |
Chi sono le persone con controllo significativo di MORTGAGE FUNDING CORPORATION PLC?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paragon Banking Group Plc | 06 apr 2016 | Homer Road B91 3QJ Solihull 51 West Midlands United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
MORTGAGE FUNDING CORPORATION PLC ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Assignment of rights of mfc under mts declaration of trust and supplemental declaration of trust | Creato il 04 ago 2004 Consegnato il 12 ago 2004 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All its rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of charge over credit balances | Creato il 04 ago 2004 Consegnato il 12 ago 2004 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All right title and interest in and to the deposit(s). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of floating charge | Creato il 04 ago 2004 Consegnato il 12 ago 2004 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Assignment of broking deed | Creato il 04 ago 2004 Consegnato il 12 ago 2004 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All its rights to the lender. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Assignment of management agreement | Creato il 04 ago 2004 Consegnato il 12 ago 2004 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All its rights to the lender. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed | Creato il 16 dic 1988 Consegnato il 05 gen 1989 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee as trustee for the lenders and creditors under the terms of the charge supplemental to and modifying a trust debentrue dated 9/5/86 and 3 deeds dated 3/6/87, 23/7/88 & 7/7/88. | |
Brevi particolari First floating charge over:- (see doc for full details). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed | Creato il 07 lug 1988 Consegnato il 27 lug 1988 | In corso | Importo garantito All moneys due or to become due from the company to the lenders (as defined in the deed) in respect of loans (as defined) and all other liabilities monies under the terms of this trust debenture supplemental to and modifying a trust debenture dated 9-5-86 and to two deeds dated 3.6.8M and 23.2.88. | |
Brevi particolari Floating charge over undertaking and all property and assets present and future including rights uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Trust debenture | Creato il 09 mag 1986 Consegnato il 20 mag 1986 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed. | |
Brevi particolari First floating charge over the undertaking and all property and rights assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
MORTGAGE FUNDING CORPORATION PLC ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0