MORTGAGE FUNDING CORPORATION PLC

MORTGAGE FUNDING CORPORATION PLC

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMORTGAGE FUNDING CORPORATION PLC
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà per azioni
    Numero di società 01921487
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MORTGAGE FUNDING CORPORATION PLC?

    • Intermediazione finanziaria non classificata altrove (64999) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova MORTGAGE FUNDING CORPORATION PLC?

    Indirizzo della sede legale
    1 Bridgewater Place
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MORTGAGE FUNDING CORPORATION PLC?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MORTGAGE FUNDING CORPORATION LIMITED11 giu 198511 giu 1985

    Quali sono gli ultimi bilanci di MORTGAGE FUNDING CORPORATION PLC?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per MORTGAGE FUNDING CORPORATION PLC?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    13 pagineLIQ13

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato Paragon House 51 Homer Road Solihull West Midlands B91 3QJ

    2 pagineAD03

    Indirizzo della sede legale modificato da 51 Homer Road Solihull West Midlands B91 3QJ a 1 Bridgewater Place Water Lane Leeds West Yorkshire LS11 5QR in data 18 mar 2019

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 26 feb 2019

    LRESSP

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 nov 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 set 2017

    13 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 nov 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Modifica dei dettagli di The Paragon Group of Companies Plc come persona con controllo significativo il 21 set 2017

    2 paginePSC05

    Bilancio redatto al 30 set 2016

    12 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 nov 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Keith Graham Allen il 01 lug 2016

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 30 set 2015

    11 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 05 nov 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 nov 2015

    Stato del capitale al 23 nov 2015

    • Capitale: GBP 50,000
    SH01

    Nomina di Mr Keith Graham Allen come amministratore in data 23 set 2015

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 30 set 2014

    11 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 05 nov 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 nov 2014

    Stato del capitale al 05 nov 2014

    • Capitale: GBP 50,000
    SH01

    Cessazione della carica di John Gemmell come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Miss Pandora Sharp come segretario

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di John Gemmell come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Richard James Woodman come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 30 set 2013

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 05 nov 2013 con elenco completo degli azionisti

    12 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital13 nov 2013

    Stato del capitale al 13 nov 2013

    • Capitale: GBP 50,000
    SH01

    Chi sono gli amministratori di MORTGAGE FUNDING CORPORATION PLC?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SHARP, Pandora
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    1 Bridgewater Place
    West Yorkshire
    Segretario
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    1 Bridgewater Place
    West Yorkshire
    188710030001
    ALLEN, Keith Graham
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    1 Bridgewater Place
    West Yorkshire
    Amministratore
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    1 Bridgewater Place
    West Yorkshire
    EnglandBritish189271650002
    SHELTON, Richard Dominic
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    1 Bridgewater Place
    West Yorkshire
    Amministratore
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    1 Bridgewater Place
    West Yorkshire
    EnglandBritish79139430001
    WOODMAN, Richard James
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    1 Bridgewater Place
    West Yorkshire
    Amministratore
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    1 Bridgewater Place
    West Yorkshire
    EnglandBritish166716710001
    CHAPMAN, Christopher Paul
    1 Motts Close
    Watton At Stone
    SG14 3TR Hertford
    Hertfordshire
    Segretario
    1 Motts Close
    Watton At Stone
    SG14 3TR Hertford
    Hertfordshire
    British74024200001
    GEMMELL, John Grigor
    Homer Road
    B91 3QJ Solihull
    51
    West Midlands
    Segretario
    Homer Road
    B91 3QJ Solihull
    51
    West Midlands
    British84111440004
    MATON, Steven Roger
    20 Longland Drive
    Totteridge
    N20 8HE London
    Segretario
    20 Longland Drive
    Totteridge
    N20 8HE London
    British41681860001
    MEDLOCK, Alexander William
    24 Cornwallis Avenue
    Beltinge
    CT6 6UQ Herne Bay
    Kent
    Segretario
    24 Cornwallis Avenue
    Beltinge
    CT6 6UQ Herne Bay
    Kent
    British46466260001
    WELLMAN, Gillian Margaret
    9 Ormonde Place
    Old Avenue
    KT13 0PE Weybridge
    Surrey
    Segretario
    9 Ormonde Place
    Old Avenue
    KT13 0PE Weybridge
    Surrey
    British80029900001
    GEMMELL, John Grigor
    Homer Road
    B91 3QJ Solihull
    51
    West Midlands
    Amministratore
    Homer Road
    B91 3QJ Solihull
    51
    West Midlands
    United KingdomBritish84111440004
    HAIRE, Roderick Fulton
    79 Westbury Road
    HA6 3DA Northwood
    Middlesex
    Amministratore
    79 Westbury Road
    HA6 3DA Northwood
    Middlesex
    British41732910001
    HANRATTY, John Joseph
    21 Kingslawn Close
    Howards Lane Putney
    SW15 6QJ London
    Amministratore
    21 Kingslawn Close
    Howards Lane Putney
    SW15 6QJ London
    United KingdomBritish12553730001
    LOVERING, Roger Vincent
    2 Foxhanger Gardens
    GU22 7BQ Woking
    Surrey
    Amministratore
    2 Foxhanger Gardens
    GU22 7BQ Woking
    Surrey
    EnglandBritish28922470001
    LUBOFF, Mark Edward
    6 Bolingbroke Grove
    SW11 6ES London
    Amministratore
    6 Bolingbroke Grove
    SW11 6ES London
    EnglandBritish55875890001
    OWEN, David Robert
    Dorset Cottage The Hildens
    Westcott
    RH4 3JX Dorking
    Surrey
    Amministratore
    Dorset Cottage The Hildens
    Westcott
    RH4 3JX Dorking
    Surrey
    British60864210002
    RAIKES, Anthony Francis
    Pond House
    High Street
    TN5 6AA Wadhurst
    East Sussex
    Amministratore
    Pond House
    High Street
    TN5 6AA Wadhurst
    East Sussex
    British74100440004
    ROGERS, Paul Robert
    2 Zig Zag Road
    CR8 5EL Kenley
    Surrey
    Amministratore
    2 Zig Zag Road
    CR8 5EL Kenley
    Surrey
    EnglandBritish53567140002
    ROSS, Geoffrey Michael
    The Pond House
    9 Lakeside Crescent
    CM14 4JB Brentwood
    Essex
    Amministratore
    The Pond House
    9 Lakeside Crescent
    CM14 4JB Brentwood
    Essex
    British70812190001
    SHARMAN, Norman John
    3 Edenham Close
    Lower Earley
    RG6 3TH Reading
    Berkshire
    Amministratore
    3 Edenham Close
    Lower Earley
    RG6 3TH Reading
    Berkshire
    British52184590001
    SMITH, Stephen Howard
    59 Chestnut Springs
    Lydiard Millicent
    SN5 9NB Swindon
    Wiltshire
    Amministratore
    59 Chestnut Springs
    Lydiard Millicent
    SN5 9NB Swindon
    Wiltshire
    British42550950001
    WARD, Anthony John
    Maynards Appledore Road
    Leigh Green
    TN30 7DE Tenterden
    Kent
    Amministratore
    Maynards Appledore Road
    Leigh Green
    TN30 7DE Tenterden
    Kent
    EnglandBritish106674440001
    WAUD, Christopher Graham
    Sethorns
    Brownhill Road
    BH25 5TT New Milton
    Hampshire
    Amministratore
    Sethorns
    Brownhill Road
    BH25 5TT New Milton
    Hampshire
    British63563910001
    WHITTALL, Harry John
    41 Baldock Road
    SG8 5BJ Royston
    Hertfordshire
    Amministratore
    41 Baldock Road
    SG8 5BJ Royston
    Hertfordshire
    British34641400001
    WILMINGTON TRUST SP SERVICES (LONDON) LIMITED
    Tower 42 (Level 11) International Financial Centre
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Amministratore
    Tower 42 (Level 11) International Financial Centre
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    24311810024

    Chi sono le persone con controllo significativo di MORTGAGE FUNDING CORPORATION PLC?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Paragon Banking Group Plc
    Homer Road
    B91 3QJ Solihull
    51
    West Midlands
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Homer Road
    B91 3QJ Solihull
    51
    West Midlands
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaPublic Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House Uk
    Numero di registrazione2336032
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    MORTGAGE FUNDING CORPORATION PLC ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Assignment of rights of mfc under mts declaration of trust and supplemental declaration of trust
    Creato il 04 ago 2004
    Consegnato il 12 ago 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All its rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 ago 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 04 ago 2004
    Consegnato il 12 ago 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All right title and interest in and to the deposit(s). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 ago 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of floating charge
    Creato il 04 ago 2004
    Consegnato il 12 ago 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 ago 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Assignment of broking deed
    Creato il 04 ago 2004
    Consegnato il 12 ago 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All its rights to the lender. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 ago 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Assignment of management agreement
    Creato il 04 ago 2004
    Consegnato il 12 ago 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All its rights to the lender. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 ago 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed
    Creato il 16 dic 1988
    Consegnato il 05 gen 1989
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as trustee for the lenders and creditors under the terms of the charge supplemental to and modifying a trust debentrue dated 9/5/86 and 3 deeds dated 3/6/87, 23/7/88 & 7/7/88.
    Brevi particolari
    First floating charge over:- (see doc for full details). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation PLC
    Transazioni
    • 05 gen 1989Registrazione di un'ipoteca
    Deed
    Creato il 07 lug 1988
    Consegnato il 27 lug 1988
    In corso
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from the company to the lenders (as defined in the deed) in respect of loans (as defined) and all other liabilities monies under the terms of this trust debenture supplemental to and modifying a trust debenture dated 9-5-86 and to two deeds dated 3.6.8M and 23.2.88.
    Brevi particolari
    Floating charge over undertaking and all property and assets present and future including rights uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation Plcas Trustee for the Lenders.
    Transazioni
    • 27 lug 1988Registrazione di un'ipoteca
    Trust debenture
    Creato il 09 mag 1986
    Consegnato il 20 mag 1986
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed.
    Brevi particolari
    First floating charge over the undertaking and all property and rights assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation PLC
    Transazioni
    • 20 mag 1986Registrazione di un'ipoteca

    MORTGAGE FUNDING CORPORATION PLC ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    26 feb 2019Inizio della liquidazione
    09 lug 2020Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Derek Hyslop
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    Colin Peter Dempster
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0