ADVANCED COMPOSITES GROUP (PRIMCO) LIMITED

ADVANCED COMPOSITES GROUP (PRIMCO) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàADVANCED COMPOSITES GROUP (PRIMCO) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01921570
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ADVANCED COMPOSITES GROUP (PRIMCO) LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova ADVANCED COMPOSITES GROUP (PRIMCO) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Composites House
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Derbyshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ADVANCED COMPOSITES GROUP (PRIMCO) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ADVANCED COMPOSITES GROUP (MANCHESTER) LIMITED28 gen 200828 gen 2008
    PRIMCO LIMITED18 dic 198918 dic 1989
    GEORGE COLE TECHNOLOGIES LTD29 ott 198529 ott 1985
    YARDASTON LIMITED12 giu 198512 giu 1985

    Quali sono gli ultimi bilanci di ADVANCED COMPOSITES GROUP (PRIMCO) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2012

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per ADVANCED COMPOSITES GROUP (PRIMCO) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per ADVANCED COMPOSITES GROUP (PRIMCO) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 feb 2014

    Stato del capitale al 14 feb 2014

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    5 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da Concorde House Warwick New Road Leamington Spa Warwickshire CV32 5JG in data 11 giu 2013

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 31 mar 2013 al 31 dic 2012

    1 pagineAA01

    Bilancio redatto al 31 mar 2012

    7 pagineAA

    Nomina di Mr Roy Douglas Smith come amministratore in data 20 lug 2012

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr David M Drillock come amministratore in data 20 lug 2012

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Roy Douglas Smith come segretario in data 20 lug 2012

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Andrew Brian Moss come amministratore in data 20 lug 2012

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Steven John Bowers come amministratore in data 20 lug 2012

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Steven John Bowers come segretario in data 20 lug 2012

    1 pagineTM02

    legacy

    3 pagineMG02

    Cessazione della carica di Mark Malitskie come amministratore in data 20 feb 2012

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Jonathan Peter Mabbitt come amministratore in data 28 feb 2012

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2011

    7 pagineAA

    Cessazione della carica di Clive Snowdon come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Douglas Robertson come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Steven John Bowers come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2010 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2010

    7 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di ADVANCED COMPOSITES GROUP (PRIMCO) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SMITH, Roy Douglas
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    England
    Segretario
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    England
    171179170001
    DRILLOCK, David M
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    England
    Amministratore
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    England
    United StatesAmerican170878740001
    SMITH, Roy Douglas
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    England
    Amministratore
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    England
    UsaUsa170877010001
    BOWERS, Steven John
    50 Regency House
    Newbold Terrace
    CV32 4HD Leamington Spa
    Warwickshire
    Segretario
    50 Regency House
    Newbold Terrace
    CV32 4HD Leamington Spa
    Warwickshire
    British61929330003
    COLE, Sara Elizabeth
    11 Shakespeare Street
    CV37 6RN Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Segretario
    11 Shakespeare Street
    CV37 6RN Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    British5916920003
    BOWERS, Steven John
    Warwick New Road
    CV32 5JG Leamington Spa
    Concorde House
    Warwickshire
    Amministratore
    Warwick New Road
    CV32 5JG Leamington Spa
    Concorde House
    Warwickshire
    United KingdomBritish176189250001
    CALDECUTT, Francis
    107 Heights Avenue
    Rochdale
    Manchester
    Greater Manchester
    Amministratore
    107 Heights Avenue
    Rochdale
    Manchester
    Greater Manchester
    British6009900001
    COLE, Jessie Louise
    The Miles Green Lane East
    Cabus
    PR3 1JS Preston
    Lancashire
    Amministratore
    The Miles Green Lane East
    Cabus
    PR3 1JS Preston
    Lancashire
    British5896270001
    COX, John Raymond Sylvester
    Burned Hay Cottage Woodlands Road
    Pownall Park
    SK9 5QB Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    Burned Hay Cottage Woodlands Road
    Pownall Park
    SK9 5QB Wilmslow
    Cheshire
    British5896280001
    MABBITT, Jonathan Peter
    Sunset
    Nether Lane
    DE56 4AP Hazelwood
    Derbyshire
    Amministratore
    Sunset
    Nether Lane
    DE56 4AP Hazelwood
    Derbyshire
    EnglandBritish83707310002
    MALITSKIE, Mark
    52 High Street
    Broughton
    NN14 1NQ Kettering
    Northamptonshire
    Amministratore
    52 High Street
    Broughton
    NN14 1NQ Kettering
    Northamptonshire
    EnglandBritish68667640001
    MOSS, Andrew Brian
    Saddlebow Cottage
    Saddlebow Lane
    CV35 8PQ Claverdon
    Warwickshire
    Amministratore
    Saddlebow Cottage
    Saddlebow Lane
    CV35 8PQ Claverdon
    Warwickshire
    EnglandBritish161928410001
    ROBERTSON, Douglas Grant
    Blackmore Grange
    Blackmore End
    WR8 0EE Hanley Swan
    Worcestershire
    Amministratore
    Blackmore Grange
    Blackmore End
    WR8 0EE Hanley Swan
    Worcestershire
    EnglandBritish123487130001
    SNOWDON, Clive John
    New End Barn
    Spernall Lane Great Alne
    B49 6JD Alcester
    Warwickshire
    Amministratore
    New End Barn
    Spernall Lane Great Alne
    B49 6JD Alcester
    Warwickshire
    United KingdomBritish32242700001

    ADVANCED COMPOSITES GROUP (PRIMCO) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 11 dic 2009
    Consegnato il 30 dic 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly known as advanced composites group (manchester) limited and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any of any present or future account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 30 dic 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 19 apr 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Credit agreement
    Creato il 26 set 1991
    Consegnato il 08 ott 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £15592.14 due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    All its right title & interest in and to all sums payable (including by way of refund) under the insurance set out in form 395 (see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited
    Transazioni
    • 08 ott 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 24 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0