IN BUSINESS MEDIA LIMITED
Panoramica
Nome della società | IN BUSINESS MEDIA LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01921874 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di IN BUSINESS MEDIA LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova IN BUSINESS MEDIA LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Trelawney House Chestergate SK11 6DW Macclesfield Cheshire |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di IN BUSINESS MEDIA LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
ATALINK PUBLISHING LIMITED | 17 ago 2011 | 17 ago 2011 |
PRETEND LIMITED | 15 set 2009 | 15 set 2009 |
ATALINK PUBLISHING LIMITED | 28 lug 1998 | 28 lug 1998 |
ATALINK LIMITED | 12 giu 1985 | 12 giu 1985 |
Quali sono gli ultimi bilanci di IN BUSINESS MEDIA LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2013 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per IN BUSINESS MEDIA LIMITED?
Bilancio annuale |
|
---|
Quali sono le ultime deposizioni per IN BUSINESS MEDIA LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 21 feb 2014 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2013 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Derek Alexander Morren come amministratore in data 06 mar 2013 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 21 feb 2013 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2012 | 2 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Adrian James Dunleavy come amministratore in data 09 mar 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 21 feb 2012 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Nomina di Mr Derek Alexander Morren come amministratore in data 10 feb 2012 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Adrian James Dunleavy come amministratore in data 10 feb 2012 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew Mckerlie come amministratore in data 10 feb 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Alex Connock come amministratore in data 10 feb 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed atalink publishing LIMITED\certificate issued on 17/01/12 | 3 pagine | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2011 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed pretend LIMITED\certificate issued on 17/08/11 | 3 pagine | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Ten Alps Plc il 23 feb 2011 | 2 pagine | CH02 | ||||||||||
Nomina di Andrew Mckerlie come amministratore | 2 pagine | AP02 | ||||||||||
Nomina di Ten Alps Plc come amministratore | 2 pagine | AP02 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 21 feb 2011 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Mr Nitil Patel il 21 feb 2011 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Nitil Patel il 21 feb 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di IN BUSINESS MEDIA LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATEL, Nitil | Segretario | Chestergate SK11 6DW Macclesfield Trelawney House Cheshire United Kingdom | British | Financial Director | 126644210001 | |||||||||
PATEL, Nitil | Amministratore | Chestergate SK11 6DW Macclesfield Trelawney House Cheshire United Kingdom | England | British | Financial Director | 126644210001 | ||||||||
CLARKE, Nancy Louise | Segretario | 1 Milton Avenue N6 5QF London | British | 9692290001 | ||||||||||
HUTCHINGS, Christopher | Segretario | 4 Flagstaff Close EN9 1JB Waltham Abbey Essex | British | 33877510002 | ||||||||||
MOSS, Graeme John | Segretario | 60 Meadow Walk Ewell KT17 2ED Epsom Surrey | British | Company Secretary | 8175050001 | |||||||||
DUNLEAVY, Adrian James | Amministratore | Chestergate SK11 6DW Macclesfield Trelawney House Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | Chief Executive Officer | 112236910001 | ||||||||
DUNLEAVY, Adrian James | Amministratore | Roundstone House WA14 3RG Millington Cheshire | United Kingdom | British | Company Director | 112236910001 | ||||||||
FENTON, Stephen Kenneth | Amministratore | Flat 5 Regent Court 279 Kingsland Road Hackney E2 London | British | Director | 9692310001 | |||||||||
GREGORIOU, Charles | Amministratore | 1 Creighton Avenue Muswell Hill N10 1NX London | British | Director | 41031020002 | |||||||||
HEMPENSTALL, Thomas | Amministratore | 12 Pine Hill KT18 7BG Epsom Surrey | British | Director | 119534520001 | |||||||||
MORREN, Derek Alexander | Amministratore | Chestergate SK11 6DW Macclesfield Trelawney House Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | Finance Director | 114001580004 | ||||||||
MORREN, Derek Alexander | Amministratore | Ashwood Farm Court Wervin CH2 4HF Chester 3 United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 114001580002 | ||||||||
VINCENT, Paul Stephen | Amministratore | Sunway Beech Drive Kingswood KT20 6PS Tadworth Surrey | British | Director | 8175090001 | |||||||||
ALEX CONNOCK | Amministratore | 15 Links Place EH6 7EZ Edinburgh Great Michael House United Kingdom |
| 158003440002 | ||||||||||
ANDREW MCKERLIE | Amministratore | Links Place EH6 7EZ Edinburgh Great Michael House United Kingdom |
| 158003610001 | ||||||||||
METAL BULLETIN PLC | Amministratore | Park House Park Terrace KT4 7HY Worcester Park Surrey | 83597810001 |
IN BUSINESS MEDIA LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Omnibus guarantee and set-off agreement | Creato il 31 gen 2011 Consegnato il 01 feb 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the principals to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Any right title or interest in or to any credit balance being any sum standing to the credit of the account, whether in sterling or any other currency or currency unit and the debt from time to time owing by the bank represented by that sum see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 27 mar 2008 Consegnato il 04 apr 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 03 lug 1990 Consegnato il 17 lug 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Including trade fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 02 mar 1989 Consegnato il 09 mar 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 13 giu 1988 Consegnato il 23 giu 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0