RARE PUBLISHING LIMITED

RARE PUBLISHING LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàRARE PUBLISHING LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01924870
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di RARE PUBLISHING LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova RARE PUBLISHING LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    7 Billing Road
    NN1 5AN Northampton
    Northamptonshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di RARE PUBLISHING LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    AMD BRASS TACKS LIMITED18 gen 200118 gen 2001
    BRASS TACKS PUBLISHING COMPANY LIMITED(THE)07 feb 198607 feb 1986
    RABSLAND LIMITED21 giu 198521 giu 1985

    Quali sono gli ultimi bilanci di RARE PUBLISHING LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 gen 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per RARE PUBLISHING LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per RARE PUBLISHING LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 01 gen 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 feb 2014

    Stato del capitale al 14 feb 2014

    • Capitale: GBP 27,500
    SH01

    Nomina di Mrs Susan Margaret Lake come segretario in data 21 mar 2013

    2 pagineAP03

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 gen 2013

    11 pagineAA

    Cessazione della carica di Peter John Moore come segretario in data 21 mar 2013

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Peter John Moore come amministratore in data 21 mar 2013

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da 3rd Floor 21 Great Sutton Street London EC1V 0DY in data 05 set 2013

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 01 gen 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 gen 2012

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 gen 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 gen 2011

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 gen 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio annuale redatto al 01 gen 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 gen 2010

    6 pagineAA

    legacy

    5 pagineMG01

    legacy

    5 pagineMG01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 dic 2009 al 31 gen 2010

    1 pagineAA01

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2009 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2008

    7 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2007

    7 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    7 pagine395

    Chi sono gli amministratori di RARE PUBLISHING LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LAKE, Susan Margaret
    The Green
    Thurlby
    PE10 0HA Bourne
    4
    Lincolnshire
    United Kingdom
    Segretario
    The Green
    Thurlby
    PE10 0HA Bourne
    4
    Lincolnshire
    United Kingdom
    182060610001
    LAKE, Grahame
    4 The Green
    Thurlby
    PE10 0HA Bourne
    Lincolnshire
    Amministratore
    4 The Green
    Thurlby
    PE10 0HA Bourne
    Lincolnshire
    EnglandBritish108297820001
    CONCHIE, William Kim
    7 Strafford Road
    TW1 3AD Twickenham
    Segretario
    7 Strafford Road
    TW1 3AD Twickenham
    British27780900002
    DAVISON, Robert Edward
    Yeomans Close
    Thorley Park
    CM23 4EU Bishops Stortford
    23
    Hertfordshire
    Segretario
    Yeomans Close
    Thorley Park
    CM23 4EU Bishops Stortford
    23
    Hertfordshire
    British45449440002
    MOORE, Peter John
    66 Vicarage Road
    Blackwater
    GU17 9BD Camberley
    Surrey
    Segretario
    66 Vicarage Road
    Blackwater
    GU17 9BD Camberley
    Surrey
    United Kingdom26131670001
    SMITH, Mark William
    Overbrook
    Farley Green
    GU5 9DN Albury
    Surrey
    Segretario
    Overbrook
    Farley Green
    GU5 9DN Albury
    Surrey
    British31134280008
    BAKER, Neville Peter
    6 Hut Field Lane
    Papworth Everard
    CB3 8GS Cambridge
    Cambridgeshire
    Amministratore
    6 Hut Field Lane
    Papworth Everard
    CB3 8GS Cambridge
    Cambridgeshire
    British58551030002
    CHAMBERLAIN, Alan John
    53 Fernlea
    Braiswick
    CO4 5UB Colchester
    Essex
    Amministratore
    53 Fernlea
    Braiswick
    CO4 5UB Colchester
    Essex
    British37261670001
    CONCHIE, William Kim
    White House
    1 Fenwick Road
    TR11 4DR Falmouth
    Cornwall
    Amministratore
    White House
    1 Fenwick Road
    TR11 4DR Falmouth
    Cornwall
    EnglandBritish27780900003
    HANLEY, Jeremy, Sir
    6 Butts Mead
    HA6 2TL Northwood
    Middlesex
    Amministratore
    6 Butts Mead
    HA6 2TL Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritish55302100001
    HIGGINS, Paul James
    19 Fields Park Road
    NP9 5BA Newport
    Gwent
    Amministratore
    19 Fields Park Road
    NP9 5BA Newport
    Gwent
    EnglandBritish22612650002
    MCKNIGHT, Kevin John
    50a Wardo Avenue
    SW6 London
    Amministratore
    50a Wardo Avenue
    SW6 London
    British10915910003
    MOORE, Peter John
    66 Vicarage Road
    Blackwater
    GU17 9BD Camberley
    Surrey
    Amministratore
    66 Vicarage Road
    Blackwater
    GU17 9BD Camberley
    Surrey
    United KingdomUnited Kingdom26131670001
    QUIRKE, Stephen Joseph James
    67 Micheldever Road
    SE12 8LU London
    Amministratore
    67 Micheldever Road
    SE12 8LU London
    United KingdomBritish10915920002
    SAGAR, Sewak Bharat Singh
    361 Durnsford Road
    Wimbledon Park
    SW19 8EF London
    Amministratore
    361 Durnsford Road
    Wimbledon Park
    SW19 8EF London
    British20561040001
    SHARP, Fiona Mary
    61 Heath Gardens
    TW1 4LY Twickenham
    Middlesex
    Amministratore
    61 Heath Gardens
    TW1 4LY Twickenham
    Middlesex
    British66457680001
    SMITH, Mark William
    Overbrook
    Farley Green
    GU5 9DN Albury
    Surrey
    Amministratore
    Overbrook
    Farley Green
    GU5 9DN Albury
    Surrey
    United KingdomBritish31134280008
    SPOONER, Linda Jane
    Flat 5 2 Finborough Road
    SW10 9EQ London
    Amministratore
    Flat 5 2 Finborough Road
    SW10 9EQ London
    British58551200001
    STUART, Andrew Peter
    6 Wellingham Road
    East Dulwich
    SE22 9HD London
    Amministratore
    6 Wellingham Road
    East Dulwich
    SE22 9HD London
    British20561050003

    RARE PUBLISHING LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Rent deposit deed
    Creato il 04 giu 2010
    Consegnato il 19 giu 2010
    In corso
    Importo garantito
    £5,375.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All monies due or to become due see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Archfinall Limited
    Transazioni
    • 19 giu 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Deed of deposit
    Creato il 04 giu 2010
    Consegnato il 19 giu 2010
    In corso
    Importo garantito
    £2,750 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All monies due or become due under the terms of the lease dated 4 june 2010 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Archfinall Limited
    Transazioni
    • 19 giu 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 27 feb 2008
    Consegnato il 03 mar 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Leumi Abl Limited
    Transazioni
    • 03 mar 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 15 gen 2007
    Consegnato il 20 gen 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Arbuthnot Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 20 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 30 nov 2006
    Consegnato il 18 dic 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Arbuthnot Latham & Co Limited
    Transazioni
    • 18 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of deposit
    Creato il 27 ott 2006
    Consegnato il 02 nov 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    £2,750.
    Persone aventi diritto
    • Archfinall Limited
    Transazioni
    • 02 nov 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of deposit
    Creato il 27 apr 2006
    Consegnato il 03 mag 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    £5,375.00 plus any interest thereon.
    Persone aventi diritto
    • Archfinall Limited
    Transazioni
    • 03 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 14 nov 2002
    Consegnato il 20 nov 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 nov 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 28 lug 1998
    Consegnato il 31 lug 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 31 lug 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 apr 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 26 nov 1990
    Consegnato il 29 nov 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    First fixed charge on all book & other debts,floating charge on all other the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 29 nov 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 19 nov 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 25 apr 1986
    Consegnato il 02 mag 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Please see doc m 17.. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 mag 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 29 nov 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0