MONARCH REALISATIONS 12 LIMITED

MONARCH REALISATIONS 12 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMONARCH REALISATIONS 12 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01925737
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MONARCH REALISATIONS 12 LIMITED?

    • (9999) /

    Dove si trova MONARCH REALISATIONS 12 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Homelife House
    26/32 Oxford Road
    BH8 8EZ Bournemouth
    Dorset
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MONARCH REALISATIONS 12 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MCCARTHY & STONE (GROUP SERVICES) LIMITED02 ott 198602 ott 1986
    MCCARTHY & STONE CONSULTANCY SERVICES LIMITED25 giu 198525 giu 1985

    Quali sono gli ultimi bilanci di MONARCH REALISATIONS 12 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 ago 2007

    Quali sono le ultime deposizioni per MONARCH REALISATIONS 12 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Bilancio annuale redatto al 01 mar 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital02 mar 2010

    Stato del capitale al 02 mar 2010

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Gary Neil Day il 11 feb 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Michael John Jennings il 19 gen 2010

    2 pagineCH01

    legacy

    4 pagine363a

    Memorandum e Statuto

    11 pagineMA

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed mccarthy & stone (group services) LIMITED\certificate issued on 14/05/09
    3 pagineCERTNM

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 ago 2007

    7 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    5 pagine288a

    Bilancio redatto al 31 ago 2006

    9 pagineAA

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 ago 2005

    6 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    2 pagine288a

    Bilancio redatto al 31 ago 2004

    6 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di MONARCH REALISATIONS 12 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GREEN, Trevor Lindsay
    Foxhill 31 Avon Castle Drive
    BH24 2BB Ringwood
    Hampshire
    Segretario
    Foxhill 31 Avon Castle Drive
    BH24 2BB Ringwood
    Hampshire
    British981540001
    BALL, Michael David
    Mulberry House
    Trumps Green Road
    GU25 4JA Virginia Water
    Surrey
    Amministratore
    Mulberry House
    Trumps Green Road
    GU25 4JA Virginia Water
    Surrey
    United KingdomBritish58961410002
    DAY, Gary Neil
    Chine View Mansions
    2 Mckinley Road West Overcliff
    BH4 8AQ Bournemouth
    1
    United Kingdom
    Amministratore
    Chine View Mansions
    2 Mckinley Road West Overcliff
    BH4 8AQ Bournemouth
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish10857490004
    JENNINGS, Michael John
    51 Chaddesley Glen
    Sandbanks
    BH13 7RE Poole
    Chameleon
    Dorset
    United Kingdom
    Amministratore
    51 Chaddesley Glen
    Sandbanks
    BH13 7RE Poole
    Chameleon
    Dorset
    United Kingdom
    EnglandBritish8586280013
    PHILLIPS, Howard Peter Stewart
    Flamstone Park
    Bishopstone
    SP5 4DB Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    Flamstone Park
    Bishopstone
    SP5 4DB Salisbury
    Wiltshire
    EnglandBritish72535940003
    FIELD, Derek Anthony
    Autumn Chase Beach Road
    Upton
    BH16 5NA Poole
    Dorset
    Amministratore
    Autumn Chase Beach Road
    Upton
    BH16 5NA Poole
    Dorset
    British50673980001
    GRAY, John
    Crosstrees
    Sway Road
    SO41 8LR Lymington
    Hampshire
    Amministratore
    Crosstrees
    Sway Road
    SO41 8LR Lymington
    Hampshire
    United KingdomBritish34578290001
    HARRISON, Rodney Michael
    Amberwell
    Toms Lane Linwood
    BH24 3QU Ringwood
    Hants
    Amministratore
    Amberwell
    Toms Lane Linwood
    BH24 3QU Ringwood
    Hants
    EnglandBritish6583720001
    LOVELOCK, Keith
    Toogoods House
    Moorside
    DT10 1HQ Sturminster Newton
    Dorset
    Amministratore
    Toogoods House
    Moorside
    DT10 1HQ Sturminster Newton
    Dorset
    British6219340001
    MCCARTHY, John Sidney
    Squalls Estate
    Squalls Lane Tisbury
    SP3 6RX Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    Squalls Estate
    Squalls Lane Tisbury
    SP3 6RX Salisbury
    Wiltshire
    EnglandBritish31054720002
    THORNE, Matthew Wadman John
    The Mount Bannerdown Road
    Batheaston
    BA1 8EG Bath
    Avon
    Amministratore
    The Mount Bannerdown Road
    Batheaston
    BA1 8EG Bath
    Avon
    United KingdomBritish8469850001
    TOWERS, Martin George
    Linton House Avenue Des Hirondelles
    Pool In Wharfedale
    LS21 1EY Otley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Linton House Avenue Des Hirondelles
    Pool In Wharfedale
    LS21 1EY Otley
    West Yorkshire
    British36252860002
    TUFTS, Dean Stuart
    1 Browning Road
    GU13 0YJ Fleet
    Hampshire
    Amministratore
    1 Browning Road
    GU13 0YJ Fleet
    Hampshire
    British74298850001

    MONARCH REALISATIONS 12 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 02 dic 1994
    Consegnato il 20 dic 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors (as defined) to the chargee pursuant to the terms of each finance document (as defined) and to the ancillary bank (as defined) under each ancillary document (as defined) to which any obligor is a party
    Brevi particolari
    First floating charge all undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 giu 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 15 dic 1992
    Consegnato il 23 dic 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due from each obligor to the chargee (as agent), the banks (or any of them) and the chargee (in this capacity the"ancillary bank") on any account whatsoever under the terms of the finance documents to which such obligor is a party
    Brevi particolari
    (For full details see form 395 tc ref: M46). A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 23 dic 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 gen 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Aircraft mortgage
    Creato il 16 ago 1988
    Consegnato il 18 ago 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £831,980 due forom the company to forward trust limited or any account whatsoever
    Brevi particolari
    One - cessna 550 citation ii aircraft reg. Marks g-jetb serial no 550-0288 and equipped with JT15D/4 (two) engines serial no's 70844 and 70852. all spare engines, parts, components and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Forward Trust Limited
    Transazioni
    • 18 ago 1988Registrazione di un'ipoteca
    Aircraft mortgage
    Creato il 23 gen 1987
    Consegnato il 26 gen 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £501,300
    Brevi particolari
    One used as 355FI ecurevil helicopter reg marks g - cnet serial no:- 5120 and aquipped with alison 250 C20F (please see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Forward Trust Limited
    Transazioni
    • 26 gen 1987Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0