NEWINCCO 838 LIMITED

NEWINCCO 838 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàNEWINCCO 838 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01926825
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di NEWINCCO 838 LIMITED?

    • (7011) /

    Dove si trova NEWINCCO 838 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Clock House
    87 Paines Lane
    HA5 3BZ Pinner
    Middlesex
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di NEWINCCO 838 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SPECIALITY SHOPS LIMITED25 lug 198525 lug 1985
    CONSULGATE PUBLIC LIMITED COMPANY27 giu 198527 giu 1985

    Quali sono gli ultimi bilanci di NEWINCCO 838 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2006

    Quali sono le ultime deposizioni per NEWINCCO 838 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    10 pagine4.71

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 17 nov 2012

    6 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 17 mag 2012

    6 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 17 nov 2011

    6 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 17 mag 2011

    6 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 17 nov 2010

    6 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 17 mag 2010

    6 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 17 nov 2009

    6 pagine4.68

    legacy

    2 pagine403a

    legacy

    1 pagine287

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 18 nov 2008

    LRESSP

    legacy

    3 pagine363a

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed speciality shops LIMITED\certificate issued on 09/06/08
    2 pagineCERTNM

    legacy

    5 pagine363a

    Bilancio redatto al 30 set 2006

    13 pagineAA

    legacy

    5 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 mar 2005

    13 pagineAA

    legacy

    1 pagine225

    legacy

    5 pagine363a

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288c

    Chi sono gli amministratori di NEWINCCO 838 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PORTMAN ADMINISTRATION 1 LIMITED
    6th Floor Lansdowne House
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    Segretario
    6th Floor Lansdowne House
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    93189540002
    PORTMAN ADMINISTRATION 1 LIMITED
    6th Floor Lansdowne House
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    Amministratore
    6th Floor Lansdowne House
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    93189540002
    PORTMAN ADMINISTRATION 2 LIMITED
    6th Floor Lansdowne House
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    Amministratore
    6th Floor Lansdowne House
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    88224330004
    GOLDSOBEL, Howard
    34 Elliott Square
    NW3 3SU London
    Segretario
    34 Elliott Square
    NW3 3SU London
    British57132180003
    GURKIN, Nigel David
    22 Alacross Road
    Ealing
    W5 4HT London
    Segretario
    22 Alacross Road
    Ealing
    W5 4HT London
    British53087320002
    LINDOP, David John
    81 Sandy Lane
    SM2 7EP Cheam
    Surrey
    Segretario
    81 Sandy Lane
    SM2 7EP Cheam
    Surrey
    British56666280001
    MOSS, Andrew Graham
    244 Willesden Lane
    NW2 5RE London
    Segretario
    244 Willesden Lane
    NW2 5RE London
    British4573140002
    ELLIOTT, Graeme Arthur
    Flat 2
    39 Elm Park Gardens
    SW10 9QF London
    Amministratore
    Flat 2
    39 Elm Park Gardens
    SW10 9QF London
    British40491120001
    EMMETT, Graham Anthony Johnathan
    Rushmead
    Leigh Place
    KT11 2HL Cobham
    Surrey
    Amministratore
    Rushmead
    Leigh Place
    KT11 2HL Cobham
    Surrey
    British66041940002
    FEENEY, Michael Howard
    34 Money Hill Road
    WD3 7EQ Rickmansworth
    Herts
    Amministratore
    34 Money Hill Road
    WD3 7EQ Rickmansworth
    Herts
    United KingdomBritish6727860001
    GARLICK, John Simon
    14 Brassey Hill
    RH8 0ES Limpsfield
    Surrey
    Amministratore
    14 Brassey Hill
    RH8 0ES Limpsfield
    Surrey
    EnglandBritish84134650001
    GOSWELL, Paul Jonathan
    Mulberry Lodge
    Mill Hill Barnes
    SW13 0HS London
    Amministratore
    Mulberry Lodge
    Mill Hill Barnes
    SW13 0HS London
    United KingdomBritish60475780002
    GURKIN, Nigel
    40 Hamilton Court
    Hamilton Road
    W5 2EJ Ealing
    Amministratore
    40 Hamilton Court
    Hamilton Road
    W5 2EJ Ealing
    British53087320001
    HADEN SCOTT, Timothy
    6 Russell Hill
    CR8 2JA Purley
    Surrey
    Amministratore
    6 Russell Hill
    CR8 2JA Purley
    Surrey
    British63220740001
    HOUGHTON, David John
    605 Gilbert House
    Barbican
    EC2Y 8BD London
    Amministratore
    605 Gilbert House
    Barbican
    EC2Y 8BD London
    EnglandBritish1605090002
    JAFFE, Stephen Richard
    14 Park Avenue
    SW14 8AT London
    Amministratore
    14 Park Avenue
    SW14 8AT London
    EnglandUnited Kingdom12701960001
    LINDOP, David John
    81 Sandy Lane
    SM2 7EP Cheam
    Surrey
    Amministratore
    81 Sandy Lane
    SM2 7EP Cheam
    Surrey
    British56666280001
    MCDONALD, Peter Stuart
    Limes Farmhouse
    Upper Lambourn
    RG17 8RG Hungerford
    Berkshire
    England
    Amministratore
    Limes Farmhouse
    Upper Lambourn
    RG17 8RG Hungerford
    Berkshire
    England
    British77781180003
    MCDONALD, Peter Stuart
    4 St Stephens Terrace
    SW8 1DH London
    Amministratore
    4 St Stephens Terrace
    SW8 1DH London
    British77781180001
    MCLEAN, Simon
    Winslade Park
    EX5 1DS Exeter
    Amministratore
    Winslade Park
    EX5 1DS Exeter
    British12676480004
    RAZZALL, Edward Timothy
    9b Landsdowne Walk
    W11 9LN London
    Amministratore
    9b Landsdowne Walk
    W11 9LN London
    British72530280002
    RICHARDS, Roderick Lamont
    34 Findlay Street
    Fulham
    SW6 6HD London
    Amministratore
    34 Findlay Street
    Fulham
    SW6 6HD London
    British1996340001
    RITBLAT, James William Jeremy
    24 St Petersburgh Place
    W2 4LB London
    Amministratore
    24 St Petersburgh Place
    W2 4LB London
    EnglandBritish38424950003
    TIDY, Thomas Peter
    35 Wyatt Drive
    SW13 8AL London
    Amministratore
    35 Wyatt Drive
    SW13 8AL London
    British21430260001
    WAGMAN, Colin Barry
    North Lodge
    25 Ringwood Avenue
    N2 9NT London
    Amministratore
    North Lodge
    25 Ringwood Avenue
    N2 9NT London
    United KingdomBritish39329840001

    NEWINCCO 838 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge of shares
    Creato il 09 lug 2004
    Consegnato il 19 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due of the borrower and the guarantors to the chargee whether on its own account or on behalf of any of the security beneficiaries) or to the other security beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All its present and future right, title and interest in and to all the charged securities which are at any time owned by it from time to time or in which it has an interest to the extent of such interest together with all related rights from time to time accruing to those charged securities and all rights which it may have at any time against any clearance or settement system or custodian in respect of any charged investments;. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bradford & Bingley PLC
    Transazioni
    • 19 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 mar 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge of shares
    Creato il 02 giu 2004
    Consegnato il 10 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrowers and the guarantors to the chargee whether on its own account or on behalf of any of the security beneficiaries or to the other security beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    First fixed charge all its present and future right title and interest in the charged securities and all related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bradford & Bingley PLC (Security Trustee)
    Transazioni
    • 10 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage of shares
    Creato il 26 feb 2001
    Consegnato il 08 mar 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee under each finance document (as defined)
    Brevi particolari
    The shares,all dividends payable and all stocks,securities,rights,moneys or property. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft,London Branch
    Transazioni
    • 08 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 feb 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 26 mar 1999
    Consegnato il 07 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    35 south street bishops stortford hertfordshire t/n HD273464. All fixtures and fittings and all fixed plant and machinery (not being chattels within the meaning of the bills of sale acts). A floating charge over all unfixed plant and machinery and other chattels and equipment and assigns the goodwill of the business carried on at or from the property and the benefit of the licence or certificate the right to recover and receive any compensation payable in respect of the licence or certificate.
    Persone aventi diritto
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transazioni
    • 07 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage of shares
    Creato il 22 gen 1999
    Consegnato il 01 feb 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities due from each obligor (as defined), each junior creditor (as defined) and speciality shops birkenhead investments limited to the chargee under each finance document (as defined)
    Brevi particolari
    All the shares in speciality shops (clapham) limited and all dividends paid or payable on all or any of the shares and all stocks shares securities rights moneys or property accruing. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypo- Und Vereinsbank Aktiengesellschaft, London Branch
    Transazioni
    • 01 feb 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 26 mag 1998
    Consegnato il 12 giu 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The advance (as therein defined) and all other sums due or to become due from the company to the chargee under or in accordance with the loan dcouments (as terein defined)
    Brevi particolari
    The f/h property k/a units 1, 2 and 3 portrack lane retail park haverton hill road stockton on tees t/n's TES25607, CE16605 and CE10032 and all fixtures fixed plant and machinery thereon and a floating charge the goodwill and all rents. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • The Canada Life Assurance Company
    Transazioni
    • 12 giu 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment and charge
    Creato il 26 mag 1998
    Consegnato il 12 giu 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    The benefit of all rights actions and claims pursuant to the warranty agreements by the following contractors: marshall construstion (west yorkshire) limited; hull smith building design limited; jordan pritchard gorman limited; norwest holst soil engineering limited; northern cladding limied; compass engineering limited, fws consultants.
    Persone aventi diritto
    • The Cananda Life Assurance Company
    Transazioni
    • 12 giu 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deposit agreement
    Creato il 23 mar 1998
    Consegnato il 01 apr 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £7,791,434.63 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The cash sum of £7,791,434.63 together with all interest accruing thereon.
    Persone aventi diritto
    • The Canada Life Assurance Company
    Transazioni
    • 01 apr 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 feb 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 13 mar 1997
    Consegnato il 21 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 3A south street bishops stortford hertfordshire t/no HD273464 and the proceeds of sale thereof together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 lug 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 13 mar 1997
    Consegnato il 21 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a land and buildings on the west side of montpellier street cheltenham gloucestershire t/no GR74505 and the proceeds of sale thereof together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter
    Creato il 16 gen 1997
    Consegnato il 23 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies, liabilities and obligations, whether certain or contingent which at the date of the letter or thereafter may be or become due and owing by the company and each and every charging company (as defined) and guarantor, but without duplication, to the chargee under or pursuant to the overdraft facility letter, the counter-indemnity and, as the case may be, the debenture, the letter and/or any other security document (all as defined)
    Brevi particolari
    The same property as is mortgaged or charged under the debenture dated 31ST may 1994.
    Persone aventi diritto
    • The Co-Operative Bank PLC (The "Overdraft Bank")
    Transazioni
    • 23 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Intercreditor deed
    Creato il 16 gen 1997
    Consegnato il 22 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future liabilities (actual or contingent) payable or owing by the borrower speciality shops (birkenhead) limited to the chargee under or in connection with the senior finance documents
    Brevi particolari
    F/H land comprised in t/n: MS353050 being the pyramids shopping centre and car park birkenhead situated at 150 borough road birkenhead wirral. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypotheken- Und Wechsel-Bank Aktiengesellschaft
    Transazioni
    • 22 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 07 gen 1997
    Consegnato il 21 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land on the south side of mountergate norwich t/n: NK179862 and f/h land on the north east side of king street norwich t/n: NK187796 together with all fixtures and fittings fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transazioni
    • 21 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Interceditor deed
    Creato il 07 giu 1996
    Consegnato il 13 giu 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future liabilities due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the senior finance documents (as defined)
    Brevi particolari
    Victoria place shopping centre buckingham palace road london SW1. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypotheken -Und Wechsel-Bank Aktiengesellschaft
    Transazioni
    • 13 giu 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 03 giu 1996
    Consegnato il 04 giu 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All sums of money in any currency deposited or paid to the credit of the accounts designated as speciality shops PLC account number 20020167 at unity trust bank PLC. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transazioni
    • 04 giu 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage of shares
    Creato il 23 mag 1996
    Consegnato il 28 mag 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from speciality shops (stortford) limited to deutsche hypothekenbank (actien-gesellschaft) on any account whatsoever under each finance document (as defined)
    Brevi particolari
    All shares,dividends payable and all stocks,securities,rights and other income. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft)
    Transazioni
    • 28 mag 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 28 feb 1996
    Consegnato il 11 mar 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a 25 & 26 berkeley square clifton bristol t/no:- AV149524 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 11 mar 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 28 feb 1996
    Consegnato il 11 mar 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a 28 to 30 berkley square clifton bristol t/no:- AV118643 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 11 mar 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 28 feb 1996
    Consegnato il 11 mar 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a 27 berkeley square clifton bristol t/no:- AV149525 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 11 mar 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 28 feb 1996
    Consegnato il 11 mar 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    And the proceeds of sale thereof of the f/h property k/a the berkeleey centre 15 17 and 19 queens road bristol t/no:- AV118638. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 11 mar 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental legal mortgage
    Creato il 27 gen 1995
    Consegnato il 08 feb 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the co-operative bank P.L.C. as agent and trustee of the security for the secured parties (as defined) pursuant to the facility agreement,the deed and/or any other security document (all as defined)
    Brevi particolari
    All that f/h property on the south west side of the causeway,bishops stortford,hertfordshire.t/no.hd 239272.all that f/h property k/as the dells,south street,bishop's stortford,hertfordshire.t/no.HD239681.all that f/h property k/as 3A south street,bishop's stortford,hertfordshire.t/no.HD273464 together with all buildings,fixtures and fixed plant and machinery and any proceeds of sale thereof.
    Persone aventi diritto
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transazioni
    • 08 feb 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security presented for registration in scotland
    Creato il 15 giu 1994
    Consegnato il 23 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    One half share pro indiviso of waverley shopping centre princes street edinburgh.
    Persone aventi diritto
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transazioni
    • 23 giu 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 31 mag 1994
    Consegnato il 16 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargees under the terms of the facility agreement dated 27TH april 1994 and the "security documents" (as defined therein)
    Brevi particolari
    Various properties as specified in form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Co-Operative Bank P.L.C.as Agent and Trustee for the Secured Parties
    Transazioni
    • 16 giu 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 lug 1996Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 04 lug 1996Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 27 ott 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over cash cover account
    Creato il 31 mag 1994
    Consegnato il 16 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All rights title & interest in the charged account & the charged balance. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transazioni
    • 16 giu 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 22 dic 1993
    Consegnato il 05 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land t/n GR74505 k/a land and buildings on the west side of montpelier street cheltenham gloucstershire and by way of floating charge all unfixed plant and machinery and other chattels and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transazioni
    • 05 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    NEWINCCO 838 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    15 apr 2013Data di scioglimento
    18 nov 2008Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Ian David Holland
    Ian Holland & Co
    The Clock House
    HA5 3BZ 87 Paines Lane
    Pinner Middlesex
    Praticante
    Ian Holland & Co
    The Clock House
    HA5 3BZ 87 Paines Lane
    Pinner Middlesex

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0