CORINTHIAN MARKETING LIMITED

CORINTHIAN MARKETING LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCORINTHIAN MARKETING LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01930303
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CORINTHIAN MARKETING LIMITED?

    • (3650) /

    Dove si trova CORINTHIAN MARKETING LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    81 Station Road
    SL7 1NS Marlow
    Bucks
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CORINTHIAN MARKETING LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CORINTHIAN TRADING COMPANY LIMITED(THE)12 lug 198512 lug 1985

    Quali sono gli ultimi bilanci di CORINTHIAN MARKETING LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per CORINTHIAN MARKETING LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    21 pagineLIQ14

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 03 lug 2015

    22 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 03 lug 2016

    23 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 03 lug 2014

    23 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 03 lug 2013

    20 pagine4.68

    Domanda di insolvenza

    Insolvency:release liquidator 05/04/2013
    1 pagineLIQ MISC

    Domanda di insolvenza

    Insolvency:release liquidator 05/04/2013
    1 pagineLIQ MISC

    Indirizzo della sede legale modificato da * First Floor Davidson House Forbury Square Reading Berkshire RG1 3EU* in data 04 apr 2013

    2 pagineAD01

    Avviso di cessazione di funzioni come liquidatore volontario

    1 pagine4.40

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 03 lug 2012

    17 pagine4.68

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    1 pagine2.34B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B/2.15B

    10 pagine2.16B

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    1 pagineF2.18

    Cessazione della carica di Andrew Speed come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Nigel Kay come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Simon Shaw come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di John Hughes come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Mark Stinchcombe come segretario

    1 pagineTM02

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Indirizzo della sede legale modificato da * Dralda House 24-28 Crendon Street High Wycombe Buckinghamshire HP13 6LS United Kingdom* in data 18 apr 2011

    2 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 14 giu 2010 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 lug 2010

    Stato del capitale al 08 lug 2010

    • Capitale: GBP 59,901
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    18 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di CORINTHIAN MARKETING LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SPEED, Christopher Paul
    Groves Barn
    Church Road, Penn
    HP10 8NX High Wycombe
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Groves Barn
    Church Road, Penn
    HP10 8NX High Wycombe
    Buckinghamshire
    EnglandBritish7012850007
    STINCHCOMBE, Mark Andrew
    14 Gossmore Walk
    SL7 1QZ Marlow
    Buckinghamshire
    Amministratore
    14 Gossmore Walk
    SL7 1QZ Marlow
    Buckinghamshire
    EnglandBritish40925690003
    GORDON, Keith William
    Yewden Manor
    Mill End
    RG9 6JR Henley
    Oxon
    Segretario
    Yewden Manor
    Mill End
    RG9 6JR Henley
    Oxon
    British57591420001
    HALL, Norman Ronald
    1 Hartwell Road
    NN7 2NT Roade
    Northamptonshire
    Segretario
    1 Hartwell Road
    NN7 2NT Roade
    Northamptonshire
    British98926570001
    JEEWON, Sudesh
    16 Earl Close
    HP13 5EH High Wycombe
    Buckinghamshire
    Segretario
    16 Earl Close
    HP13 5EH High Wycombe
    Buckinghamshire
    British96447210001
    KIMBERLEY, Steven John
    50 Corfe Way
    GU14 6TS Farnborough
    Hampshire
    Segretario
    50 Corfe Way
    GU14 6TS Farnborough
    Hampshire
    British57587690001
    STINCHCOMBE, Mark Andrew
    14 Gossmore Walk
    SL7 1QZ Marlow
    Buckinghamshire
    Segretario
    14 Gossmore Walk
    SL7 1QZ Marlow
    Buckinghamshire
    British40925690003
    BAYLEY, Trevor Keith
    Lyndhurst
    Rutland Road
    SL6 4HZ Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    Lyndhurst
    Rutland Road
    SL6 4HZ Maidenhead
    Berkshire
    British76853100002
    BURGIN, Christopher
    Grange Barrow House
    Beckhampton
    SN8 1QR Marlborough
    Wiltshire
    Amministratore
    Grange Barrow House
    Beckhampton
    SN8 1QR Marlborough
    Wiltshire
    EnglandBritish68621460003
    EXCELL, Richard Michael
    Whitefield House
    Whitefield
    TA4 2UW Wiveliscombe
    Somerset
    Amministratore
    Whitefield House
    Whitefield
    TA4 2UW Wiveliscombe
    Somerset
    United KingdomBritish82905180002
    HALL, Norman Ronald
    1 Hartwell Road
    NN7 2NT Roade
    Northamptonshire
    Amministratore
    1 Hartwell Road
    NN7 2NT Roade
    Northamptonshire
    United KingdomBritish98926570001
    HUGHES, John Barry
    The Green
    SL1 7BG Burnham
    19
    Berkshire
    Amministratore
    The Green
    SL1 7BG Burnham
    19
    Berkshire
    EnglandBritish161093820001
    KAY, Nigel
    Thrupps Lane
    KT12 4LX Hersham
    33
    Surrey
    Amministratore
    Thrupps Lane
    KT12 4LX Hersham
    33
    Surrey
    EnglandBritish128808330001
    MORRISON, Joseph Francis
    571 36th Street
    Manhattan Beach
    California
    Usa
    Amministratore
    571 36th Street
    Manhattan Beach
    California
    Usa
    American54111010001
    SHAW, Simon Marc
    Southfield Road
    Downley
    HP13 5JZ High Wycombe
    1
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Southfield Road
    Downley
    HP13 5JZ High Wycombe
    1
    Buckinghamshire
    EnglandBritish128825610001
    SHAW, Simon Park
    91 Gantshill Crescent
    Gants Hill
    IG2 6TR Ilford
    Essex
    Amministratore
    91 Gantshill Crescent
    Gants Hill
    IG2 6TR Ilford
    Essex
    British28119550001
    SPEED, Andrew James
    Sandelswood End
    HP9 2AQ Beaconsfield
    44
    Bucks
    England
    Amministratore
    Sandelswood End
    HP9 2AQ Beaconsfield
    44
    Bucks
    England
    EnglandBritish123472580002
    SPEED, Geoffrey
    Pewsey Cottage Church Road
    Penn
    HP10 8NX High Wycombe
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Pewsey Cottage Church Road
    Penn
    HP10 8NX High Wycombe
    Buckinghamshire
    British44135890001
    STINCHCOMBE, Mark Andrew
    14 Gossmore Walk
    SL7 1QZ Marlow
    Buckinghamshire
    Amministratore
    14 Gossmore Walk
    SL7 1QZ Marlow
    Buckinghamshire
    EnglandBritish40925690003

    CORINTHIAN MARKETING LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    All assets debenture
    Creato il 09 dic 2009
    Consegnato il 10 dic 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 10 dic 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Share pledge
    Creato il 14 mar 2008
    Consegnato il 28 mar 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The entire right, title and interest in and to the shares held in corinthian marketing hk LTD, see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 28 mar 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 14 mar 2008
    Consegnato il 18 mar 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 18 mar 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 10 apr 2006
    Consegnato il 13 apr 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 13 apr 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Invoice finance agreement
    Creato il 18 gen 2001
    Consegnato il 26 gen 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the invoice finance agreement
    Brevi particolari
    By way of all book and other debts, revenues and claims both present and future and all things in action due or owing, or which may be due and owing to or purchased or owned by the company which have not vested in the lender pursuant to the invoice finance agreement.
    Persone aventi diritto
    • Davenham Trade Finance Limited
    Transazioni
    • 26 gen 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 29 nov 2000
    Consegnato il 30 nov 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed equitable charge all estate or interest in any f/h or l/h property..fixed charge its uncalled capital, goodwill and book debts etc..floating charge all other undertaking and assets of the company.
    Persone aventi diritto
    • Davenham Trade Finance Limited
    Transazioni
    • 30 nov 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 23 giu 2000
    Consegnato il 14 set 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £36,000 due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The interest of the company in a deposit account into which the sum of £36,000 has been deposited and otherwise on the terms as mentioned in the rent deposit deed.
    Persone aventi diritto
    • Degussa Limited
    Transazioni
    • 14 set 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 03 feb 1998
    Consegnato il 06 feb 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the debenture
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Mercury Asset Management PLC(As Agent and the Trustee for the Lenders as Efined in the Debenture)
    Transazioni
    • 06 feb 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 nov 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 30 gen 1998
    Consegnato il 04 feb 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 04 feb 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 nov 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed equitable charge
    Creato il 27 lug 1994
    Consegnato il 30 lug 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All book debts invoice debts accounts notes bills acceptances and/or other forms of obligation. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Griffin Factors Limited
    Transazioni
    • 30 lug 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 dic 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 03 set 1990
    Consegnato il 14 set 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 14 set 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 04 nov 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 29 set 1989
    Consegnato il 09 ott 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 ott 1989Registrazione di un'ipoteca

    CORINTHIAN MARKETING LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    06 apr 2011Inizio dell'amministrazione
    04 lug 2011Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Gareth Wyn Roberts
    Davidson House Forbury Square
    RG1 3EU Reading
    Berkshire
    Praticante
    Davidson House Forbury Square
    RG1 3EU Reading
    Berkshire
    Paul Ellison
    First Floor Davidson House
    Forbury Square
    RG1 3EU Reading
    Berkshire
    Praticante
    First Floor Davidson House
    Forbury Square
    RG1 3EU Reading
    Berkshire
    2
    DataTipo
    04 lug 2011Inizio della liquidazione
    12 ott 2017Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Gareth Wyn Roberts
    Davidson House Forbury Square
    RG1 3EU Reading
    Berkshire
    Praticante
    Davidson House Forbury Square
    RG1 3EU Reading
    Berkshire
    Paul Ellison
    First Floor Davidson House
    Forbury Square
    RG1 3EU Reading
    Berkshire
    Praticante
    First Floor Davidson House
    Forbury Square
    RG1 3EU Reading
    Berkshire
    Francis F A Wessely
    Rsm Tenon Restructuring
    81 Station Road
    SL7 1NS Marlow
    Bucks
    Praticante
    Rsm Tenon Restructuring
    81 Station Road
    SL7 1NS Marlow
    Bucks
    Peter James Hughes-Holland
    Rsm Tenon Restructuring
    81 Station Road
    SL7 1NS Marlow
    Bucks
    Praticante
    Rsm Tenon Restructuring
    81 Station Road
    SL7 1NS Marlow
    Bucks

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0