IMEX SPACES LIMITED

IMEX SPACES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàIMEX SPACES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01931478
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di IMEX SPACES LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova IMEX SPACES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Olympia House
    Armitage Road
    NW11 8RQ London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di IMEX SPACES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    I-MEX PROPERTIES LTD23 mag 198923 mag 1989
    DOVEARCH LIMITED18 lug 198518 lug 1985

    Quali sono gli ultimi bilanci di IMEX SPACES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per IMEX SPACES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    4 pagine4.71

    Indirizzo della sede legale modificato da Nations House 103 Wigmore Street London W1U 1AE in data 11 ott 2010

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 28 set 2010

    LRESSP

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Cessazione della carica di Philip Warner come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 mar 2009

    12 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 mar 2008

    11 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 mar 2007

    12 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 mar 2006

    18 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288c

    Risoluzioni

    Resolutions
    pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    resolution

    Deliberazione elettiva

    ELRES

    Chi sono gli amministratori di IMEX SPACES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LANCHESTER, David James
    1 Holly Close
    IG9 6HT Buckhurst Hill
    Essex
    Segretario
    1 Holly Close
    IG9 6HT Buckhurst Hill
    Essex
    British7014460002
    KEOGH, Mark William
    Norfolk House 28 Kidmore Road
    Caversham
    RG4 7LU Reading
    Amministratore
    Norfolk House 28 Kidmore Road
    Caversham
    RG4 7LU Reading
    EnglandIrish62140690001
    VAGHELA, Vinod Bachulal
    99 Cathles Road
    Balham
    SW12 9LF London
    Amministratore
    99 Cathles Road
    Balham
    SW12 9LF London
    EnglandBritish5689250001
    DRYSDALE, Clive Douglas
    The Hollies
    Bath Road
    SL6 4LH Maidenhead
    Berkshire
    Segretario
    The Hollies
    Bath Road
    SL6 4LH Maidenhead
    Berkshire
    British45345090004
    LOWES, Richard Phillip
    2 Westcott Keep
    RH6 9US Horley
    Surrey
    Segretario
    2 Westcott Keep
    RH6 9US Horley
    Surrey
    British5785520001
    NORRIS, Patricia Pamela
    Flat 6 Broadlands Lodge
    Broadlands Road Highgate
    N6 4AW London
    Segretario
    Flat 6 Broadlands Lodge
    Broadlands Road Highgate
    N6 4AW London
    British4318800001
    TAYLOR-SMITH, Kim David Spencer
    White Lodge
    338 Upper Richmond Road
    SW15 6TL London
    Segretario
    White Lodge
    338 Upper Richmond Road
    SW15 6TL London
    British78391680002
    ARONSOHN, Norman Edward
    1 Ardwick Road
    NW2 2BX London
    Amministratore
    1 Ardwick Road
    NW2 2BX London
    United KingdomBritish6647720001
    BETTS, David Richard
    Apartment 58
    Ragged Staff Wharf
    Queensway
    Gibraltar
    Amministratore
    Apartment 58
    Ragged Staff Wharf
    Queensway
    Gibraltar
    SpainBritish80803300001
    CHAPMAN, Robert William Thomas
    16 Dunton Close
    Four Oaks
    B75 5QD Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    16 Dunton Close
    Four Oaks
    B75 5QD Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandBritish32652350001
    COLLINS, Peter William
    The Oaks
    23 Croft Road
    RG40 3HX Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    The Oaks
    23 Croft Road
    RG40 3HX Wokingham
    Berkshire
    United KingdomBritish26086560001
    CRAN, William Michael
    16 Ashleigh Dale
    Birkby
    HD2 2DL Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    16 Ashleigh Dale
    Birkby
    HD2 2DL Huddersfield
    West Yorkshire
    British5206400002
    DIGHTON, Simon Gerald
    28 Lightwoods Hill
    Bearwood
    B67 5EA Warley
    West Midlands
    Amministratore
    28 Lightwoods Hill
    Bearwood
    B67 5EA Warley
    West Midlands
    United KingdomBritish78151560001
    DRYSDALE, Clive Douglas
    The Hollies
    Bath Road
    SL6 4LH Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    The Hollies
    Bath Road
    SL6 4LH Maidenhead
    Berkshire
    EnglandBritish45345090004
    GLEGHORN, Keith William
    Royd Top Broad Lane
    Upperthong Holmfirth
    HD7 1LS Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    Royd Top Broad Lane
    Upperthong Holmfirth
    HD7 1LS Huddersfield
    West Yorkshire
    British43071440002
    GOULD, Bernard David
    76 Woodhill Crescent
    Kenton
    HA3 0LZ Harrow
    Middlesex
    Amministratore
    76 Woodhill Crescent
    Kenton
    HA3 0LZ Harrow
    Middlesex
    British4021030001
    HEATHWOOD, Derek Kevin
    47 Fullarton Crescent
    KA10 6LL Troon
    South Ayrshire
    Amministratore
    47 Fullarton Crescent
    KA10 6LL Troon
    South Ayrshire
    British85468580002
    HERRITTY, Jayne
    17 Paradise Lane
    Hall Green
    B28 0DY Birmingham
    Amministratore
    17 Paradise Lane
    Hall Green
    B28 0DY Birmingham
    British45641090001
    HINE, Derek Leslie
    8 Showell Close
    Westwood Court
    WR9 8UQ Droitwich
    Worcestershire
    Amministratore
    8 Showell Close
    Westwood Court
    WR9 8UQ Droitwich
    Worcestershire
    British29871470001
    JONES, Morgan Lewis
    4 Camden Close
    BR7 5PH Chislehurst
    Kent
    Amministratore
    4 Camden Close
    BR7 5PH Chislehurst
    Kent
    EnglandBritish10146340003
    KIRKWOOD, Stuart Watson
    The Granary Malthouse Farm
    Evesham Road Cookhill
    B49 5LJ Alcester
    Warwickshire
    Amministratore
    The Granary Malthouse Farm
    Evesham Road Cookhill
    B49 5LJ Alcester
    Warwickshire
    British76937270002
    LOWES, Richard Phillip
    2 Westcott Keep
    RH6 9US Horley
    Surrey
    Amministratore
    2 Westcott Keep
    RH6 9US Horley
    Surrey
    EnglandBritish5785520001
    MEADE, Karl Robert
    Holly Mount
    Penn Road
    HP9 2TS Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Holly Mount
    Penn Road
    HP9 2TS Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritish118074370001
    MOORE, Richard
    88 Alzey Gardens
    AL5 5SZ Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    88 Alzey Gardens
    AL5 5SZ Harpenden
    Hertfordshire
    British73793650001
    SALMON, Steven Kenneth
    Oakridge 8 Carters Close
    B61 7HJ Bromsgrove
    Worcestershire
    Amministratore
    Oakridge 8 Carters Close
    B61 7HJ Bromsgrove
    Worcestershire
    British66565200002
    SHERRATT, Peter John
    23 Fiery Hill Road
    Barnt Green
    B45 8LD Birmingham
    Amministratore
    23 Fiery Hill Road
    Barnt Green
    B45 8LD Birmingham
    British52526530002
    SMITH, Nicholas Paul
    Scrag Oak
    TN5 6NP Wadhurst
    Sussex
    Amministratore
    Scrag Oak
    TN5 6NP Wadhurst
    Sussex
    United KnigdomBritish32981540001
    STEVENS, Michael John
    32 Woodfield Park
    HP6 5QH Amersham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    32 Woodfield Park
    HP6 5QH Amersham
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish60348780002
    STEVENSON, Roland
    24 Miranda Drive
    Heathcote
    CV34 6FE Warwick
    Warwickshire
    Amministratore
    24 Miranda Drive
    Heathcote
    CV34 6FE Warwick
    Warwickshire
    British1160500003
    STOKES, Thomas Mcnair
    17 Arran View
    Stewarton
    KA3 5EX Kilmarnock
    Ayrshire
    Amministratore
    17 Arran View
    Stewarton
    KA3 5EX Kilmarnock
    Ayrshire
    British854380001
    TAYLOR, Margaret
    15 Capesthorne Close
    Holmes Chapel
    CW4 7EN Crewe
    Cheshire
    Amministratore
    15 Capesthorne Close
    Holmes Chapel
    CW4 7EN Crewe
    Cheshire
    British64610720001
    TAYLOR-SMITH, Kim David Spencer
    White Lodge
    338 Upper Richmond Road
    SW15 6TL London
    Amministratore
    White Lodge
    338 Upper Richmond Road
    SW15 6TL London
    British78391680002
    WARNER, Philip Courtenay Thomas, Sir
    Marden Grange
    Marden
    SN10 3RQ Devizes
    Wiltshire
    Amministratore
    Marden Grange
    Marden
    SN10 3RQ Devizes
    Wiltshire
    United KingdomBritish7356840001
    WATSON, Ian Richard
    Old Dove House
    Annables Lane
    AL5 3PR Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    Old Dove House
    Annables Lane
    AL5 3PR Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish68256540001

    IMEX SPACES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security agreement
    Creato il 22 lug 2005
    Consegnato il 04 ago 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Colville business centre, goliath way, hermitage estate, colville t/n LT300425 south side of waingate, lower clough, linthwaite, hudderfield t/n WYK187697 land lying to the south of waingate, lower clough, linthwaite, hudderfield t/n WYK591854. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC (The "Agent") as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 04 ago 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mezzanine security agreement
    Creato il 22 lug 2005
    Consegnato il 01 ago 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each mezzanine obligor to the lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first legal mortgage, all estates or interest in any real property being colville business centre, goliath way, hermitage estate for further property charged please refer to the form 395 by way of fixed charge its interests in all investments now or subsequently held by it. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Warner Estate, Limited
    Transazioni
    • 01 ago 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 03 set 2004
    Consegnato il 07 set 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Gresley road, south western industrial estate, peterlee t/no DU191311 (f/h); site 1, glenfield business park, philips road, blackburn, lancashire t/nos LA524845 LA562580 (l/h) spring hall mills, mile cross road, halifax t/no WYK51717 (f/h) for details of further properties charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 07 set 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 10 september 2003 and
    Creato il 31 lug 2003
    Consegnato il 25 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from zipmodes to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All and whole the subjects k/a and forming traction house situated on the south side of hamilton road motherwell t/no LAN26055.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 25 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 10 september 2003 and
    Creato il 31 lug 2003
    Consegnato il 25 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from zipmodes to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All and whole the subjects k/a and forming motherwell business centre lying to the southwest side of dalziel street the southeast side of coursington road and northwest side of albert street motherwell t/no LAN136913.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 25 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 10 september 2003 and
    Creato il 31 lug 2003
    Consegnato il 25 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from zipmodes to the chargee
    Brevi particolari
    All and whole the subjects k/a and forming block 3 greenhill industrial estate coltswood road coatbridge t/no LAN53581.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 25 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 10 september 2003 and
    Creato il 31 lug 2003
    Consegnato il 25 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from zipmodes to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All and whole the subjects on the south side of main street coatbridge t/nos LAN74818 and LAN45798.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 25 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 10 september 2003 and
    Creato il 31 lug 2003
    Consegnato il 25 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from zipmodes to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All and whole the subjects known formerly as plot 10 and now as imex spaces business centre broadleys business park stirling t/no stg 39416.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 25 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 10 september 2003 and
    Creato il 31 lug 2003
    Consegnato il 25 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from zipmodes to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All and whole that plot or area of ground k/a and forming plot 2 carnegie campus dunfermline in the county of fife t/no ffe 44170.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 25 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 31 lug 2003
    Consegnato il 13 ago 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from zipmodes limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 ago 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A standard security which was presented in scotland for registration on 30 september 2002 and
    Creato il 24 set 2002
    Consegnato il 18 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All and whole the subjects on the south side of hamilton road, motherwell and registered in the land register of scotland under t/no. Lan 26055.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 18 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 set 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A standard security which was presented in scotland for registration on 30 september 2002 and
    Creato il 24 set 2002
    Consegnato il 18 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All and whole the subjects extending to seventy six decimal or one hundredth parts of a hectare (0.76 hectares) or thereby at carnegie campus, dunfermline registered in the land registry of scotland under t/no. Ffe 44170.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 18 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 set 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 23 set 2002
    Consegnato il 01 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge and all monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (As Agent and Trustee for Each of the Secured Parties)
    Transazioni
    • 01 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 set 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 29 feb 2000
    Consegnato il 13 mar 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent, whether owed jointly, severally or in any other capacity whatsoever and whether originally incurred by the company or by some other person) of the obligors (as defined) to the chargee (as trustee for the beneficiaries under (and as defined in) the trust agreement (as defined)) (or any of them) under each of the finance documents (as defined)
    Brevi particolari
    By way of first legal mortgage the mortgage property (as defined), assigns all right title and interest to in and under all present and future collateral agreements to real property, licences granted to the company in respect of the real property, insurance policies and all proceeds paid or payable thereunder, first fixed charge all present and future assets, first floating charge all that heritable property of the company physically situated on the real property in scotland. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 mar 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 gen 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Second ranking debenture
    Creato il 29 feb 2000
    Consegnato il 13 mar 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent, whether owed jointly, severally or in any other capacity whatsoever and whether originally incurred by the company or by some other person) of the obligors (as defined) to the chargee (as trustee for the beneficiaries under (and as defined in) the trust agreement (as defined)) (or any of them) under each of the finance documents (as defined)
    Brevi particolari
    By way of second legal mortgage the mortgage property (as defined), assigns all right title and interest to in and under all present and future collateral agreements to real property, licences granted to the company in respect of the real property, insurance policies and all proceeds paid or payable thereunder, second fixed charge all present and future assets, second floating charge all that heritable property of the company physically situated on the real property in scotland. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 mar 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 gen 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 10 nov 1999
    Consegnato il 25 nov 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a the farfield road unit factory development 2/18 hillfort road , 92/98 hoyland road sheffield t/no;-SYK385540.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 nov 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 10 nov 1999
    Consegnato il 25 nov 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a wilsons park manchester t/no;-GM46446.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 nov 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 10 nov 1999
    Consegnato il 25 nov 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a the cricket inn cricket inn road maltravers road derwent street sheffield t/no;-SYK394754.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 nov 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 10 nov 1999
    Consegnato il 25 nov 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H propertry k/a royd mill business park brighouse t/no;-WYK505418.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 nov 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 10 nov 1999
    Consegnato il 25 nov 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a the hoyland road factory development 30/80 hoyland road sheffield SYK88618.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 nov 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 10 nov 1999
    Consegnato il 25 nov 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a the hillford unit factory development hoyland road sheffield t/no;-SYK394671.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 nov 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 10 nov 1999
    Consegnato il 25 nov 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a londesborough street hull t/no;-HS186745.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 nov 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 10 nov 1999
    Consegnato il 25 nov 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a atlas business centre oxgate lane staples corner london t/no;-NGL498102.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 nov 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 10 nov 1999
    Consegnato il 25 nov 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a marsh mill luck lane marsh huddersfield t/no;-WYK377723.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 nov 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 10 nov 1999
    Consegnato il 25 nov 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a black rock mills linthwaite huddersfield t/no's;-WYK591854, WYK525399, WYK187697 and WYK561310.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 nov 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    IMEX SPACES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    05 nov 2011Data di scioglimento
    28 set 2010Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Stephen Gordon Franklin
    Panos Eliades Franklin & Co Olympia House
    Armitage Road
    NW11 8RQ London
    Praticante
    Panos Eliades Franklin & Co Olympia House
    Armitage Road
    NW11 8RQ London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0