SOLUTIONS (ROSS) LTD.

SOLUTIONS (ROSS) LTD.

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSOLUTIONS (ROSS) LTD.
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01935313
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SOLUTIONS (ROSS) LTD.?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova SOLUTIONS (ROSS) LTD.?

    Indirizzo della sede legale
    Fifth Floor
    80 Hammersmith Road
    W14 8UD London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SOLUTIONS (ROSS) LTD.?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SNOWMAN HOLIDAYS LIMITED18 set 198618 set 1986
    CHILSTONES LIMITED01 ago 198501 ago 1985

    Quali sono gli ultimi bilanci di SOLUTIONS (ROSS) LTD.?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per SOLUTIONS (ROSS) LTD.?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01
    A6FKZJEZ

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    8 pagineAA
    A6D0OECY

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 lug 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01
    X6AYTDWP

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    8 pagineAA
    A5F4GU0B

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 lug 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01
    X5BAU9C9

    Cessazione della carica di Mark Moran come amministratore in data 01 mar 2016

    1 pagineTM01
    X51ZFCBV

    Bilancio annuale redatto al 09 lug 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital29 lug 2015

    Stato del capitale al 29 lug 2015

    • Capitale: GBP 2
    SH01
    X4COVQLV

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    7 pagineAA
    A4B3653S

    Nomina di Mr Mark Moran come amministratore in data 01 apr 2015

    2 pagineAP01
    X450T4AQ

    Cessazione della carica di Jason David Lock come amministratore in data 01 apr 2015

    1 pagineTM01
    X450T3YO

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    5 pagineAA
    A3HHXM8Z

    Bilancio annuale redatto al 09 lug 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    X3D41NH7

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    7 pagineAA
    A2GCXLGA

    Indirizzo della sede legale modificato da * 21 Exhibition Place Addison Bridge Place Kensington London W14 8XP United Kingdom* in data 25 lug 2013

    1 pagineAD01
    X2DCGYE0

    Bilancio annuale redatto al 09 lug 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital24 lug 2013

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 24 lug 2013

    SH01
    X2D79OA2

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    8 pagineAA
    A1HZ2WVS

    Bilancio annuale redatto al 09 lug 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    X1CVXEWH

    Bilancio annuale redatto al 09 lug 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    X7YDHVXO

    Indirizzo della sede legale modificato da * Priory House, Randalls Way Leatherhead Surrey KT22 7TP* in data 18 lug 2011

    1 pagineAD01
    X7YDGVXN

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    12 pagineAA
    AZC2UVEQ

    Bilancio annuale redatto al 10 lug 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    XPCR4UE1

    legacy

    3 pagineMG02
    A2EGES3F

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    2 pagineCC04
    AWX0OQ6N

    Chi sono gli amministratori di SOLUTIONS (ROSS) LTD.?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HALL, David James
    80 Hammersmith Road
    W14 8UD London
    Fifth Floor
    England
    Segretario
    80 Hammersmith Road
    W14 8UD London
    Fifth Floor
    England
    BritishCompany Lawyer132246660001
    HALL, David James
    80 Hammersmith Road
    W14 8UD London
    Fifth Floor
    England
    Amministratore
    80 Hammersmith Road
    W14 8UD London
    Fifth Floor
    England
    EnglandBritishCompany Lawyer132246660001
    CRAIG, Peter Stuart
    Kempley Green House
    Kempley Green
    GL18 2BN Dymock
    Gloucestershire
    Segretario
    Kempley Green House
    Kempley Green
    GL18 2BN Dymock
    Gloucestershire
    British2482140001
    GREENSMITH, Paul John
    8 Ennerdale Road
    Kew
    TW9 3PG Richmond Upon Thames
    Surrey
    Segretario
    8 Ennerdale Road
    Kew
    TW9 3PG Richmond Upon Thames
    Surrey
    BritishDirector150227000001
    MACK, Torsten
    D8710 The Bridge
    334 Queenstown Road
    SW8 4NP London
    Segretario
    D8710 The Bridge
    334 Queenstown Road
    SW8 4NP London
    BritishDirector93474760001
    MUKERJI, Swagatam
    The Peacocks
    Drews Park, Knotty Green
    HP9 2TT Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Segretario
    The Peacocks
    Drews Park, Knotty Green
    HP9 2TT Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishFinance Director121222440001
    SPRUZEN, David Andrew
    Homewood
    The Avenue, Farnham Common
    SL2 3JY Slough
    Bucks
    Segretario
    Homewood
    The Avenue, Farnham Common
    SL2 3JY Slough
    Bucks
    BritishDirector110080200001
    THORPE, James Michael
    Tredunnock Farm
    Llangarron
    HR9 6PG Ross On Wye
    Herefordshire
    Segretario
    Tredunnock Farm
    Llangarron
    HR9 6PG Ross On Wye
    Herefordshire
    British13498640001
    BRADSHAW, Stephen Wallace
    Great Elm
    BA11 3NY Nr Frome
    Glenthorpe
    Somerset
    Amministratore
    Great Elm
    BA11 3NY Nr Frome
    Glenthorpe
    Somerset
    EnglandBritishDirector132026810001
    CRAIG, Peter Stuart
    Kempley Green House
    Kempley Green
    GL18 2BN Dymock
    Gloucestershire
    Amministratore
    Kempley Green House
    Kempley Green
    GL18 2BN Dymock
    Gloucestershire
    EnglandBritishCompany Director2482140001
    GREENSMITH, Paul John
    8 Ennerdale Road
    Kew
    TW9 3PG Richmond Upon Thames
    Surrey
    Amministratore
    8 Ennerdale Road
    Kew
    TW9 3PG Richmond Upon Thames
    Surrey
    EnglandBritishDirector150227000001
    LOCK, Jason David
    80 Hammersmith Road
    W14 8UD London
    Fifth Floor
    England
    Amministratore
    80 Hammersmith Road
    W14 8UD London
    Fifth Floor
    England
    EnglandBritishFinance Director144822040001
    MACK, Torsten
    D8710 The Bridge
    334 Queenstown Road
    SW8 4NP London
    Amministratore
    D8710 The Bridge
    334 Queenstown Road
    SW8 4NP London
    BritishDirector93474760001
    MASSEY, Anthony David
    The Granary
    Tredunnock Farm, Llangarron
    HR9 6PG Ross On Wye
    Herefordshire
    Amministratore
    The Granary
    Tredunnock Farm, Llangarron
    HR9 6PG Ross On Wye
    Herefordshire
    BritishCompany Director85961770001
    MORAN, Mark
    80 Hammersmith Road
    W14 8UD London
    Fifth Floor
    Amministratore
    80 Hammersmith Road
    W14 8UD London
    Fifth Floor
    United KingdomBritishDirector60066000008
    MUKERJI, Swagatam
    The Peacocks
    Drews Park, Knotty Green
    HP9 2TT Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    The Peacocks
    Drews Park, Knotty Green
    HP9 2TT Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritishFinance Director121222440001
    PATEL, Chaitanya Bhupendra
    Robin Hill
    Warren Lane
    KT22 0ST Oxshott
    Surrey
    Amministratore
    Robin Hill
    Warren Lane
    KT22 0ST Oxshott
    Surrey
    United KingdomBritishDirector63915280004
    SMITH, Julie
    Bron Y Gan Station Street
    HR9 7AG Ross On Wye
    Herefordshire
    Amministratore
    Bron Y Gan Station Street
    HR9 7AG Ross On Wye
    Herefordshire
    BritishPersonnel Manger18574010003
    SPRUZEN, David Andrew
    Homewood
    The Avenue, Farnham Common
    SL2 3JY Slough
    Bucks
    Amministratore
    Homewood
    The Avenue, Farnham Common
    SL2 3JY Slough
    Bucks
    EnglandBritishDirector110080200001
    THOMPSON, Christopher, Professor
    3 Preshaw House
    Preshaw
    SO32 1HP Upham
    Hampshire
    Amministratore
    3 Preshaw House
    Preshaw
    SO32 1HP Upham
    Hampshire
    United KingdomBritishDoctor162000490001
    THORPE, James Michael
    Tredunnock Farm
    Llangarron
    HR9 6PG Ross On Wye
    Herefordshire
    Amministratore
    Tredunnock Farm
    Llangarron
    HR9 6PG Ross On Wye
    Herefordshire
    United KingdomBritishCompany Director13498640001

    Chi sono le persone con controllo significativo di SOLUTIONS (ROSS) LTD.?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Priory Old Schools Services Ltd
    80 Hammersmith Road
    W14 8UD London
    5th Floor
    England
    06 apr 2016
    80 Hammersmith Road
    W14 8UD London
    5th Floor
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland And Wales
    Numero di registrazione2838284
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    SOLUTIONS (ROSS) LTD. ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security agreement
    Creato il 05 giu 2009
    Consegnato il 12 giu 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of its rights in respect of any relevant contract - blenheim healthcare limited, loan agreement dated 15 june 2009. priory healthcare investments limited loan agreement dated 15 june 2009. priory group limited loan agreement dated 15 june 2009. for details of further relevant contracts charged please refer to form 395, see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Security Agent)
    Transazioni
    • 12 giu 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Security agreement
    Creato il 09 nov 2005
    Consegnato il 22 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over all property and assets including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Abn Amro Bank N.V. London Branch (Facility Agent)
    Transazioni
    • 22 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement
    Creato il 15 set 2005
    Consegnato il 26 set 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H property k/a kilworthy house tavistock west devon t/nos DN369633 and DN371089, f/h property k/a ward house bere alston yelverton west devon t/no DN346394, f/h property k/a eastwood grange school milken lane ashover derbyshire t/no DY212755. For details of further properties charged please refer to form 395. all buildings fixtures fittings and fixed plant and machinery and floating charge all assets no effectively mortgaged charged or assigned. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Abn Amro Bank N.V., London Branch (The Facility Agent)
    Transazioni
    • 26 set 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    The obligor security accession deed
    Creato il 23 dic 2004
    Consegnato il 05 gen 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the borrower security trustee or any of the other borrower secured creditors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first legal mortgage the accession deed property. The f/h land and buildings k/a part of the property at talocher farm wanastow road monmouth monmouthshire NP25 4DN title absolute t/n CYM160932 (for details of further properties charged please refer to form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Citicorp Trustee Company Limited as Security Trustee for the Borrower Secured Creditors and the Capex Facility Secured Creditors
    Transazioni
    • 05 gen 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 26 gen 2004
    Consegnato il 10 feb 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 10 feb 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 28 ott 2002
    Consegnato il 30 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fairview foy ross-on-wye herefordshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 30 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 15 giu 2001
    Consegnato il 26 giu 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Talocher farm and associated buildings wonastow road, monmouth monmouthshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 giu 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 giu 1999
    Consegnato il 08 lug 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a grosvenor house gloucester road ross-on-wye herefordshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 lug 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 nov 1997
    Consegnato il 17 nov 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Callow hills farm munstone nr ledbury hereford & worcester.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 nov 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 27 nov 1996
    Consegnato il 03 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The old rectory hope-under-dinmore hereford and worcester.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 03 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0