LYNCH-STAUNTON COSMETICS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | LYNCH-STAUNTON COSMETICS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01936379 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di LYNCH-STAUNTON COSMETICS LIMITED?
- Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici (46450) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
Dove si trova LYNCH-STAUNTON COSMETICS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Newbury House Aintree Avenue White Horse Business Park BA14 0XB Trowbridge Wiltshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di LYNCH-STAUNTON COSMETICS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| CONSTANCE CARROLL LIMITED | 20 ott 2011 | 20 ott 2011 |
| CONSTANCE CARROLL OVERSEAS LIMITED | 07 mag 2004 | 07 mag 2004 |
| CONSTANCE CARROLL OVERSEAS PUBLIC LIMITED COMPANY | 25 nov 1985 | 25 nov 1985 |
| CONSTANCE CARROLL (EXPORTS) LIMITED | 06 ago 1985 | 06 ago 1985 |
Quali sono gli ultimi bilanci di LYNCH-STAUNTON COSMETICS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per LYNCH-STAUNTON COSMETICS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2019 | 6 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 30 lug 2019
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Graham Murray Lynch Staunton il 22 ott 2018 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2018 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 ago 2018 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Lynne Margaret Lovell come amministratore in data 16 feb 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2017 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 ago 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Susan Angela Lynch-Staunton il 20 set 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Susan Angela Clayton-Smith il 27 lug 2017 | 3 pagine | CH01 | ||||||||||
Nomina di Lynne Margaret Lovell come amministratore in data 27 gen 2017 | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2016 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 ago 2016 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2015 | 7 pagine | AA | ||||||||||
La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta | 1 pagine | DISS40 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 ago 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||||||||||
Cessazione della carica di John Alan Thompson come amministratore in data 01 set 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed constance carroll LIMITED\certificate issued on 26/11/14 | 3 pagine | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Chi sono gli amministratori di LYNCH-STAUNTON COSMETICS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LYNCH STAUNTON, Graham Murray | Amministratore | Aintree Avenue White Horse Business Park BA14 0XB Trowbridge Newbury House Wiltshire United Kingdom | United Kingdom | British | 77490420006 | |||||
| LYNCH-STAUNTON, Susan Angela | Amministratore | Aintree Avenue White Horse Business Park BA14 0XB Trowbridge Newbury House Wiltshire United Kingdom | England | British | 165079930008 | |||||
| MUSHET, Norman Buchanan | Segretario | 5 Howgill Close Ledsham Park CH66 4JH Little Sutton Cheshire | British | 105077220001 | ||||||
| RING, Leo Joseph | Segretario | 3 Fairways IRISH Rathfarnham Dublin 14 Ireland | Irish | 97021090001 | ||||||
| RING, Leo Joseph | Segretario | 3 Fairways IRISH Rathfarnham Dublin 14 Ireland | Irish | 97021090001 | ||||||
| ROBERTS, Timothy Edward | Segretario | 19 Grammar School Road WA13 0BQ Lymm Cheshire | British | 14876480002 | ||||||
| CARPENTER, Brian William | Amministratore | Willan House Highland Road, Badgers Mount TN14 7BA Sevenoaks Kent | England | British | 14876490002 | |||||
| HICKIE, Gerard | Amministratore | Higher House Farm Castle Mill Lane WA15 0RA Ashley Cheshire | Irish | 85735370004 | ||||||
| HUGHES, Loraine | Amministratore | Walsham Gardens WA9 5UT St. Helens 38 Merseyside | England | British | 138239430001 | |||||
| LOVELL, Lynne Margaret | Amministratore | Aintree Avenue White Horse Business Park BA14 0XB Trowbridge Newbury House Wiltshire Uk | England | British | 251923560001 | |||||
| MARSH, Stephen Beverley | Amministratore | Home Farm Liverpool Road Ashton In Makerfield WN4 9LX Wigan Lancashire | British | 36100180002 | ||||||
| MURPHY, James Michael | Amministratore | 36 Ulverton Road IRISH Dalkey Co Dublin Ireland | Ireland | Irish | 51806010005 | |||||
| MUSHET, Norman Buchanan | Amministratore | 5 Howgill Close Ledsham Park CH66 4JH Little Sutton Cheshire | British | 105077220001 | ||||||
| O'BRIEN, Paul | Amministratore | 3 Fox Lodge Road Fox Lodge Woods IRISH Ratoath Ireland | Ireland | Irish | 96999430001 | |||||
| OTLEY, Richard Reverdy | Amministratore | 4 Osborne Way HP23 6EN Wiggington Hertfordshire | United Kingdom | British | 127085630001 | |||||
| ROBERTS, Timothy Edward | Amministratore | 19 Grammar School Road WA13 0BQ Lymm Cheshire | British | 14876480002 | ||||||
| SOROKIN, Alexander | Amministratore | 10 Sterling Street SW7 1HN London | American | 111747170001 | ||||||
| THOMPSON, John Alan | Amministratore | Grimrod Place East Gillibrands WN8 9UU Skelmersdale 22 Lancashire United Kingdom | England | British | 60966890001 | |||||
| WILKINSON, Alan Geoffrey | Amministratore | 1 Sunningdale Gardens Freshfield Road L37 3RL Formby Liverpool Merseyside | British | 14876510002 | ||||||
| WILKINSON, Geoffrey Harold | Amministratore | Dalton House Higher Lane Dalton WN8 7RP Wigan Lancashire | British | 14876520001 | ||||||
| WILKINSON, Peter Alan | Amministratore | Uplands Higher Lane, Dalton WN8 7TW Wigan Lancashire | United Kingdom | British | 87473650001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di LYNCH-STAUNTON COSMETICS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lynch-Staunton Cosmetics Holdings Limited | 06 apr 2016 | Aintree Avenue White Horse Business Park BA14 0XB Trowbridge Newbury House Wiltshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
LYNCH-STAUNTON COSMETICS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 19 lug 2012 Consegnato il 24 lug 2012 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security agreement | Creato il 28 mar 2006 Consegnato il 11 apr 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each chargor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over property and assets including goodwill bookdebts uncalled plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security agreement | Creato il 09 giu 2004 Consegnato il 28 giu 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each chargor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 27 mag 1988 Consegnato il 06 giu 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures fixed and machinery all stocks, shares & other securities. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0