FOUR SEASONS (DFK) LIMITED

FOUR SEASONS (DFK) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàFOUR SEASONS (DFK) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01938282
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di FOUR SEASONS (DFK) LIMITED?

    • Altre attività di assistenza sanitaria (86900) / Attività sanitarie e di assistenza sociale

    Dove si trova FOUR SEASONS (DFK) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O TENEO RESTRUCTURING LIMITED
    156 Great Charles Street Quuensway
    B3 3HN Birmingham
    West Midlands
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di FOUR SEASONS (DFK) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BETTERCARE U.K. LIMITED13 mar 200013 mar 2000
    EXTENDICARE (UK) LIMITED16 nov 199416 nov 1994
    INTERNATIONAL CARE SERVICES LIMITED22 nov 198522 nov 1985
    SWIFT 349 LIMITED13 ago 198513 ago 1985

    Quali sono gli ultimi bilanci di FOUR SEASONS (DFK) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per FOUR SEASONS (DFK) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione

    26 pagineAM23

    Indirizzo della sede legale modificato da 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN a 156 Great Charles Street Quuensway Birmingham West Midlands B3 3HN in data 07 set 2021

    2 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da Four Brindleyplace Birmingham B1 2HZ a 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN in data 28 giu 2021

    2 pagineAD01

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    23 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    3 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    22 pagineAM10

    Cessazione della carica di Benjamin Robert Taberner come amministratore in data 30 giu 2020

    1 pagineTM01

    Dichiarazione delle attività con il modulo AM02SOA

    17 pagineAM02

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    41 pagineAM06

    Cessazione della carica di Maureen Claire Royston come amministratore in data 30 apr 2020

    1 pagineTM01

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    40 pagineAM03

    Indirizzo della sede legale modificato da Norcliffe House Station Road Wilmslow SK9 1BU a Four Brindleyplace Birmingham B1 2HZ in data 16 apr 2020

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    3 pagineAM01

    Cessazione della carica di Martin William Oliver Healy come amministratore in data 30 gen 2020

    1 pagineTM01

    Notifica di Mericourt Limited come persona con controllo significativo il 16 lug 2019

    2 paginePSC02

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 dic 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Martin William Oliver Healy come amministratore in data 18 nov 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Timothy Richard William Hammond come amministratore in data 18 nov 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione di Elli Finance (Uk) Plc come persona con controllo significativo il 30 apr 2019

    1 paginePSC07

    Modifica dei dettagli di Elli Finance (Uk) Plc come persona con controllo significativo il 17 mag 2019

    2 paginePSC05

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 dic 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    28 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 dic 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    24 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di FOUR SEASONS (DFK) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MATTISON, Abigail
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United Kingdom
    Segretario
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United Kingdom
    188568040001
    CROWE, Geoffrey Michael
    51 Oakwood Lane
    Bowdon
    WA14 3DL Altrincham
    Cheshire
    Segretario
    51 Oakwood Lane
    Bowdon
    WA14 3DL Altrincham
    Cheshire
    British38256680007
    KAY, Dominic Jude
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    Segretario
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    British145920530001
    MURPHY, Marc
    39 Cranmore Park
    BT9 6JF Belfast
    Segretario
    39 Cranmore Park
    BT9 6JF Belfast
    Irish88620540001
    PALMER, Martin Trevor Digby
    Hill House
    Crook Road Brenchley
    TN12 7BS Tonbridge
    Kent
    Segretario
    Hill House
    Crook Road Brenchley
    TN12 7BS Tonbridge
    Kent
    British79436600001
    PATTERSON, James
    19 Knockmore Park
    BT20 3SL Bangor
    County Down
    Northern Ireland
    Segretario
    19 Knockmore Park
    BT20 3SL Bangor
    County Down
    Northern Ireland
    British65359270002
    RIDGWELL, David William
    4 Browns Lane
    Hastoe
    HP23 6LX Tring
    Hertfordshire
    Segretario
    4 Browns Lane
    Hastoe
    HP23 6LX Tring
    Hertfordshire
    British1691410001
    BARLOW, George Edward
    41 Nidd Approach
    LS22 7UJ Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    41 Nidd Approach
    LS22 7UJ Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritish66559170001
    CALDWELL, Charles Anthony
    26 Hampton Manor
    BT7 3EL Belfast
    County Antrim
    Amministratore
    26 Hampton Manor
    BT7 3EL Belfast
    County Antrim
    Northern IrelandBritish65779460001
    CALKIN, Joy Durfee, Dr
    Suite 915,
    610 Bullock Drive
    L3R 0G1 Unionville
    Ontario
    Canada
    Amministratore
    Suite 915,
    610 Bullock Drive
    L3R 0G1 Unionville
    Ontario
    Canada
    Canadian55624300001
    CALVELEY, Peter, Dr
    Canwick Hill
    Canwick
    LN4 2RF Lincoln
    The Old Vicarage
    Lincolnshire
    Amministratore
    Canwick Hill
    Canwick
    LN4 2RF Lincoln
    The Old Vicarage
    Lincolnshire
    United KingdomBritish131468590001
    CARTER, James Wesley
    28 Teddington Park Avenue
    Toronto
    M4N 2C3 Ontario
    Canada
    Amministratore
    28 Teddington Park Avenue
    Toronto
    M4N 2C3 Ontario
    Canada
    Canadian48953740001
    GEARY, Michael
    20 Castlehill Road
    BT4 3GL Belfast
    Amministratore
    20 Castlehill Road
    BT4 3GL Belfast
    British143518040001
    HAMMOND, Timothy Richard William
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    Amministratore
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    EnglandBritish205777760001
    HARRIS, Douglas James
    14 The Laurels
    Potten End
    HP4 2SP Berkhamsted
    Hertfordshire
    Amministratore
    14 The Laurels
    Potten End
    HP4 2SP Berkhamsted
    Hertfordshire
    Canadian39267910003
    HEALY, Martin William Oliver
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    Amministratore
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United KingdomIrish134003120002
    HEHIR, Anthony Patrick
    Scolty Lodge 12 Oldfield Road
    Heswall
    CH60 6SE Wirral
    Merseyside
    Amministratore
    Scolty Lodge 12 Oldfield Road
    Heswall
    CH60 6SE Wirral
    Merseyside
    EnglandBritish111038070001
    HEYWOOD, Anthony George
    Harborough Hall Lane
    CO5 9UA Messing
    Harborough Hall
    Essex
    Amministratore
    Harborough Hall Lane
    CO5 9UA Messing
    Harborough Hall
    Essex
    EnglandBritish131288260001
    HOW, Alistair Maxwell
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    Amministratore
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United KingdomBritish169139000001
    KAY, Dominic Jude
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    Amministratore
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    United KingdomBritish145920530001
    LADLY, Frederick Bernard
    11 Friars Lane
    Islington
    Ontario
    Canada
    Amministratore
    11 Friars Lane
    Islington
    Ontario
    Canada
    Canadian33893980002
    LAMBERT, Richard Edwards
    31 Hogback Wood Road
    HP9 1JT Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    31 Hogback Wood Road
    HP9 1JT Beaconsfield
    Buckinghamshire
    UkBritish149807760001
    MCDONALD, Peter Stuart
    4 St Stephens Terrace
    SW8 1DH London
    Amministratore
    4 St Stephens Terrace
    SW8 1DH London
    British77781180001
    MCLAUGHLIN, John Gordon
    38 Linden Crescent
    FOREIGN Brampton Ontario L6s 3az Canada
    Amministratore
    38 Linden Crescent
    FOREIGN Brampton Ontario L6s 3az Canada
    Canadian44356870001
    MITCHELL, Nicholas John
    Lymbrook
    53 Dore Road Dore
    S17 3NA Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    Lymbrook
    53 Dore Road Dore
    S17 3NA Sheffield
    South Yorkshire
    Great BritainBritish145102120001
    NEALE, Charles Christopher Anthony
    62 Scarsdale Villas
    W8 6PP London
    Amministratore
    62 Scarsdale Villas
    W8 6PP London
    British24748590001
    O'REILLY, Michael Patrick
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    Amministratore
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United KingdomBritish40241900001
    ORESCHNICK, Robert
    Bankfield Cold Hill Lane
    New Mill
    HD9 7JX Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    Bankfield Cold Hill Lane
    New Mill
    HD9 7JX Huddersfield
    West Yorkshire
    American82179080001
    PATTERSON, Gordon
    6 Cultra Park
    BT18 0QE Holywood
    County Down
    Amministratore
    6 Cultra Park
    BT18 0QE Holywood
    County Down
    Northern IrelandBritish65359330001
    PATTERSON, Gordon
    No 5 Cultra Park
    BT18 0QE Holywood
    County Down
    Northern Ireland
    Amministratore
    No 5 Cultra Park
    BT18 0QE Holywood
    County Down
    Northern Ireland
    British66574310004
    PATTERSON, James
    19 Knockmore Park
    BT20 3SL Bangor
    County Down
    Northern Ireland
    Amministratore
    19 Knockmore Park
    BT20 3SL Bangor
    County Down
    Northern Ireland
    Northern IrelandBritish65359270002
    RHINELANDER, Melvin Gilbert
    19 Aylesbury Road
    Toronto
    Ontario
    Canada
    Amministratore
    19 Aylesbury Road
    Toronto
    Ontario
    Canada
    Canadian66168700001
    ROYSTON, Maureen Claire, Dr
    B1 2HZ Birmingham
    Four Brindleyplace
    Amministratore
    B1 2HZ Birmingham
    Four Brindleyplace
    United KingdomBritish184190020002
    SMITH, Ian Richard
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    Amministratore
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United KingdomBritish181082310001
    SMITH, Michael John
    11 Lower Park Road
    IG10 4NB Loughton
    Essex
    Amministratore
    11 Lower Park Road
    IG10 4NB Loughton
    Essex
    EnglandBritish641150001

    Chi sono le persone con controllo significativo di FOUR SEASONS (DFK) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United Kingdom
    16 lug 2019
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione03633551
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Suite 3 Regency House
    91 Western Road
    BN1 2NW Brighton
    C/O Alvarez & Marsal Europe Llp
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Suite 3 Regency House
    91 Western Road
    BN1 2NW Brighton
    C/O Alvarez & Marsal Europe Llp
    United Kingdom
    Forma giuridicaPublic Limited Company
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione08094161
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione03863850
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    FOUR SEASONS (DFK) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A security deed
    Creato il 30 ott 2006
    Consegnato il 17 nov 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Credit Suisse London Branch
    Transazioni
    • 17 nov 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 giu 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 23 lug 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed and floating charge
    Creato il 06 dic 1999
    Consegnato il 16 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies, liabilities and obligations due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease dated 6TH december 1999
    Brevi particolari
    By way of first legal mortgage the premises together with all buildings and other fixtures fixed plant machinery and all tangible moveable property and tenant's or trade fixtures from time to time thereon; by way of first fixed charge all plant and machinery, book debts and other debts, goodwill and uncalled capital; by way of first floating charge the undertaking and all its property and assets whatsoever and wheresoever present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Quercus (Nursing Homes) Limited
    Transazioni
    • 16 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 lug 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 08 set 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed and floating charge
    Creato il 06 dic 1999
    Consegnato il 16 dic 1999
    In corso
    Importo garantito
    All monies, liabilities and obligations due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease dated 6TH december 1999
    Brevi particolari
    By way of first legal mortgage the premises together with all buildings and other fixtures fixed plant machinery and all tangible moveable property and tenant's or trade fixtures from time to time thereon; by way of first fixed charge all plant and machinery, book debts and other debts, goodwill and uncalled capital; by way of first floating charge the undertaking and all its property and assets whatsoever and wheresoever present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Quercus (Nursing Homes) Limited
    Transazioni
    • 16 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 lug 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Fixed and floating charge
    Creato il 06 dic 1999
    Consegnato il 16 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies, liabilities and obligations due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease dated 6TH december 1999
    Brevi particolari
    By way of first legal mortgage the premises together with all buildings and other fixtures fixed plant machinery and all tangible moveable property and tenant's or trade fixtures from time to time thereon; by way of first fixed charge all plant and machinery, book debts and other debts, goodwill and uncalled capital; by way of first floating charge the undertaking and all its property and assets whatsoever and wheresoever present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Quercus (Nursing Homes) Limited
    Transazioni
    • 16 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 lug 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 07 lug 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed and floating charge
    Creato il 06 dic 1999
    Consegnato il 16 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies, liabilities and obligations due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease dated 6TH december 1999
    Brevi particolari
    By way of first legal mortgage the premises together with all buildings and other fixtures fixed plant machinery and all tangible moveable property and tenant's or trade fixtures from time to time thereon; by way of first fixed charge all plant and machinery, book debts and other debts, goodwill and uncalled capital; by way of first floating charge the undertaking and all its property and assets whatsoever and wheresoever present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Quercus (Nursing Homes) Limited
    Transazioni
    • 16 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 lug 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 07 lug 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed and floating charge
    Creato il 06 dic 1999
    Consegnato il 16 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies, liabilities and obligations due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease dated 6TH december 1999
    Brevi particolari
    By way of first legal mortgage the premises together with all buildings and other fixtures fixed plant machinery and all tangible moveable property and tenant's or trade fixtures from time to time thereon; by way of first fixed charge all plant and machinery, book debts and other debts, goodwill and uncalled capital; by way of first floating charge the undertaking and all its property and assets whatsoever and wheresoever present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Quercus (Nursing Homes) Limited
    Transazioni
    • 16 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 lug 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 25 nov 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed and floating charge
    Creato il 06 dic 1999
    Consegnato il 16 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies, liabilities and obligations due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease dated 6TH december 1999
    Brevi particolari
    By way of first legal mortgage the premises together with all buildings and other fixtures fixed plant machinery and all tangible moveable property and tenant's or trade fixtures from time to time thereon; by way of first fixed charge all plant and machinery, book debts and other debts, goodwill and uncalled capital; by way of first floating charge the undertaking and all its property and assets whatsoever and wheresoever present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Quercus (Nursing Homes) Limited
    Transazioni
    • 16 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 lug 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 08 set 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed and floating charge
    Creato il 06 dic 1999
    Consegnato il 16 dic 1999
    In corso
    Importo garantito
    All monies, liabilities and obligations due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease dated 6TH december 1999
    Brevi particolari
    By way of first legal mortgage the premises together with all buildings and other fixtures fixed plant machinery and all tangible moveable property and tenant's or trade fixtures from time to time thereon; by way of first fixed charge all plant and machinery, book debts and other debts, goodwill and uncalled capital; by way of first floating charge the undertaking and all its property and assets whatsoever and wheresoever present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Quercus (Nursing Homes) Limited
    Transazioni
    • 16 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 lug 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Fixed and floating charge
    Creato il 06 dic 1999
    Consegnato il 16 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies, liabilities and obligations due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease dated 6TH december 1999
    Brevi particolari
    By way of first legal mortgage the premises together with all buildings and other fixtures fixed plant machinery and all tangible moveable property and tenant's or trade fixtures from time to time thereon; by way of first fixed charge all plant and machinery, book debts and other debts, goodwill and uncalled capital; by way of first floating charge the undertaking and all its property and assets whatsoever and wheresoever present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Quercus (Nursing Homes) Limited
    Transazioni
    • 16 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 lug 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 07 lug 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed and floating charge
    Creato il 06 dic 1999
    Consegnato il 16 dic 1999
    In corso
    Importo garantito
    All monies, liabilities and obligations due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease dated 6TH december 1999
    Brevi particolari
    By way of first legal mortgage the premises together with all buildings and other fixtures fixed plant machinery and all tangible moveable property and tenant's or trade fixtures from time to time thereon; by way of first fixed charge all plant and machinery, book debts and other debts, goodwill and uncalled capital; by way of first floating charge the undertaking and all its property and assets whatsoever and wheresoever present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Quercus (Nursing Homes) Limited
    Transazioni
    • 16 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 lug 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Fixed and floating charge
    Creato il 06 dic 1999
    Consegnato il 16 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies, liabilities and obligations due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease dated 6TH december 1999
    Brevi particolari
    By way of first legal mortgage the premises together with all buildings and other fixtures fixed plant machinery and all tangible moveable property and tenant's or trade fixtures from time to time thereon; by way of first fixed charge all plant and machinery, book debts and other debts, goodwill and uncalled capital; by way of first floating charge the undertaking and all its property and assets whatsoever and wheresoever present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Quercus (Nursing Homes) Limited
    Transazioni
    • 16 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 lug 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 07 lug 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 11 ago 1998
    Consegnato il 14 ago 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land on the south side of springfield road elburton t/no: DN56894. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 14 ago 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 05 giu 1998
    Consegnato il 09 giu 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land lying to the south west of cherrys road and to the south of rotherhsm rpad cundy cross barnsley t/n SK154952 SYK344991 SYK354662. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 09 giu 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 05 giu 1998
    Consegnato il 09 giu 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The elms nursing home and dwellinghouse known as le mar elm drive louth lincolnshire. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 09 giu 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 05 giu 1998
    Consegnato il 09 giu 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings on the east side of north road berwick upon tweed t/n ND60893. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 09 giu 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 05 giu 1998
    Consegnato il 09 giu 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land on the west side of fordcombe road fordcombe kent t/n K610202. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 09 giu 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 11 set 1995
    Consegnato il 12 set 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a hilltop manor nursing home, high lane t/no. SF349920. Fixed charge over all buildings and other structures fixed to the property. Fixed charge over any goodwill relating to the property. Fixed charge over all plant machinery and other chattels attached to the property. Floating charge over all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property. Assignment of the rental sums. Fixed charge the proceeds of any claim made under any insurance policy relating to any of the property.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 12 set 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 11 lug 1995
    Consegnato il 14 lug 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the f/h property k/a bickleigh down care centre t/no dn 237139. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 14 lug 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 11 lug 1995
    Consegnato il 14 lug 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the f/h property k/a meadowbrook nursing home t/no SL83650. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 14 lug 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 dic 1993
    Consegnato il 11 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property cherry tree nursing home barnsley t/n syk 317417.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 set 1993
    Consegnato il 11 ott 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a berwick nursing home berwick-upon-thames.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 ott 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 24 mar 1993
    Consegnato il 26 mar 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or cherry tree homeslimited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Leasehold property k/a cherry tree nursing home cherrys road cundy cross barnsley.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 26 mar 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 24 mar 1993
    Consegnato il 26 mar 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or nursing home estates limited on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the freehold property k/a cherry tree nursing home cherry road cundy cross barnsley.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 26 mar 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 19 set 1991
    Consegnato il 26 set 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Maple lodge nursing home scotton, catterick garrison north yorkshire t/no:- nyk 67936.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 26 set 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 04 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 26 lug 1991
    Consegnato il 01 ago 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land to north east of perry road west scunthorpe t/n hs 174511.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 01 ago 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 04 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    FOUR SEASONS (DFK) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    24 mar 2020Inizio dell'amministrazione
    29 set 2021Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Adrian Peter Berry
    Deloitte Llp
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    Praticante
    Deloitte Llp
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    Clare Boardman
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0