CASTLE HOME VIDEO LIMITED
Panoramica
| Nome della società | CASTLE HOME VIDEO LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01938596 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CASTLE HOME VIDEO LIMITED?
- Creazione artistica (90030) / Attività artistiche, sportive e di divertimento
Dove si trova CASTLE HOME VIDEO LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 33 Wigmore Street W1U 1QX London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CASTLE HOME VIDEO LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| INDEPENDENT VIDEO SERVICES LIMITED | 28 nov 1985 | 28 nov 1985 |
| SHARPIRON LIMITED | 13 ago 1985 | 13 ago 1985 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CASTLE HOME VIDEO LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2013 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per CASTLE HOME VIDEO LIMITED?
| Bilancio annuale |
|
|---|
Quali sono le ultime deposizioni per CASTLE HOME VIDEO LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 18 dic 2014 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Maximilian Dressendoerfer il 17 ott 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Mark David Ranyard il 17 ott 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2013 | 8 pagine | AA | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 27 ago 2014
| 4 pagine | SH01 | ||||||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da C/O Davenport Lyons 6 Agar Street London WC2N 4HN England a Simons Muirhead & Burton 8-9 Frith Street London W1D 3JB | 1 pagine | AD02 | ||||||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato Simons Muirhead & Burton 8-9 Frith Street London W1D 3JB | 1 pagine | AD03 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 18 dic 2013 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Beaumont House Avonmore Road Kensington Village London W14 8TS United Kingdom | 1 pagine | AD02 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da C/O Davenport Lyons 30 Old Burlington Street London W1S 3NL England in data 10 set 2013 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Mark David Ranyard come amministratore in data 30 apr 2013 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Nomina di Maximilian Dressendoerfer come amministratore in data 30 apr 2013 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Nomina di John Leslie Dobinson come amministratore in data 30 apr 2013 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Timothy Spencer Smith come amministratore in data 30 apr 2013 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 364-366 Kensington High Street London W14 8NS England in data 06 giu 2013 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2012 | 6 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 18 dic 2012 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Nomina di Timothy Spencer Smith come amministratore in data 21 nov 2012 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Abolanle Abioye come segretario in data 21 nov 2012 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Adam Martin Barker come amministratore in data 21 nov 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di David Richard James Sharpe come amministratore in data 21 nov 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di CASTLE HOME VIDEO LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBINSON, John Leslie | Amministratore | Wigmore Street W1U 1QX London 33 England | United Kingdom | British | 34942720003 | |||||
| DRESSENDOERFER, Maximilian, Dr | Amministratore | Wigmore Street W1U 1QX London 33 England | Germany | German | 157717080010 | |||||
| RANYARD, Mark David | Amministratore | Wigmore Street W1U 1QX London 33 England | England | British | 154884950002 | |||||
| ABIOYE, Abolanle | Segretario | Kensington High Street W14 8NS London 364-366 United Kingdom | British | 88802330001 | ||||||
| COOK, Edward John Nicholas | Segretario | Flat 2 47 Crooked Billet SW19 4RQ London | British | 59798700002 | ||||||
| HOLDER, Ian Keith | Segretario | 39a Great Percy Street WC1X 9RD London | British | 60759970001 | ||||||
| JOY, Matthew Robert | Segretario | 2 Chestnut Place KT21 2DY Ashtead Surrey | British | 115905420001 | ||||||
| O'BRIEN, Judith Elizabeth | Segretario | Glinton Cottage Milton Avenue Chalfont St Peter SL9 8QW Gerrards Cross Buckinghamshire | British | 53890870001 | ||||||
| STANDING, Sarah Elizabeth Anne | Segretario | 1 Pilsdon Close Inner Park Road Wimbledon SW19 6DR London | British | 41378870002 | ||||||
| CITY GROUP PLC | Segretario | 25 City Road EC1Y 1BQ London | 35794270001 | |||||||
| BARKER, Adam Martin | Amministratore | Kensington High Street W14 8NS London 364-366 United Kingdom | England | British | 162279360001 | |||||
| BEECHER, Jonathan Roderick | Amministratore | Great Oaks 7 Woodway Merrow GU1 2TF Guildford Surrey | British | 4641390002 | ||||||
| BRYANT, David Thomas | Amministratore | Ramillies Road W4 1JW London 37 United Kingdom | England | British | 129141390001 | |||||
| COKELL, Joseph | Amministratore | Talltrees Orpington Road BR7 6RA Chislehurst Kent | Gb-Eng | British | 76396440001 | |||||
| CONSTANT, Richard Michael | Amministratore | 6 Balniel Gate SW1V 3SD London | United Kingdom | British | 43836310003 | |||||
| COOK, Edward John Nicholas | Amministratore | 25 Ernle Road Wimbledon SW20 0HH London | British | 59798700004 | ||||||
| FISHER, Thomas Clive | Amministratore | 1 Nevelle Close Binfield RG42 4AZ Bracknell Berkshire | England | British | 26978160002 | |||||
| MUIR, Boyd Johnston | Amministratore | The Street Albury GU5 9AX Guildford Old Rectory Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 129432950001 | |||||
| SEMON, Roger | Amministratore | Kingsfield Kings Lane Cobblers Hill HP16 9PN Great Missenden Buckinghamshire | United Kingdom | British | 59798610002 | |||||
| SHAND, Terence Richard | Amministratore | Winkins Wood Farm Shillinglee Road Plaistow RH14 0PQ Billingshurst West Sussex | British | 4641400002 | ||||||
| SHARPE, David Richard James | Amministratore | Kensington High Street W14 8NS London 364-366 United Kingdom | England | Irish | 166109150001 | |||||
| SMITH, Timothy Spencer | Amministratore | Avonmore Road Kensington Village W14 8TS London Beaumont House United Kingdom | England | British | 130003340001 | |||||
| WALLACE, Paul Frederick | Amministratore | Westfield House Nunnery Lane TN11 8HA Penshurst Kent | England | British | 76655520001 |
CASTLE HOME VIDEO LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage debenture | Creato il 07 mag 1991 Consegnato il 09 mag 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee & debenture | Creato il 22 dic 1988 Consegnato il 11 gen 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 19 ott 1987 Consegnato il 28 ott 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed and floating charge | Creato il 26 giu 1987 Consegnato il 03 lug 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed charge on all book & other debts owing to the company. Floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts (exceeding those mentioned above) uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 26 giu 1987 Consegnato il 03 lug 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/H property k/a flat 7 rippon house, hornchurch essex. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0