YWC GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàYWC GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01939258
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di YWC GROUP LIMITED?

    • fabbricazione di altri prodotti in plastica (22290) / Industrie manifatturiere
    • Altre installazioni in costruzioni (43290) / Costruzioni

    Dove si trova YWC GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    4th Floor Fountain Precinct
    Leopold Street
    S1 2JA Sheffield
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di YWC GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    YORKSHIRE WINDOW CO. LTD.21 mag 198621 mag 1986
    FINCHALTON LIMITED15 ago 198515 ago 1985

    Quali sono gli ultimi bilanci di YWC GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per YWC GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    24 pagineLIQ14

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 18 gen 2020

    24 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 18 gen 2019

    24 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 18 gen 2018

    26 pagineLIQ03

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    2 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    2 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    2 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    2 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    2 pagineF10.2

    Indirizzo della sede legale modificato da Hellaby Industrial Estate Hellaby Rotherham South Yorkshire S66 8HN a 4th Floor Fountain Precinct Leopold Street Sheffield S1 2JA in data 10 feb 2017

    2 pagineAD01

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    16 pagine4.20

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 19 gen 2017

    LRESEX

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 ago 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Cessazione della carica di Kevin Taylor come amministratore in data 10 giu 2016

    2 pagineTM01

    Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2015

    26 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 25 ago 2015 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital02 set 2015

    Stato del capitale al 02 set 2015

    • Capitale: GBP 60,800
    SH01

    Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2014

    27 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 25 ago 2014 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 ott 2014

    Stato del capitale al 07 ott 2014

    • Capitale: GBP 60,800
    SH01

    Cessazione della carica di Steven Roger Cousins come amministratore in data 30 giu 2014

    1 pagineTM01

    Nomina di Steven Roger Cousins come segretario

    1 pagineAP03

    Nomina di Steven Roger Cousins come amministratore in data 25 lug 2006

    1 pagineAP01

    Cessazione della carica di Jonathan Bailey come amministratore

    2 pagineTM01

    Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2013

    25 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di YWC GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    COUSINS, Steven Roger
    61 Lea Road
    S18 1SD Dronfield
    Derbyshire
    Segretario
    61 Lea Road
    S18 1SD Dronfield
    Derbyshire
    British114656960001
    CARTER, Rex Andrew
    Chaff Close
    Whiston
    S60 4JH Rotherham
    15
    South Yorkshire
    Amministratore
    Chaff Close
    Whiston
    S60 4JH Rotherham
    15
    South Yorkshire
    United KingdomBritish82322290002
    CHESTER, Ian Robert
    Hellaby Industrial Estate
    S66 8HN Rotherham
    Bramley Way
    South Yorkshire
    England
    Amministratore
    Hellaby Industrial Estate
    S66 8HN Rotherham
    Bramley Way
    South Yorkshire
    England
    EnglandBritish181466460001
    COUSINS, Steven Roger
    Lea Road
    S18 1SD Dronfield
    61
    Derbyshire
    Amministratore
    Lea Road
    S18 1SD Dronfield
    61
    Derbyshire
    United KingdomBritish181551540001
    YARLETT, Michael Stewart
    The Barn House Pleasley Road
    Guilthwaite Hill
    S60 4NE Rotherham
    Amministratore
    The Barn House Pleasley Road
    Guilthwaite Hill
    S60 4NE Rotherham
    EnglandBritish33028840004
    LEVINE, Peter Michael
    32 West Court
    West Avenue
    LS8 2JN Leeds
    West Yorkshire
    Segretario nominato
    32 West Court
    West Avenue
    LS8 2JN Leeds
    West Yorkshire
    British900006720001
    ADDY, Christopher
    1 Cliff Hill Close
    Maltby
    S66 8BF Rotherham
    South Yorkshire
    Amministratore
    1 Cliff Hill Close
    Maltby
    S66 8BF Rotherham
    South Yorkshire
    EnglandEnglish93315810001
    ALLSOPP, Richard Malcolm
    7 Queensway
    S60 3EE Rotherham
    South Yorkshire
    Amministratore
    7 Queensway
    S60 3EE Rotherham
    South Yorkshire
    British3241690001
    BAILEY, Jonathan Trevor
    Bramley Way
    Hellaby Industrial Estate
    S66 8HN Rotherham
    Yorkshire Windows
    South Yorkshire
    England
    Amministratore
    Bramley Way
    Hellaby Industrial Estate
    S66 8HN Rotherham
    Yorkshire Windows
    South Yorkshire
    England
    EnglandBritish169581220001
    BLAGDEN, John Charles
    6 Coral Place
    Aughton
    S26 3RT Sheffield
    Amministratore
    6 Coral Place
    Aughton
    S26 3RT Sheffield
    British19379850002
    COUSINS, Steven Roger
    61 Lea Road
    S18 1SD Dronfield
    Derbyshire
    Amministratore
    61 Lea Road
    S18 1SD Dronfield
    Derbyshire
    EnglandBritish114656960001
    KEENAN, Robert
    62 Leedham Road
    S65 3EB Rotherham
    South Yorkshire
    Amministratore
    62 Leedham Road
    S65 3EB Rotherham
    South Yorkshire
    United KingdomBritish70765950001
    LEVINE, Peter Michael
    32 West Court
    West Avenue
    LS8 2JN Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore delegato nominato
    32 West Court
    West Avenue
    LS8 2JN Leeds
    West Yorkshire
    British900006720001
    RIGBY, Edwin John
    25 Constance Avenue
    LN6 8SU North Hykeham
    Lincoln
    Amministratore
    25 Constance Avenue
    LN6 8SU North Hykeham
    Lincoln
    United KingdomBritish87672510001
    SCOTT, Paul Graham
    57 Morthen Road
    Wickersley
    S66 0ER Rotherham
    South Yorkshire
    Amministratore
    57 Morthen Road
    Wickersley
    S66 0ER Rotherham
    South Yorkshire
    British19379840001
    SHAW, Anthony
    14 Victoria Avenue
    S65 2PY Rotherham
    Amministratore
    14 Victoria Avenue
    S65 2PY Rotherham
    British19379820003
    TAYLOR, Kevin
    Hellaby Industrial Estate
    Hellaby
    S66 8HN Rotherham
    South Yorkshire
    Amministratore
    Hellaby Industrial Estate
    Hellaby
    S66 8HN Rotherham
    South Yorkshire
    EnglandBritish81151010003
    WILSON, Howard James
    64 King Edward Road
    Thorne
    DN8 4BS Doncaster
    South Yorkshire
    Amministratore
    64 King Edward Road
    Thorne
    DN8 4BS Doncaster
    South Yorkshire
    British46326000001

    Chi sono le persone con controllo significativo di YWC GROUP LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr Michael Stewart Yarlett
    Guilthwaite Hill
    Whiston
    S60 4NE Rotherham
    The Barn House
    England
    25 ago 2016
    Guilthwaite Hill
    Whiston
    S60 4NE Rotherham
    The Barn House
    England
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    YWC GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 01 mag 2013
    Consegnato il 07 mag 2013
    In corso
    Breve descrizione
    A. by way of first legal mortgage the specified real property namely;. 1. unit BT512/3 a-f hellaby lane industrial estate, hellaby, rotherham, south yorkshire as the same is contained in SYK253742. 2. land on the south west side of braithwell way, hellaby industrial estate yorkshire as the same is contained in SYK365435. 3. land on the south west side of bramley way, hellaby industrial estate, hellaby yorkshire as the same is contained in SYK365434. B. by way of first fixed charge:. (I) all real property and all interests in real property not charged by clause 4.1(a));. (Ii) all licences to enter upon or use land and the benefit of all other agreements relating to land; and. (Iii) the proceeds of sale of all real property other than specified real property;. C. by way of first fixed charge the intellectual property (if any) specified in part 3 of schedule 1;. D. by way of first fixed charge all intellectual property (if any) not charged by clause 4.1(n);. "Intellectual property rights" means:. (I) any patents, trade marks, service marks, designs, business names, copyrights, design rights, moral rights, inventions, confidential information, know-how and other intellectual property rights and interests whether registered or unregistered; and. (Ii) the benefit of all applications and rights to use such assets of the company.. Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Centric SPV1 Limited
    Transazioni
    • 07 mag 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Legal charge
    Creato il 20 apr 2012
    Consegnato il 27 apr 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and premises at bramley way hellaby rotherham t/no SYK253742 SYK365435 SYK365434.
    Persone aventi diritto
    • Michael Stewart Yarlett
    Transazioni
    • 27 apr 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Deposit agreement
    Creato il 24 apr 2006
    Consegnato il 27 apr 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    £3,231.25 and the monies held in the account.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Window Company Limited
    Transazioni
    • 27 apr 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 10 dic 2003
    Consegnato il 12 dic 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 12 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal mortgage
    Creato il 10 dic 2003
    Consegnato il 12 dic 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property unit BT512/3 a-f hellaby lane industrial estate hellaby t/n SYK253742. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 12 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 25 giu 1997
    Consegnato il 05 lug 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and buildings k/a unit bt 512/3 a-f hellaby industrial estate hellaby rotherham south yorkshire t/no;-SYK253742 together with goodwill of any business at the property and proceeds of any insurance. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 05 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 22 feb 1988
    Consegnato il 24 feb 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that f/h property situate and k/a factory unit no: bt 51213 on the hellaby industrial estate rotherham south yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • The English Industrial Estates Corporation
    Transazioni
    • 24 feb 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 01 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 30 apr 1986
    Consegnato il 08 mag 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures & fittings fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 08 mag 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 25 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    YWC GROUP LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    19 gen 2017Inizio della liquidazione
    24 giu 2021Data prevista di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Adrian Graham
    4th Floor Fountain Precinct
    Leopold Street
    S1 2JA Sheffield
    Praticante
    4th Floor Fountain Precinct
    Leopold Street
    S1 2JA Sheffield

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0