MISYS SERVICES LIMITED

MISYS SERVICES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMISYS SERVICES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01941076
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MISYS SERVICES LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova MISYS SERVICES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    One Kingdom Street
    Paddington
    W2 6BL London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MISYS SERVICES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CAMBRIDGE COMPUTER SERVICES LIMITED21 ago 198521 ago 1985

    Quali sono gli ultimi bilanci di MISYS SERVICES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mag 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per MISYS SERVICES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    13 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 24 ago 2016

    20 pagine4.68

    Dichiarazione di solvibilità

    4 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 25 ago 2015

    LRESSP

    Tutta la proprietà o attività è stata liberata dall'onere 6

    5 pagineMR05

    Nomina di Mr Johannes Jacobus Olivier come amministratore in data 20 lug 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Andrew Paul Woodward come amministratore in data 20 lug 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 29 mag 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 giu 2015

    Stato del capitale al 01 giu 2015

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Bilancio redatto al 31 mag 2014

    14 pagineAA

    Nomina di Mr Andrew Paul Woodward come amministratore in data 05 set 2014

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Sanjay Patel come amministratore in data 28 ago 2014

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr John Van Harken come amministratore in data 31 lug 2014

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Elizabeth Mary Collins come amministratore in data 31 lug 2014

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 29 mag 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 giu 2014

    Stato del capitale al 04 giu 2014

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Bilancio redatto al 31 mag 2013

    15 pagineAA

    Cessazione della carica di Misys Corporate Director Limited come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Joanna Hawkes come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Misys Corporate Secretary Limited come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Sanjay Patel come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Elizabeth Mary Collins come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Joanna Marageret Hawkes come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Bijal Patel come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 29 mag 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di MISYS SERVICES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HARKEN, John Van
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Amministratore
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomAmerican183654340001
    HOMER, Thomas Edward Timothy
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Amministratore
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    EnglandBritish146605570001
    OLIVIER, Johannes Jacobus
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Amministratore
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomSouth African199516920001
    BICHEMO, Tracey Lynne
    Flat E 9 Longridge Road
    SW5 9SB London
    Segretario
    Flat E 9 Longridge Road
    SW5 9SB London
    British16560470002
    BRAIN, Sarah Elizabeth Highton
    Portwood Cottage
    The Street Warninglid Haywards Heath
    RH17 5SZ West Sussex
    No 1
    England
    Segretario
    Portwood Cottage
    The Street Warninglid Haywards Heath
    RH17 5SZ West Sussex
    No 1
    England
    146638800001
    DURRANT, Zoe Vivienne
    Beehive Cottage
    Radford Road, Rous Lench
    WR11 4UL Evesham
    Worcestershire
    Segretario
    Beehive Cottage
    Radford Road, Rous Lench
    WR11 4UL Evesham
    Worcestershire
    British68141090001
    GRAY, Elizabeth Andrea
    16 Broad Street
    CV34 4LT Warwick
    Warwickshire
    Segretario
    16 Broad Street
    CV34 4LT Warwick
    Warwickshire
    British98035800001
    HAM, Richard Laurence
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    Segretario
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    British136433670001
    NASH, Andrew
    Lych Gates Angel Street
    Upper Bentley
    B97 5TA Redditch
    Worcestershire
    Segretario
    Lych Gates Angel Street
    Upper Bentley
    B97 5TA Redditch
    Worcestershire
    British48592890001
    WATERS, Paul Christopher
    The Old Vicarage
    High Street
    B50 4BQ Bidford On Avon
    Warwickshire
    Segretario
    The Old Vicarage
    High Street
    B50 4BQ Bidford On Avon
    Warwickshire
    British67435560001
    WILSON, Kevin Michael
    Strauss Road
    Chiswick
    W4 1DL London
    10
    Segretario
    Strauss Road
    Chiswick
    W4 1DL London
    10
    Other138835080001
    MISYS CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Kingdom Street
    Paddington
    W2 6BL London
    One
    United Kingdom
    Segretario
    Kingdom Street
    Paddington
    W2 6BL London
    One
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione07036299
    170463660001
    CHEESEWRIGHT, James
    Horton Meadow
    Heyshott
    GU29 0DL Midhurst
    West Sussex
    Amministratore
    Horton Meadow
    Heyshott
    GU29 0DL Midhurst
    West Sussex
    United KingdomBritish80646020001
    COLLINS, Elizabeth Mary
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Amministratore
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomBritish180406780001
    COPELAND, Philip Robert
    Crofton Sheldon Road
    Ickford
    HP18 9HY Aylesbury
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Crofton Sheldon Road
    Ickford
    HP18 9HY Aylesbury
    Buckinghamshire
    EnglandBritish44954570001
    EVANS, Howard
    Charlton Park House
    Charlton Park Gate
    GL53 7DJ Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    Charlton Park House
    Charlton Park Gate
    GL53 7DJ Cheltenham
    Gloucestershire
    United KingdomBritish56986700002
    EVANS, Robert Owen
    Field House
    Ashow
    CV8 2LE Kenilworth
    Warwickshire
    Amministratore
    Field House
    Ashow
    CV8 2LE Kenilworth
    Warwickshire
    British57011000002
    FARRIMOND, Nicholas Brian
    The Avenue
    WD17 4NU Watford
    51
    Hertfordshire
    England
    Amministratore
    The Avenue
    WD17 4NU Watford
    51
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish75357260001
    FLANAGAN, Andrew Henry
    75 Drymen Road
    Bearsden
    G61 2RH Glasgow
    Amministratore
    75 Drymen Road
    Bearsden
    G61 2RH Glasgow
    British42787120001
    GRAHAM, Ross King
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    Amministratore
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    United KingdomBritish61733920001
    HAM, Richard Laurence
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    Amministratore
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    United KingdomBritish136433670001
    HAWKES, Joanna Marageret
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Amministratore
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    EnglandBritish136214800001
    JOHNSON, Russell Alan
    Worcester Avenue
    Kings Hill West Malling
    ME19 4FL Kent
    14
    England
    United Kingdom
    Amministratore
    Worcester Avenue
    Kings Hill West Malling
    ME19 4FL Kent
    14
    England
    United Kingdom
    British130788060001
    MALONE, James Christopher
    Gloucester Park Apartments
    Ashburn Park
    SW7 4LL London
    Apartment 3g
    Amministratore
    Gloucester Park Apartments
    Ashburn Park
    SW7 4LL London
    Apartment 3g
    Usa/Irish122549240003
    MARSH, Howard Alexander David
    33 Rogers Way
    CV34 6PY Warwick
    Amministratore
    33 Rogers Way
    CV34 6PY Warwick
    United KingdomBritish111938620001
    MCMAHON, Jasper Philip
    Ground Floor Flat
    33 Warrington Crescent
    W9 1EJ London
    Amministratore
    Ground Floor Flat
    33 Warrington Crescent
    W9 1EJ London
    EnglandBritish45080250003
    NICHOLSON, John William
    50 Exning Road
    CB8 0AB Newmarket
    Suffolk
    Amministratore
    50 Exning Road
    CB8 0AB Newmarket
    Suffolk
    British45395580001
    OLDERSHAW, Peter Alan
    Wellesbourne 80 Newfield Road
    West Hagley
    DY9 0HY Stourbridge
    West Midlands
    Amministratore
    Wellesbourne 80 Newfield Road
    West Hagley
    DY9 0HY Stourbridge
    West Midlands
    British2546430001
    PATEL, Bijal Mahendra
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    Amministratore
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United KingdomBritish161424380001
    PATEL, Sanjay Surendra
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Amministratore
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomBritish147221810001
    TAYLOR, David
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    Amministratore
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    British1439590001
    WHITTY, Brian Howard
    Ruxley House Rowney Green Lane
    Rowney Green
    B48 7QF Alvechurch
    Worcestershire
    Amministratore
    Ruxley House Rowney Green Lane
    Rowney Green
    B48 7QF Alvechurch
    Worcestershire
    British36622750002
    WOODWARD, Andrew Paul
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Amministratore
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomBritish100885620001
    MISYS CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    One Kingdom Street
    W2 6BL Paddington
    Group Secretariat Misys Plc
    London
    Amministratore
    One Kingdom Street
    W2 6BL Paddington
    Group Secretariat Misys Plc
    London
    132964180001

    MISYS SERVICES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 27 lug 2012
    Consegnato il 06 ago 2012
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All property,all the shares and investments and all corresponding related rights first fixed charge all other interests in any property and the benefit of all other agreements relating to land,all of its right title and interest in the charged intellectual property see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Credit Suisse Ag,Cayman Islands Branch
    Transazioni
    • 06 ago 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 24 ago 2015Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off (olso) dated 3RD july 1995
    Creato il 19 dic 2006
    Consegnato il 29 dic 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 29 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 feb 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995
    Creato il 17 set 2003
    Consegnato il 01 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 01 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 feb 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3 july 1995
    Creato il 11 set 2003
    Consegnato il 24 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 24 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 feb 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3RD july 1995 and
    Creato il 29 lug 2003
    Consegnato il 12 ago 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 12 ago 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 feb 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995 (the letter)
    Creato il 23 ott 2002
    Consegnato il 13 nov 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 13 nov 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 feb 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    MISYS SERVICES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    06 ott 2017Data di scioglimento
    25 ago 2015Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Hugh Francis Jesseman
    3 Field Court
    Grays Inn
    WC1R 5EF London
    Praticante
    3 Field Court
    Grays Inn
    WC1R 5EF London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0