TRANSCOMM PLC

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTRANSCOMM PLC
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà per azioni
    Numero di società 01942212
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TRANSCOMM PLC?

    • (7415) /

    Dove si trova TRANSCOMM PLC?

    Indirizzo della sede legale
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TRANSCOMM PLC?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TARDIS TRANSCOMMUNICATIONS PLC13 dic 199913 dic 1999
    SCOTSWOOD INDUSTRIES PLC21 set 199521 set 1995
    BISCAY INVESTMENTS PLC02 nov 199202 nov 1992
    LAZADEAL PUBLIC LIMITED COMPANY 08 giu 198908 giu 1989
    PERMA INDUSTRIES PUBLIC LIMITED COMPANY12 ago 198712 ago 1987
    LAZADEAL PUBLIC LIMITED COMPANY 27 ago 198527 ago 1985

    Quali sono gli ultimi bilanci di TRANSCOMM PLC?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per TRANSCOMM PLC?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dettagli del direttore cambiati per Timothy James Beresford Shaw il 24 nov 2011

    2 pagineCH01

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    9 pagine4.71

    Indirizzo della sede legale modificato da 81 Newgate Street London EC1A 7AJ in data 18 apr 2011

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 30 mar 2011

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Bilancio redatto al 31 mar 2010

    15 pagineAA

    Cessazione della carica di Adam Baird come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 13 giu 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 lug 2010

    Stato del capitale al 08 lug 2010

    • Capitale: GBP 5,261,021.7
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Roger Vigilance il 26 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Timothy James Beresford Shaw il 26 ott 2009

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2009

    15 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Adam John Baird il 26 ott 2009

    2 pagineCH01

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 mar 2008

    15 pagineAA

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 mar 2007

    14 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di TRANSCOMM PLC?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    NEWGATE STREET SECRETARIES LIMITED
    81 Newgate Street
    EC1A 7AJ London
    Segretario
    81 Newgate Street
    EC1A 7AJ London
    45816950001
    SHAW, Timothy James Beresford
    Bt Centre
    81 Newgate Street
    EC1A 7AJ London
    Pp A9d
    United Kingdom
    Amministratore
    Bt Centre
    81 Newgate Street
    EC1A 7AJ London
    Pp A9d
    United Kingdom
    EnglandBritishSolicitor104815050001
    VIGILANCE, Roger Orin
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Amministratore
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    United KingdomBritishCorporate Development Director112894720001
    BACKHOUSE, Russell John
    Pedlars Cottage
    Winterbourne
    RG20 8AS Newbury
    Berkshire
    Segretario
    Pedlars Cottage
    Winterbourne
    RG20 8AS Newbury
    Berkshire
    BritishCompany Acc37568000006
    BALME, Anthony David Nettleon
    9 Broad Street
    SO24 9AR Alresford
    Hampshire
    Segretario
    9 Broad Street
    SO24 9AR Alresford
    Hampshire
    British155915350002
    BUCKMASTER, Douglas Graham
    The Flat Lindisfarne Elms Avenue
    Parkstone
    BH14 8EE Poole
    Dorset
    Segretario
    The Flat Lindisfarne Elms Avenue
    Parkstone
    BH14 8EE Poole
    Dorset
    British13913790001
    HOMAN-RUSSELL, William Barry
    Heath Barn Cottage Hampers Lane
    Storrington
    RH20 3HY Pulborough
    West Sussex
    Segretario
    Heath Barn Cottage Hampers Lane
    Storrington
    RH20 3HY Pulborough
    West Sussex
    British1227500001
    PRIOR, Stephen John
    16a Haygarth Place
    High Street Wimbledon
    SW19 5BX London
    Segretario
    16a Haygarth Place
    High Street Wimbledon
    SW19 5BX London
    BritishChartered Secretary1167820004
    BACKHOUSE, Russell John
    Pedlars Cottage
    Winterbourne
    RG20 8AS Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Pedlars Cottage
    Winterbourne
    RG20 8AS Newbury
    Berkshire
    BritishCompany Acc37568000006
    BAIRD, Adam John
    81 Newgate Street
    London
    EC1A 7AJ
    Amministratore
    81 Newgate Street
    London
    EC1A 7AJ
    United KingdomBritishAccountant133855430001
    BALME, Anthony David Nettleon
    9 Broad Street
    SO24 9AR Alresford
    Hampshire
    Amministratore
    9 Broad Street
    SO24 9AR Alresford
    Hampshire
    United KingdomBritishWool Broker155915350002
    BOWEN, David
    59 Farm Road
    Winchmore Hill
    N21 3JD London
    Amministratore
    59 Farm Road
    Winchmore Hill
    N21 3JD London
    BritishAccountant106789240001
    BROCKLEBANK, Aubrey Thomas, Sir
    Hunters Lodge St Andrews Lane
    Titchmarsh
    NN14 3DN Kettering
    Northamptonshire
    Amministratore
    Hunters Lodge St Andrews Lane
    Titchmarsh
    NN14 3DN Kettering
    Northamptonshire
    Gb-GbnBritishCompany Director56733000005
    CAMILLERI, John Michael
    55 Hihglands
    Whiteparish
    SP5 2SX Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    55 Hihglands
    Whiteparish
    SP5 2SX Salisbury
    Wiltshire
    BritishDirector35185850001
    COLLIER, David
    12 Coniston Road
    Blackrod
    BL6 5DN Bolton
    Lancashire
    Amministratore
    12 Coniston Road
    Blackrod
    BL6 5DN Bolton
    Lancashire
    BritishCompany Director20891600001
    COPPIN, Raymond
    9 Lee Lane
    Pinkneys Green
    SL6 6NU Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    9 Lee Lane
    Pinkneys Green
    SL6 6NU Maidenhead
    Berkshire
    BritishChartered Accountant93818410001
    DOYLE, Raymond
    6 Whitecroft
    Nailsworth
    GL6 0NS Stroud
    Gloucestershire
    Amministratore
    6 Whitecroft
    Nailsworth
    GL6 0NS Stroud
    Gloucestershire
    BritishCompany Director35730720001
    FITTON, Andrew Charles
    The Cedars Scholards Lane
    Ramsbury
    SN8 2PL Marlborough
    Wiltshire
    Amministratore
    The Cedars Scholards Lane
    Ramsbury
    SN8 2PL Marlborough
    Wiltshire
    BritishCompany Director7527160002
    FORMBY, Paul Madders
    Grange Hall
    The Grange
    GY1 2QJ St Peter Port
    Guernsey
    Amministratore
    Grange Hall
    The Grange
    GY1 2QJ St Peter Port
    Guernsey
    BritishBusiness Consultant87104890001
    FOX, John
    270 Singlewell Road
    DA11 7RE Gravesend
    Kent
    Amministratore
    270 Singlewell Road
    DA11 7RE Gravesend
    Kent
    EnglandBritishTax Manager76187760001
    FURMSTON, Jonathan Mark
    St. Leonards Park House
    RH13 6EG Horsham
    4
    Sussex
    Amministratore
    St. Leonards Park House
    RH13 6EG Horsham
    4
    Sussex
    United KingdomBritishBt Executive136631740001
    HAYNES, Vivienne Ann
    24 North Hill
    Highgate
    N6 4QA London
    Amministratore
    24 North Hill
    Highgate
    N6 4QA London
    EnglandBritishSolicitor54182100002
    HOMAN-RUSSELL, William Barry
    Heath Barn Cottage Hampers Lane
    Storrington
    RH20 3HY Pulborough
    West Sussex
    Amministratore
    Heath Barn Cottage Hampers Lane
    Storrington
    RH20 3HY Pulborough
    West Sussex
    EnglandBritishEngineer1227500001
    HUGHES, David Edward
    107 Henley Road
    IP1 4NG Ipswich
    Amministratore
    107 Henley Road
    IP1 4NG Ipswich
    EnglandBritishEngineer111355350001
    HUNT, Ashton Willis
    2 West Hayes
    Hatfield Heath
    CM22 7DH Bishop's Stortford
    Herts
    Amministratore
    2 West Hayes
    Hatfield Heath
    CM22 7DH Bishop's Stortford
    Herts
    BritishAccountant88138590001
    JARVIS, John Edwin
    Hurstbury Combe Lane
    Wormley
    GU8 5JX Godalming
    Surrey
    Amministratore
    Hurstbury Combe Lane
    Wormley
    GU8 5JX Godalming
    Surrey
    BritishCompany Director62045640001
    MATTHEWS, Roderick Alfred
    Aros House
    Rhu
    G84 8NJ Helensburgh
    Dunbartonshire
    Amministratore
    Aros House
    Rhu
    G84 8NJ Helensburgh
    Dunbartonshire
    BritishChairman74872510003
    MCNULTY, Kevin
    4 Highworth
    Compton Lane
    RH13 5PU Horsham
    West Sussex
    Amministratore
    4 Highworth
    Compton Lane
    RH13 5PU Horsham
    West Sussex
    BritishBt Executive98350030001
    MODI, Rajul Kishore
    2 Wildcroft Gardens
    Canons Park
    HA8 6TJ Edgware
    Middlesex
    Amministratore
    2 Wildcroft Gardens
    Canons Park
    HA8 6TJ Edgware
    Middlesex
    BritishBt Executive98350020001
    MONKCOM, Stephen Roderick
    6 Carnoustie Grove
    Bletchley
    MK3 7RP Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    6 Carnoustie Grove
    Bletchley
    MK3 7RP Milton Keynes
    Buckinghamshire
    BritishDirector9918790001
    NICOLLE, Adrian Christopher
    Vyne Lodge
    Easton Common Hill, Winterslow
    SP5 1QD Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    Vyne Lodge
    Easton Common Hill, Winterslow
    SP5 1QD Salisbury
    Wiltshire
    EnglandBritishDirector112555010001
    PATEL, Chetan Kumar
    4 Airedale Road
    Ealing
    W5 4SD London
    Amministratore
    4 Airedale Road
    Ealing
    W5 4SD London
    BritishBusiness Manager108844090001
    PULLIN, Richard Anthony
    Bendysh Hall Barn
    Radwinter
    CB10 2UA Saffron Walden
    Essex
    Amministratore
    Bendysh Hall Barn
    Radwinter
    CB10 2UA Saffron Walden
    Essex
    United KingdomBritishManaging Director103638490001
    REDMOND, Peter
    54 St Albans Crescent
    N22 5NB London
    Amministratore
    54 St Albans Crescent
    N22 5NB London
    BritishCorporate Consultancy37127970001
    SHEARD, Matthew David George
    Flat 2
    73 Munster Road
    SW6 5RE London
    Amministratore
    Flat 2
    73 Munster Road
    SW6 5RE London
    United KingdomBritishAccountant111321360001

    TRANSCOMM PLC ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage debenture
    Creato il 28 apr 2003
    Consegnato il 03 mag 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Singer & Friedlander Limited
    Transazioni
    • 03 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 04 ott 2001
    Consegnato il 12 ott 2001
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Singer & Friedlander Factors Limited
    Transazioni
    • 12 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage debenture
    Creato il 29 set 1995
    Consegnato il 17 ott 1995
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 17 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    Fixed and floating charge
    Creato il 19 set 1990
    Consegnato il 25 set 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 25 set 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 24 mar 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 12 nov 1987
    Consegnato il 28 nov 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Tsb England of Wales PLC
    Transazioni
    • 28 nov 1987Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 21 mar 1986
    Consegnato il 02 apr 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 02 apr 1986Registrazione di un'ipoteca

    TRANSCOMM PLC ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    28 gen 2012Data di scioglimento
    30 mar 2011Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Elizabeth Anne Bingham
    Ernst & Young
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praticante
    Ernst & Young
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Patrick Joseph Brazzill
    Ernst & Young
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praticante
    Ernst & Young
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0