O L DEC 18 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàO L DEC 18 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01942994
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di O L DEC 18 LIMITED?

    • (6521) /

    Dove si trova O L DEC 18 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Juniper House
    The Drive
    CM13 3BE Warley Hill Business Park
    Brentwood
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di O L DEC 18 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    COMMERZBANK LEASING DECEMBER (18) LIMITED13 apr 201013 apr 2010
    A & L CF SEPTEMBER (1) LIMITED07 lug 200307 lug 2003
    SOVEREIGN LIMITED30 apr 198730 apr 1987
    HARRISON GREEN INVESTMENTS LIMITED30 ago 198530 ago 1985

    Quali sono gli ultimi bilanci di O L DEC 18 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al14 mar 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per O L DEC 18 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    7 pagine4.71

    Indirizzo della sede legale modificato da 43-45 Butts Green Road Hornchurch Essex RM11 2JX in data 14 mar 2012

    1 pagineAD01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 06 dic 2011

    8 pagine4.68

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 07 dic 2010

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Indirizzo della sede legale modificato da Verrington House Old London Road Knockholt Sevenoaks Kent TN14 7LU in data 20 dic 2010

    2 pagineAD01

    Cessazione della carica di Michael Beebee come amministratore

    2 pagineTM01

    Nomina di Mr Stephen Edward Hubble come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Paul Burrows come amministratore

    2 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da 30 Gresham Street London EC2V 7PG United Kingdom in data 09 dic 2010

    2 pagineAD01

    Nomina di Stephen Edward Hubble come segretario

    3 pagineAP03

    Cessazione della carica di James Wall come segretario

    2 pagineTM02

    Cessazione della carica di Neil Aiken come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Anthony Levy come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Richard Birch come amministratore

    2 pagineTM01

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 07 dic 2010

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Bilancio redatto al 14 mar 2010

    11 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Richard Alastair Birch il 30 nov 2010

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 01 lug 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 lug 2010

    Stato del capitale al 14 lug 2010

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Dettagli del segretario cambiati

    3 pagineCH03

    Risoluzioni

    Resolutions
    17 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica del Memorandum e/o degli Articoli di Associazione

    RES01

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed a & l cf september (1) LIMITED\certificate issued on 13/04/10
    2 pagineCERTNM
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 06 apr 2010

    RES15

    Chi sono gli amministratori di O L DEC 18 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HUBBLE, Stephen Edward
    Old London Road
    Knockholt
    TN14 7LU Sevenoaks
    Verrington House
    Kent
    Segretario
    Old London Road
    Knockholt
    TN14 7LU Sevenoaks
    Verrington House
    Kent
    British156260480001
    HUBBLE, Stephen Edward
    Old London Road
    Knockholt
    TN14 7LU Sevenoaks
    Verrington House
    Kent
    United Kingdom
    Amministratore
    Old London Road
    Knockholt
    TN14 7LU Sevenoaks
    Verrington House
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritish48992140001
    DUVAL, Michael John
    Greenfields
    Ponds Road
    CM2 8QP Chelmsford
    Essex
    Segretario
    Greenfields
    Ponds Road
    CM2 8QP Chelmsford
    Essex
    British72879690001
    HAWKER, Richard Allen
    31 Narborough Road South
    LE3 2HA Leicester
    Leistershire
    Segretario
    31 Narborough Road South
    LE3 2HA Leicester
    Leistershire
    British78397850001
    HEPPLEWHITE, Julian
    The Old Rectory
    Rectory End
    LE8 9EW Burton Overy
    Leicestershire
    Segretario
    The Old Rectory
    Rectory End
    LE8 9EW Burton Overy
    Leicestershire
    British51619950002
    SINCLAIR FORD, Ian Andrew
    Stainton 103 Menlove Avenue
    Calderstones
    L18 3HP Liverpool
    Segretario
    Stainton 103 Menlove Avenue
    Calderstones
    L18 3HP Liverpool
    British58189030001
    TAYLOR, Charles Stuart
    Balnacroft 8 Stonewalls
    Rosemary Lane Rossett
    LL12 0LG Wrexham
    Flintshire
    Segretario
    Balnacroft 8 Stonewalls
    Rosemary Lane Rossett
    LL12 0LG Wrexham
    Flintshire
    British27312630001
    WALL, James Cameron
    Gresham Street
    EC2V 7PG London
    30
    United Kingdom
    Segretario
    Gresham Street
    EC2V 7PG London
    30
    United Kingdom
    British149989130001
    AIKEN, Neil Gordon
    Gresham Street
    EC2V 7PG London
    30
    United Kingdom
    Amministratore
    Gresham Street
    EC2V 7PG London
    30
    United Kingdom
    United KingdomBritish43380390001
    BEEBEE, Michael Christopher
    Old London Road
    Knockholt
    TN14 7LU Sevenoaks
    Verrington House
    Kent
    Amministratore
    Old London Road
    Knockholt
    TN14 7LU Sevenoaks
    Verrington House
    Kent
    United KingdomBritish101122510002
    BIRCH, Richard Alastair
    Gresham Street
    EC2V 7PG London
    30
    United Kingdom
    Amministratore
    Gresham Street
    EC2V 7PG London
    30
    United Kingdom
    United KingdomBritish76806940008
    BRITTAIN, Frederick Humphrey
    C/O Sovereign Leasing Plc
    298 Deansgate
    M3 4HH Manchester
    Gtr Manchester
    Amministratore
    C/O Sovereign Leasing Plc
    298 Deansgate
    M3 4HH Manchester
    Gtr Manchester
    British23574940002
    BURROWS, Paul Richard
    Old London Road
    Knockholt
    TN14 7LU Sevenoaks
    Verrington House
    Kent
    Amministratore
    Old London Road
    Knockholt
    TN14 7LU Sevenoaks
    Verrington House
    Kent
    United KingdomEnglish126643220002
    DUFFY, Anthony Paul
    7 Outram Road
    Alexandra Park
    N22 7AB London
    Amministratore
    7 Outram Road
    Alexandra Park
    N22 7AB London
    EnglandBritish72286750001
    EVANS, Martin William
    Deansgate
    M3 4HH Manchester
    298
    Amministratore
    Deansgate
    M3 4HH Manchester
    298
    EnglandBritish55210060002
    FAULKNER, Geoffrey Arthur
    Triton Square
    Regent's Place
    NW1 3AN London
    2
    United Kingdom
    Amministratore
    Triton Square
    Regent's Place
    NW1 3AN London
    2
    United Kingdom
    United KingdomBritish147921000001
    GUGGLBERGER, Klaus
    Graf Starhembergasse 4
    1040 Vienna
    Austria
    Amministratore
    Graf Starhembergasse 4
    1040 Vienna
    Austria
    Austrian32780800002
    JARDINE, John
    The Old School Guilden Sutton Lane
    Guilden Sutton
    CH3 7EX Chester
    Amministratore
    The Old School Guilden Sutton Lane
    Guilden Sutton
    CH3 7EX Chester
    British31897840002
    JONES, Christopher Stanley
    Flat 34 Roberts Court
    45-49 Barkston Gardens Kensington
    SW5 0ES London
    Amministratore
    Flat 34 Roberts Court
    45-49 Barkston Gardens Kensington
    SW5 0ES London
    United KingdomBritish152017480001
    LEE, Andrew Philip, Mr.
    29 Alder Lane
    Balsall Common
    CV7 7DZ Solihull
    Amministratore
    29 Alder Lane
    Balsall Common
    CV7 7DZ Solihull
    United KingdomBritish73882180001
    LEVY, Anthony David
    Gresham Street
    EC2V 7PG London
    30
    United Kingdom
    Amministratore
    Gresham Street
    EC2V 7PG London
    30
    United Kingdom
    United KingdomBritish98888430001
    MARKS, Norman
    4 Old Hall Park
    Guilden Sutton
    CH3 7ER Chester
    Amministratore
    4 Old Hall Park
    Guilden Sutton
    CH3 7ER Chester
    British48820520002
    MORLEY, Colin Richard
    Deansgate
    M3 4HH Manchester
    298
    United Kingdom
    Amministratore
    Deansgate
    M3 4HH Manchester
    298
    United Kingdom
    EnglandBritish89102840002
    PATERSON, William Hamilton
    Laigh Brownmuir House
    Glassford
    ML10 6TX Strathaven
    Lanarkshire
    Amministratore
    Laigh Brownmuir House
    Glassford
    ML10 6TX Strathaven
    Lanarkshire
    ScotlandBritish147129850001
    ROGERS, Malcolm Courtney
    2 Wheatley Royd Barn
    Brearley Lane Luddendenfoot
    HX2 6HX Halifax
    West Yorkshire
    Amministratore
    2 Wheatley Royd Barn
    Brearley Lane Luddendenfoot
    HX2 6HX Halifax
    West Yorkshire
    EnglandBritish72877280001
    ROUGIER, Alan Toby
    Triton Square
    Regent's Place
    NW1 3AN London
    2
    United Kingdom
    Amministratore
    Triton Square
    Regent's Place
    NW1 3AN London
    2
    United Kingdom
    United KingdomBritish108954830002
    SCOTT, Ian Garden
    Riverbank House
    AB34 5JD Aboyne
    Aberdeenshire
    Amministratore
    Riverbank House
    AB34 5JD Aboyne
    Aberdeenshire
    ScotlandBritish79132120001
    SWANN, Andrew Blyth
    Nield House
    Beamond End
    HP7 0QT Amersham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Nield House
    Beamond End
    HP7 0QT Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish60626890003
    TAYLOR, Charles Stuart
    Balnacroft 8 Stonewalls
    Rosemary Lane Rossett
    LL12 0LG Wrexham
    Flintshire
    Amministratore
    Balnacroft 8 Stonewalls
    Rosemary Lane Rossett
    LL12 0LG Wrexham
    Flintshire
    United KingdomBritish27312630001
    TOWERS, Robert Leslie
    27 Winwick Park Avenue
    Winwick
    WA2 8XB Warrington
    Amministratore
    27 Winwick Park Avenue
    Winwick
    WA2 8XB Warrington
    United KingdomBritish65275200002

    O L DEC 18 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A lessor proceeds account assignment
    Creato il 15 mar 2010
    Consegnato il 26 mar 2010
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All its rights title and interest present and future in and to the assigned moneys and the assigned account together with any certificates of deposit, deposit receipts or other instruments or securities relatiing thereto see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Maersk Line UK Limited
    Transazioni
    • 26 mar 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Chattel mortgage
    Creato il 04 mar 2010
    Consegnato il 12 mar 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All present and future rights and title to and interest in the containers and compressors identified in schedule 1, including all component parts, accessories or other equipment attached. All insurances and any requisition compensation paid to or received by the company see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Maersk Line UK Limited
    Transazioni
    • 12 mar 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Specific legal mortgage no 7
    Creato il 31 ago 2004
    Consegnato il 01 set 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The equipment identified by serial numbers described in or attached to schedule 1 to the specific mortgage the benefit of all insurances of the specific equipment and all warranties, contracts or other agreements relating to the condition, operation, use or repair of the specific equipment or any part thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • P&O Nedlloyd Limited
    Transazioni
    • 01 set 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Specific legal mortgage no 6
    Creato il 30 lug 2004
    Consegnato il 02 ago 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the company's right, title and interest present and future in and to: (a) the equipment identified by the serial numbers described in or attached to schedule 1 to the specific mortgage (the "specific equipment") (b) the benefit of all insurances of the specific equipment (c) any compensation payable in respect of the compulsory acquisition or requisition for title of the specific equipment; and (d) all warranties, contracts or other agreements relating to the condition, operation, use or repair of the specific equipment or any part thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • P&O Nedlloyd Limited
    Transazioni
    • 02 ago 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Specific legal mortgage no.5
    Creato il 30 giu 2004
    Consegnato il 05 lug 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The equipment indentified by the serial numbers described in or attached to the schedule 1 to the specific mortgage the benefit of all insurances of the specific equipment any compensation payable in respect of the compulsory acquisition or requisition for title of the specific equipment and all warranties contracts or agreements relating to the condition operation use or repair of the specific equipment or any part thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • P&O Nedlloyd Limited
    Transazioni
    • 05 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Specific legal mortgage no 4
    Creato il 28 mag 2004
    Consegnato il 01 giu 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The equipment indentified by the serial numbers described in or attached to the schedule 1 to the specific mortgage the benefit of all insurances of the specific equipment any compensation payable in respect of the compulsory acquisition or requisition for title of the specific equipment and all warranties contracts or agreements relating to the condition operation use or repair of the specific equipment or any part thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • P&O Nedlloyd Limited
    Transazioni
    • 01 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Specific legal mortgage no 3
    Creato il 29 apr 2004
    Consegnato il 07 mag 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All right title and interest in and to the equipment, the benefit of all insurances of the specific equipment, any compensation payable and all warranties contracts or other agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • P&O Nedlloyd Limited
    Transazioni
    • 07 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Specific legal mortgage no 2
    Creato il 31 mar 2004
    Consegnato il 06 apr 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the company's right, title and interest in the equipment, the benefit of all insurances, any compensation payable, all warranties, contracts or other agreements relating to the equipment,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • P&O Nedlloyd Limited
    Transazioni
    • 06 apr 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Specific legal mortgage no 1
    Creato il 27 feb 2004
    Consegnato il 04 mar 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All right title and interest in and to the equipment,the benefit of all insurances,warranties,contracts or other agreements thereon; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • P & O Nedlloyd Limited
    Transazioni
    • 04 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    A container mortgage
    Creato il 27 feb 2004
    Consegnato il 04 mar 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All right title and interest and benefit in and to the equipment,benefit of all insurances and any compensation payable; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • P & O Nedlloyd Limited
    Transazioni
    • 04 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Lessor proceeds account
    Creato il 27 feb 2004
    Consegnato il 04 mar 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All right title and interest in and to the interest bearing dollar account no 39775201 and all moneys,certificates of deposit or other instruments thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • P & O Nedlloyd Limited
    Transazioni
    • 04 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)

    O L DEC 18 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    23 ott 2012Data di scioglimento
    07 dic 2010Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Jonathan Mark Birch
    Frp Advisory Llp 10 Furnival Street
    EC4A 1YH London
    Praticante
    Frp Advisory Llp 10 Furnival Street
    EC4A 1YH London
    Gareth Rutt Morris
    10 Furnival Street
    EC4A 1YH London
    Praticante
    10 Furnival Street
    EC4A 1YH London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0