BIOCON (U.K.) LIMITED

BIOCON (U.K.) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBIOCON (U.K.) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01946623
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BIOCON (U.K.) LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova BIOCON (U.K.) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    26th Floor Portland House
    Bressenden Place
    SW1E 5BG London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di BIOCON (U.K.) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2008

    Quali sono le ultime deposizioni per BIOCON (U.K.) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    2 pagineDS01

    Cessazione della carica di Penelope Cheatle come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di David Allan Turner come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 01 giu 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 giu 2010

    Stato del capitale al 09 giu 2010

    • Capitale: GBP 3,250
    SH01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2008

    5 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Penelope Anne Cheatle il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio modificato redatto al 31 dic 2006

    5 pagineAAMD

    Bilancio modificato redatto al 31 dic 2007

    5 pagineAAMD

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288c

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    5 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    5 pagineAA

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di BIOCON (U.K.) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    O.H. SECRETARIAT LIMITED
    Floor
    Portland House Bressenden Place
    SW1E 5BG London
    26th
    United Kingdom
    Segretario
    Floor
    Portland House Bressenden Place
    SW1E 5BG London
    26th
    United Kingdom
    129226660002
    TURNER, David Allan, Mr.
    Floor
    Portland House Bressenden Place
    SW1E 5BG London
    26th
    United Kingdom
    Amministratore
    Floor
    Portland House Bressenden Place
    SW1E 5BG London
    26th
    United Kingdom
    United KingdomBritish147932780001
    O H DIRECTOR LIMITED
    Portland House
    Bressenden Place
    SW1E 5BG London
    26th Floor
    Amministratore
    Portland House
    Bressenden Place
    SW1E 5BG London
    26th Floor
    95653690002
    ANDREWS, Raymond Maurice
    Lympne Court
    Castle Close
    CT21 4LQ Lympne
    Kent
    Segretario
    Lympne Court
    Castle Close
    CT21 4LQ Lympne
    Kent
    British1505690001
    GROSSET, Margaret Wilhelmina
    7 Arnprior Place
    KA7 4PT Alloway
    Ayrshire
    Segretario
    7 Arnprior Place
    KA7 4PT Alloway
    Ayrshire
    British54009620001
    HUSON, David Paul
    10 Hillcrest Close
    Kennington
    TN24 9QT Ashford
    Kent
    Segretario
    10 Hillcrest Close
    Kennington
    TN24 9QT Ashford
    Kent
    British32459420001
    IRVINE, Scott Macdonald
    69 Streatham Court
    Streatham High Road
    SW16 1DJ London
    Segretario
    69 Streatham Court
    Streatham High Road
    SW16 1DJ London
    British79545730002
    RIVETT, Michael John Edward
    61 Park End
    BR1 4AW Bromley
    Kent
    Segretario
    61 Park End
    BR1 4AW Bromley
    Kent
    British813120001
    STIFFELL, Caroline Jane
    15 Thornton Close
    Willesborough Lees
    TN24 0QU Ashford
    Kent
    Segretario
    15 Thornton Close
    Willesborough Lees
    TN24 0QU Ashford
    Kent
    British120397120001
    WAKEFIELD, Barry John
    The Old Manse
    27 High Street
    PE26 1AE Ramsey
    Cambridgeshire
    Segretario
    The Old Manse
    27 High Street
    PE26 1AE Ramsey
    Cambridgeshire
    British27554930001
    WHITESIDE, Sonia Jane
    139 Amhurst Road
    E8 2AW London
    Segretario
    139 Amhurst Road
    E8 2AW London
    British71755560003
    WINCHESTER, Emma
    The Coach House
    173a Merton Road
    SW19 1EE London
    Segretario
    The Coach House
    173a Merton Road
    SW19 1EE London
    British95340090006
    THE NEW HOVEMA LIMITED
    Unilever House
    Blackfriars
    EC4P 4BQ London
    Segretario
    Unilever House
    Blackfriars
    EC4P 4BQ London
    602120001
    ATKINSON, Anthony
    Rathkeale
    Castle Road Saltwood
    CT21 4QZ Hythe
    Kent
    Amministratore
    Rathkeale
    Castle Road Saltwood
    CT21 4QZ Hythe
    Kent
    EnglandBritish37984870001
    ATKINSON, Anthony
    Rathkeale
    Castle Road Saltwood
    CT21 4QZ Hythe
    Kent
    Amministratore
    Rathkeale
    Castle Road Saltwood
    CT21 4QZ Hythe
    Kent
    EnglandBritish37984870001
    AUCHINCLOSS, Leslie
    Strand Farm
    Currabinny
    IRISH Carrigaline
    County Cork
    Eire
    Amministratore
    Strand Farm
    Currabinny
    IRISH Carrigaline
    County Cork
    Eire
    British58742990004
    CHEATLE, Penelope Anne
    Portland House
    Bressenden Place
    SW1E 5BG London
    26th Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    Portland House
    Bressenden Place
    SW1E 5BG London
    26th Floor
    United Kingdom
    British34645590005
    FORREST, Geoffrey, Dr
    The Beeches
    32 Station Road
    CT21 5PR Hythe
    Kent
    Amministratore
    The Beeches
    32 Station Road
    CT21 5PR Hythe
    Kent
    British92615710001
    FURLONG, Richard Paul
    69 Seabrook Road
    CT21 5QW Hythe
    Kent
    Amministratore
    69 Seabrook Road
    CT21 5QW Hythe
    Kent
    British1505710001
    MCCARTHY, James Martin
    23 Weald Road
    TN13 1QQ Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    23 Weald Road
    TN13 1QQ Sevenoaks
    Kent
    EnglandIrish75666140001
    RICKARD, Michael David
    42 Beryl Road
    Noctorum
    CH43 9RT Birkenhead
    Merseyside
    Amministratore
    42 Beryl Road
    Noctorum
    CH43 9RT Birkenhead
    Merseyside
    British15024980001
    SAMUEL, Michael John, Mr.
    38 St Botolphs Road
    TN13 3AG Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    38 St Botolphs Road
    TN13 3AG Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritish13896090003
    SUTHERS, Richard Gerald
    Park Farm Fosten Green
    Biddenden
    TN27 8ER Ashford
    Kent
    Amministratore
    Park Farm Fosten Green
    Biddenden
    TN27 8ER Ashford
    Kent
    EnglandBritish164006550001
    SUTHERS, Richard Gerald
    Park Farm Fosten Green
    Biddenden
    TN27 8ER Ashford
    Kent
    Amministratore
    Park Farm Fosten Green
    Biddenden
    TN27 8ER Ashford
    Kent
    EnglandBritish164006550001
    BLACKFRIARS NOMINEES LIMITED
    Unilever House
    Blackfriars
    EC4P 4BQ London
    Amministratore
    Unilever House
    Blackfriars
    EC4P 4BQ London
    602130001
    THE NEW HOVEMA LIMITED
    Unilever House
    Blackfriars
    EC4P 4BQ London
    Amministratore
    Unilever House
    Blackfriars
    EC4P 4BQ London
    602120001

    BIOCON (U.K.) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 16 nov 1988
    Consegnato il 28 nov 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Upper moorend farm mamble kidderminster hereford & worcester.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 28 nov 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 20 giu 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 06 lug 1987
    Consegnato il 20 lug 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 lug 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 21 gen 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 06 lug 1987
    Consegnato il 20 giu 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Including trade fixtures.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 giu 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 20 giu 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security registered in scotland an 16/7/86
    Creato il 16 lug 1986
    Consegnato il 22 lug 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All there parts of the barony lands and estate of pitliver and other lying partly in the parish of dunferm line and partly in torrybeem in the country of fife.
    Persone aventi diritto
    • Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 22 lug 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 21 gen 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 27 nov 1985
    Consegnato il 06 dic 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land & buildings lying to the south of a road leading to great whitley from tenbury lindbridge parish hereford worcester title no. Hw 844.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 dic 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 21 gen 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0