MILLS GROUP LIMITED

MILLS GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMILLS GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01948839
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MILLS GROUP LIMITED?

    • Commercio al dettaglio in negozi non specializzati con prevalenza di alimentari, bevande o tabacco (47110) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
    • Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in negozi specializzati (47260) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
    • Altro commercio al dettaglio di alimentari in negozi specializzati (47290) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
    • Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria in negozi specializzati (47620) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

    Dove si trova MILLS GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MILLS GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MILLS NEWSAGENTS LIMITED12 nov 198512 nov 1985
    SWIFT 582 LIMITED20 set 198520 set 1985

    Quali sono gli ultimi bilanci di MILLS GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al24 feb 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per MILLS GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    9 pagineLIQ13

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato Tesco House Shire Park Kestrel Way Welwyn Garden City AL7 1GA

    2 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Tesco House Shire Park Kestrel Way Welwyn Garden City AL7 1GA United Kingdom a Tesco House Shire Park Kestrel Way Welwyn Garden City AL7 1GA

    2 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da Apex Road Brownhills Walsall West Midlands WS8 7HU United Kingdom a 1 More London Place London SE1 2AF in data 21 feb 2019

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    6 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 28 gen 2019

    LRESSP

    Cessazione della carica di Tracey Clements come amministratore in data 14 gen 2019

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Robert John Welch come amministratore in data 14 gen 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Tesco Services Limited come amministratore in data 14 gen 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Steven Blair come amministratore in data 14 gen 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Jonny Mcquarrie come amministratore in data 14 gen 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione di Mills Group Holdings Limited come persona con controllo significativo il 31 mar 2017

    1 paginePSC07

    Dichiarazione di conformità presentata il 12 ott 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Notifica di One Stop Stores Limited come persona con controllo significativo il 31 mar 2017

    2 paginePSC02

    Conto per una società dormiente redatto al 24 feb 2018

    3 pagineAA

    Nomina di Steven Blair come amministratore in data 17 ott 2017

    2 pagineAP01

    Nomina di Jonny Mcquarrie come amministratore in data 17 ott 2017

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 12 ott 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 25 feb 2017

    3 pagineAA

    Cessazione della carica di Andrew Paul King come amministratore in data 26 lug 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Mark Benjamin Williams come amministratore in data 23 lug 2017

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mag 2017 con aggiornamenti

    7 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da Apex Road Brownhills Walsall West Midlands WS8 7TS a Apex Road Brownhills Walsall West Midlands WS8 7HU in data 03 gen 2017

    1 pagineAD01

    Chi sono gli amministratori di MILLS GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    EVERITT, Mark Edward
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Segretario
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    160904610001
    EVERITT, Mark Edward
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Amministratore
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    United KingdomBritish107529830027
    WELCH, Robert John
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Amministratore
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    United KingdomBritish212146700001
    MILLS, Nigel John
    Fairfield Lodge
    Fencer Hill Park Gosforth
    NE3 2EA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Segretario
    Fairfield Lodge
    Fencer Hill Park Gosforth
    NE3 2EA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British1537420008
    BARTON, Tracy Jayne
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Tesco House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Tesco House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish160642760001
    BLAIR, Steven
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    Amministratore
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritish239167430001
    BYTHEWAY, Neil Trevor
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Tesco House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Tesco House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish160637140001
    CLEMENTS, Tracey
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    Amministratore
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritish198102550001
    HODGSON, Michael Arthur
    6 Elm Grove
    Herrington Burn Houghton Le Spring
    DH4 4JH Sunderland
    Tyne & Wear
    Amministratore
    6 Elm Grove
    Herrington Burn Houghton Le Spring
    DH4 4JH Sunderland
    Tyne & Wear
    EnglandBritish122369540001
    KING, Andrew Paul
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    Amministratore
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    EnglandBritish200246970001
    LLOYD, Jonathan Mark
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Tesco House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Tesco House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish160028560001
    MCQUARRIE, Jonny
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    Amministratore
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritish239167420001
    MILLS, John Richardson
    24 Southlands
    Tynemouth
    NE30 2QS North Shields
    Tyne & Wear
    Amministratore
    24 Southlands
    Tynemouth
    NE30 2QS North Shields
    Tyne & Wear
    British13434000001
    MILLS, Nigel John
    Fairfield Lodge
    Fencer Hill Park Gosforth
    NE3 2EA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    Fairfield Lodge
    Fencer Hill Park Gosforth
    NE3 2EA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish1537420008
    MILLS, Susan
    Fairfield Lodge
    Fencer Hill Park
    NE3 2EA Gosforth
    Tyne & Wear
    Amministratore
    Fairfield Lodge
    Fencer Hill Park
    NE3 2EA Gosforth
    Tyne & Wear
    EnglandBritish86075290002
    NEVILLE-ROLFE, Lucy Jeanne, Ms.
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Tesco House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Tesco House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish148079740001
    PICKFORD, David
    5 Appleby Court
    Woodstone Village
    DH4 6TL Houghton Le Spring
    Tyne & Wear
    Amministratore
    5 Appleby Court
    Woodstone Village
    DH4 6TL Houghton Le Spring
    Tyne & Wear
    EnglandBritish94035720001
    PORRETT, John Joseph
    36 Broadmeadows Close
    Derwent Park
    NE16 3DD Swalwell
    Tyne & Wear
    Amministratore
    36 Broadmeadows Close
    Derwent Park
    NE16 3DD Swalwell
    Tyne & Wear
    EnglandBritish92512900001
    REED, Anthony William
    Brownhills
    WS8 7TS Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    Amministratore
    Brownhills
    WS8 7TS Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritish160544960001
    STOKOE, Martin Geoffrey
    1 Exelby Close
    Whitebridge Park
    NE3 5LG Gosforth
    Tyne & Wear
    Amministratore
    1 Exelby Close
    Whitebridge Park
    NE3 5LG Gosforth
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish49671990001
    WILLIAMS, Mark Benjamin
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    Amministratore
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritish208244710001
    TESCO SERVICES LIMITED
    Shire Park
    Kestrel Way
    AL7 1GA Welwyn Garden City
    Tesco House
    United Kingdom
    Amministratore
    Shire Park
    Kestrel Way
    AL7 1GA Welwyn Garden City
    Tesco House
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione7600956
    175259630001

    Chi sono le persone con controllo significativo di MILLS GROUP LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    31 mar 2017
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleUnited Kingdom (England)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione02462858
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione04569041
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    MILLS GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 25 giu 2010
    Consegnato il 02 lug 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H 7,9 and 11 earsdon road monkseaton t/no TY318937; fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 02 lug 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 30 apr 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Supplemental debenture
    Creato il 13 nov 2009
    Consegnato il 18 nov 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the goodwill and uncalled capital see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 18 nov 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 30 apr 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 30 gen 2008
    Consegnato il 07 feb 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 07 feb 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 apr 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creato il 15 mar 1996
    Consegnato il 25 mar 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    7/11 earsdon road whitley bay tyne and wear with the benefit of all rights licences and guarantees and the goodwill of the business. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 25 mar 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 apr 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 09 ott 1995
    Consegnato il 13 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    90 main road seaton workington cumbria. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 13 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 apr 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 07 ago 1995
    Consegnato il 08 ago 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property siyuate and k/a 88 and 89 main road seaton workington cumbria t/nos: CU88341 and CU52728. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 08 ago 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 apr 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 28 lug 1995
    Consegnato il 04 ago 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    15 sea road fulwell sunderland. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 04 ago 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 19 nov 1994
    Consegnato il 01 dic 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 115 sea road fulwell sunderland tyne and wear t/n DU13622 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 01 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ago 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge
    Creato il 18 gen 1991
    Consegnato il 23 gen 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge on goodwill together with the mortgagors right title and interest in the following assets trading names, plans drawings, design all licences, consents and permissions.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 23 gen 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 07 apr 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 ott 1986
    Consegnato il 07 ott 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 61/63 adelaide terr benwell newcastle upon tyne tyne & wear (title no nd 9423).
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 07 ott 1986Registrazione di un'ipoteca
    Fixed and floating charge
    Creato il 03 feb 1986
    Consegnato il 04 feb 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    First fixed charge on all book & other debts now & from time to time due owing floating charge on (see M16). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 04 feb 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 07 apr 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    MILLS GROUP LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    28 gen 2019Inizio della liquidazione
    25 ott 2019Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praticante
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praticante
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0