FERNTURN 6 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàFERNTURN 6 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01949033
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di FERNTURN 6 LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova FERNTURN 6 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o TLT LLP
    One
    Redcliff Street
    BS1 6TP Bristol
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di FERNTURN 6 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    D.V.R. (ELECTRICAL WHOLESALE) LIMITED27 lug 198927 lug 1989
    D.V.R. LIMITED20 set 198520 set 1985

    Quali sono gli ultimi bilanci di FERNTURN 6 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2012

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per FERNTURN 6 LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per FERNTURN 6 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 21 lug 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 ago 2013

    Stato del capitale al 17 ago 2013

    • Capitale: GBP 200
    SH01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2012

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 21 lug 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Ian John Webb il 08 mag 2012

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Kennet Way Canal Road Industrial Estate Trowbridge Wiltshire BA14 8BL* in data 24 mag 2012

    1 pagineAD01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    2 pagineAD02

    Bilancio annuale redatto al 07 feb 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed D.V.R. (electrical wholesale) LIMITED\certificate issued on 09/03/12
    2 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name09 mar 2012

    Risoluzione di cambio di nome della società il 24 feb 2012

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2011

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 07 feb 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2010

    5 pagineAA

    Cessazione della carica di David Purdon come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 07 feb 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2009

    12 pagineAA

    legacy

    1 pagine225

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288a

    Bilancio redatto al 02 gen 2008

    14 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di FERNTURN 6 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WEBB, Ian John
    Chiphouse Road
    BS15 4TR Bristol
    31
    South Glos
    Segretario
    Chiphouse Road
    BS15 4TR Bristol
    31
    South Glos
    BritishAccountant134286210001
    WEBB, Ian John
    c/o Tlt Llp
    Redcliff Street
    BS1 6TP Bristol
    One
    England
    Amministratore
    c/o Tlt Llp
    Redcliff Street
    BS1 6TP Bristol
    One
    England
    EnglandBritishAccountant134286210001
    LYNCH, Angela
    1 Crofts Lane
    Newton Longville
    MK17 0BT Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Segretario
    1 Crofts Lane
    Newton Longville
    MK17 0BT Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British84690450001
    VARNEY, Donald John
    83 Pinewood Drive
    Bletchley
    MK2 2HU Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Segretario
    83 Pinewood Drive
    Bletchley
    MK2 2HU Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British5508830001
    WHEATCROFT, Paul
    10 Kings Avenue
    SN14 0UJ Chippenham
    Wiltshire
    Segretario
    10 Kings Avenue
    SN14 0UJ Chippenham
    Wiltshire
    British76649570001
    BURT, Terence William
    274 Kimbolton Road
    MK41 8AD Bedford
    Amministratore
    274 Kimbolton Road
    MK41 8AD Bedford
    EnglandBritishCompany Director73890540002
    HARRON, Wayne Robert
    8 Lowick Place
    Emerson Valley
    MK4 2LP Milton Keynes
    Amministratore
    8 Lowick Place
    Emerson Valley
    MK4 2LP Milton Keynes
    BritishCompany Director84943310002
    JAMES, Clive Llewelyn
    14 Wentworth Drive
    MK41 8BB Bedford
    Bedfordshire
    Amministratore
    14 Wentworth Drive
    MK41 8BB Bedford
    Bedfordshire
    BritishCompany Director22550070002
    KINGSBURY, Mark David
    33 Bowden Hill
    Lacock
    SN15 2PP Chippenham
    Wiltshire
    Amministratore
    33 Bowden Hill
    Lacock
    SN15 2PP Chippenham
    Wiltshire
    BritishDirector23381640003
    PURDON, David John
    Beechfield
    Bathampton Lane, Bathampton
    BA2 6SJ Bath
    Avon
    Amministratore
    Beechfield
    Bathampton Lane, Bathampton
    BA2 6SJ Bath
    Avon
    EnglandBritishManaging Director1449120002
    RAWLINSON, Peter John
    Lion Villa 68 High Street
    GL1 4SR Gloucester
    Gloucestershire
    Amministratore
    Lion Villa 68 High Street
    GL1 4SR Gloucester
    Gloucestershire
    BritishCompany Director5508840001
    SLADE, Jamie Alexander
    27 Whiteley Crescent
    Bletchley
    MK3 5DQ Milton Keynes
    Amministratore
    27 Whiteley Crescent
    Bletchley
    MK3 5DQ Milton Keynes
    BritishCompany Director35445150002
    VARNEY, Stephen John
    Midsummer House Lower Way
    Great Brickhill
    MK17 9AG Milton Keynes
    Amministratore
    Midsummer House Lower Way
    Great Brickhill
    MK17 9AG Milton Keynes
    United KingdomBritishCompany Director5508850002
    VASS, Roy Leslie
    49 Whitehaven
    LU3 4BY Luton
    Bedfordshire
    Amministratore
    49 Whitehaven
    LU3 4BY Luton
    Bedfordshire
    BritishDirector64648050001

    FERNTURN 6 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    An omnibus guarantee and set off agreement
    Creato il 23 ott 2002
    Consegnato il 07 nov 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 07 nov 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 dic 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    All assets debenture
    Creato il 30 set 2002
    Consegnato il 10 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 10 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 dic 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed charge over book debts
    Creato il 20 mag 1993
    Consegnato il 26 mag 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a factoring agreement leasing agreement or otherwise on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All other book and other debts and claims both present and future due or owing to or purchased or otherwise acquired by the company and the full benefit of all rights and remedies relating thereto (see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Trade Indemnity-Heller Commercial Finace LTD
    Transazioni
    • 26 mag 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 09 giu 1988
    Consegnato il 13 giu 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 13 giu 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 07 nov 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0