CATLIN UNDERWRITING (UK) LIMITED

CATLIN UNDERWRITING (UK) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCATLIN UNDERWRITING (UK) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01949119
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CATLIN UNDERWRITING (UK) LIMITED?

    • Assicurazioni sulla vita (65110) / Attività finanziarie e assicurative
    • Assicurazioni diverse da quelle sulla vita (65120) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova CATLIN UNDERWRITING (UK) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CATLIN UNDERWRITING (UK) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    WELLINGTON UNDERWRITING HOLDINGS LIMITED20 set 198520 set 1985

    Quali sono gli ultimi bilanci di CATLIN UNDERWRITING (UK) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per CATLIN UNDERWRITING (UK) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    9 pagineLIQ13

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a 20 Gracechurch Street London EC3V 0BG

    2 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da 20 Gracechurch Street London EC3V 0BG a 30 Finsbury Square London EC2A 1AG in data 29 giu 2022

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    4 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 22 giu 2022

    LRESSP

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 feb 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2020

    13 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 feb 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2019

    12 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 feb 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Christopher John Read come amministratore in data 05 feb 2020

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Paul Richard Bradbrook come amministratore in data 05 feb 2020

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Craig Standen come amministratore in data 17 dic 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Juliet Phillips come amministratore in data 17 dic 2019

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2018

    13 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 feb 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    13 pagineAA

    Cessazione della carica di Paul Andrew Jardine come amministratore in data 26 set 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Miss Juliet Phillips come amministratore in data 26 set 2018

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Clynton Jacobus Luttig come amministratore in data 26 set 2018

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 feb 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    12 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 feb 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di CATLIN UNDERWRITING (UK) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    REES, Marie Louise
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    Segretario
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    201004350001
    LUTTIG, Clynton Jacobus
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    Amministratore
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    EnglandBritish218565170001
    READ, Christopher John
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    Amministratore
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    United KingdomBritish267508980001
    STANDEN, Craig
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    Amministratore
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    United KingdomBritish265497100001
    BUSHER, Thomas George Story
    Manor Farm Cottage School Hill
    Soberton
    SO32 3PF Southampton
    Hampshire
    Segretario
    Manor Farm Cottage School Hill
    Soberton
    SO32 3PF Southampton
    Hampshire
    British6386010002
    GLOVER, Michael Logan
    Dunelm
    41. St. Catherines Road
    EN10 7LD Broxbourne
    Herts
    Segretario
    Dunelm
    41. St. Catherines Road
    EN10 7LD Broxbourne
    Herts
    British94249710001
    GUYATT, Elizabeth Helen
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    Segretario
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    160260190001
    NOONE, Lisa Marie
    8 Paget Road
    IP1 3RP Ipswich
    Suffolk
    Segretario
    8 Paget Road
    IP1 3RP Ipswich
    Suffolk
    British72182310002
    PEARCE, Philip
    4 Rabbits Farm Cottages
    Rabbits Road, South Darenth
    DA4 9JZ Dartford
    Kent
    Segretario
    4 Rabbits Farm Cottages
    Rabbits Road, South Darenth
    DA4 9JZ Dartford
    Kent
    British70960040001
    CATLIN (WELLINGTON) INSURANCE LIMITED
    Floor 3 Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7DD London
    6th
    United Kingdom
    Segretario
    Floor 3 Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7DD London
    6th
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione01321649
    100566440004
    AGNEW, Ian Charles
    9 Albert Place
    W8 London
    Amministratore
    9 Albert Place
    W8 London
    British6418620002
    ALEXANDER, John Lindsay, Sir
    Corton Denham House
    Corton Denham
    DT9 4LR Sherborne
    Dorset
    Amministratore
    Corton Denham House
    Corton Denham
    DT9 4LR Sherborne
    Dorset
    British6418630001
    AVERY, Julian Ralph
    Little Boarzell
    Hurst Green
    TN19 7QU Etchingham
    East Sussex
    Amministratore
    Little Boarzell
    Hurst Green
    TN19 7QU Etchingham
    East Sussex
    United KingdomUk37578750001
    BRADBROOK, Paul Richard
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    Amministratore
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United KingdomBritish148983260001
    BURKE, Martin Thomas
    Albany, 26 Leafy Way
    Hutton
    CM13 2QW Brentwood
    Essex
    Amministratore
    Albany, 26 Leafy Way
    Hutton
    CM13 2QW Brentwood
    Essex
    United KingdomIrish240344510001
    BUSHER, Thomas George Story
    Manor Farm Cottage School Hill
    Soberton
    SO32 3PF Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    Manor Farm Cottage School Hill
    Soberton
    SO32 3PF Southampton
    Hampshire
    British6386010002
    CALLAN, Robert
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    Amministratore
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    United KingdomBritish130365420001
    COOPER, Anthony Geoffrey
    Shirrenden
    Brenchley Road
    TN12 8DN Horsmonden
    Kent
    Amministratore
    Shirrenden
    Brenchley Road
    TN12 8DN Horsmonden
    Kent
    British73654090001
    CUSACK, Julian Michael
    3 Eastern Close
    Rushmere St. Andrew
    IP4 5BY Ipswich
    Suffolk
    Amministratore
    3 Eastern Close
    Rushmere St. Andrew
    IP4 5BY Ipswich
    Suffolk
    British84410430001
    DUMAS, Henry Raymond
    Coldharbour Farm
    BS30 5RJ Wick
    South Gloucestershire
    Amministratore
    Coldharbour Farm
    BS30 5RJ Wick
    South Gloucestershire
    British73016630001
    FRESHWATER, Neil Andrew
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    Amministratore
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    EnglandBritish125646370001
    HAYNES, Joseph Antony
    40 Edwardes Square
    W8 6HH London
    Amministratore
    40 Edwardes Square
    W8 6HH London
    British9580170001
    IBESON, David Christopher Ben
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    Amministratore
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    United KingdomBritish52745170002
    JARDINE, Paul Andrew
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    Amministratore
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    EnglandBritish62337170003
    LETSINGER, Katherine Lee
    55 Northumberland Place
    W2 5AS London
    Amministratore
    55 Northumberland Place
    W2 5AS London
    United KingdomBritish54716770009
    MAYO, John William
    38 Marryat Road
    Wimbledon
    SW19 5BD London
    Amministratore
    38 Marryat Road
    Wimbledon
    SW19 5BD London
    British8271050001
    NORRIE, Guy Bainbridge, The Honourable
    Old Church Farm
    Broughton
    SO20 8AA Stockbridge
    Hampshire
    Amministratore
    Old Church Farm
    Broughton
    SO20 8AA Stockbridge
    Hampshire
    British6420160001
    O'BRIEN, Christopher Patrick James
    66 Constable Road
    IP4 2UZ Ipswich
    Suffolk
    Amministratore
    66 Constable Road
    IP4 2UZ Ipswich
    Suffolk
    British78831780002
    PEARCE, Philip
    4 Rabbits Farm Cottages
    Rabbits Road, South Darenth
    DA4 9JZ Dartford
    Kent
    Amministratore
    4 Rabbits Farm Cottages
    Rabbits Road, South Darenth
    DA4 9JZ Dartford
    Kent
    British70960040001
    PETZOLD, Martin William
    The Pound
    Alfold
    GU6 Cranleigh
    Surrey
    Amministratore
    The Pound
    Alfold
    GU6 Cranleigh
    Surrey
    British12148870001
    PHILLIPS, Juliet
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    Amministratore
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United KingdomBritish211555110001
    PREBENSEN, Preben
    Dulverton
    TA22 9JH Somerset
    Hollam House
    Amministratore
    Dulverton
    TA22 9JH Somerset
    Hollam House
    United KingdomBritish137567870001
    PRENTICE, John Oscar
    Gentilshurst
    Fernhurst
    GU27 Haslemere
    Surrey
    Amministratore
    Gentilshurst
    Fernhurst
    GU27 Haslemere
    Surrey
    British8271070001
    PRIMER, Daniel Francis
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    Amministratore
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    United KingdomAmerican112177980002
    SINFIELD, Nicholas Christopher
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    Amministratore
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    United KingdomBritish165481720002

    Chi sono le persone con controllo significativo di CATLIN UNDERWRITING (UK) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione5562639
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    CATLIN UNDERWRITING (UK) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 11 dic 2003
    Consegnato il 22 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Trustee for the Beneficiaries
    Transazioni
    • 22 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 24 ago 1998
    Consegnato il 27 ago 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other beneficiaries (as defined) under or pursuant to the finance documents (as defined)
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 27 ago 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 lug 2001Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 28 gen 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 16 lug 1997
    Consegnato il 29 lug 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 29 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 lug 2001Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 11 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 03 nov 1992
    Consegnato il 21 nov 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 21 nov 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 lug 2001Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 11 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 08 ago 1988
    Consegnato il 18 ago 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures & fittings fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 18 ago 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 08 lug 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 08 ago 1988
    Consegnato il 18 ago 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 18 ago 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 02 mar 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 30 dic 1985
    Consegnato il 13 gen 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (See doc M10 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 13 gen 1986Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 30 dic 1985
    Consegnato il 06 gen 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    Borrower's interest in the l/h properties etc and/or the proceeds of salethereof. Specific charge over all other securities etc the goodwill & uncalled capital etc floating charge undertaking and all property and assets present and future (see doc M9 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Baring Brothers & Co Limited
    Transazioni
    • 06 gen 1986Registrazione di un'ipoteca

    CATLIN UNDERWRITING (UK) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    22 giu 2022Inizio della liquidazione
    02 giu 2023Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Sean Kenneth Croston
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    Praticante
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0