NEW COVENT GARDEN SOUP COMPANY LIMITED(THE)

NEW COVENT GARDEN SOUP COMPANY LIMITED(THE)

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàNEW COVENT GARDEN SOUP COMPANY LIMITED(THE)
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01950388
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di NEW COVENT GARDEN SOUP COMPANY LIMITED(THE)?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova NEW COVENT GARDEN SOUP COMPANY LIMITED(THE)?

    Indirizzo della sede legale
    Templar House 4225 Park Approach
    Thorpe Park
    LS15 8GB Leeds
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di NEW COVENT GARDEN SOUP COMPANY LIMITED(THE)?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2022

    Quali sono le ultime deposizioni per NEW COVENT GARDEN SOUP COMPANY LIMITED(THE)?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2022

    12 pagineAA

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 dic 2022 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Nicholas Keen come segretario in data 14 set 2022

    1 pagineTM02

    Nomina di Mrs Farhaana Hussain Aslam come segretario in data 14 set 2022

    2 pagineAP03

    Stato del capitale al 03 ago 2022

    • Capitale: GBP 1
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Reduce shre prem a/c 02/08/2022
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Cessazione della carica di Javier H Idrovo come amministratore in data 04 feb 2022

    1 pagineTM01

    Nomina di Christopher James Bellairs come amministratore in data 04 feb 2022

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2021

    11 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 dic 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2020

    11 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da 2100 Century Way Thorpe Park Business Park Leeds West Yorkshire LS15 8ZB a Templar House 4225 Park Approach Thorpe Park Leeds LS15 8GB in data 04 mag 2021

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 dic 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Dr Wolfgang Goldenitsch come amministratore in data 24 ago 2020

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Robin James Skidmore come amministratore in data 24 ago 2020

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2019

    11 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 dic 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Javier H Idrovo come amministratore in data 02 dic 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di James Michael Langrock come amministratore in data 02 dic 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Denise Menikheim Faltischek come amministratore in data 30 giu 2019

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di NEW COVENT GARDEN SOUP COMPANY LIMITED(THE)?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ASLAM, Farhaana Hussain
    4225 Park Approach
    Thorpe Park
    LS15 8GB Leeds
    Templar House
    England
    Segretario
    4225 Park Approach
    Thorpe Park
    LS15 8GB Leeds
    Templar House
    England
    300834500001
    BELLAIRS, Christopher James
    4225 Park Approach
    Thorpe Park
    LS15 8GB Leeds
    Templar House
    England
    Amministratore
    4225 Park Approach
    Thorpe Park
    LS15 8GB Leeds
    Templar House
    England
    United StatesAmericanDirector292255820001
    GOLDENITSCH, Wolfgang, Dr
    4225 Park Approach
    Thorpe Park
    LS15 8GB Leeds
    Templar House
    England
    Amministratore
    4225 Park Approach
    Thorpe Park
    LS15 8GB Leeds
    Templar House
    England
    AustriaAustrianCeo273996560001
    SCHILLER, Mark Lawrence
    4225 Park Approach
    Thorpe Park
    LS15 8GB Leeds
    Templar House
    England
    Amministratore
    4225 Park Approach
    Thorpe Park
    LS15 8GB Leeds
    Templar House
    England
    United StatesAmericanCeo Hain Celestial253401770001
    AUSTIN, Graham
    Flat 8 60 Warwick Gardens
    W14 8PP London
    Segretario
    Flat 8 60 Warwick Gardens
    W14 8PP London
    British63589180001
    BEART, Nicholas Anthony
    Yearlstone House
    Bickliegh
    EX16 8RL Tiverton
    Devon
    Segretario
    Yearlstone House
    Bickliegh
    EX16 8RL Tiverton
    Devon
    BritishChartered Accountant69274920001
    CLARK, Peter Ian
    2 Grosvenor Avenue
    SW14 8BX London
    Segretario
    2 Grosvenor Avenue
    SW14 8BX London
    New Zealander64941070002
    HUDSON, Jeremy Stuart
    Unit 4 Acorn Business Park
    Killingbeck Drive York Road
    Leeds
    West Yorkshirels14 6uf
    Segretario
    Unit 4 Acorn Business Park
    Killingbeck Drive York Road
    Leeds
    West Yorkshirels14 6uf
    British90292510003
    KEEN, Nicholas
    Century Way
    Thorpe Park Business Park
    LS15 8ZA Leeds
    2100
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Segretario
    Century Way
    Thorpe Park Business Park
    LS15 8ZA Leeds
    2100
    West Yorkshire
    United Kingdom
    199266290001
    KENDALL, William Bruce
    Millow Hall
    SG18 8RH Biggleswade
    Bedfordshire
    Segretario
    Millow Hall
    SG18 8RH Biggleswade
    Bedfordshire
    British38245080001
    AUSTIN, Graham
    Flat 8 60 Warwick Gardens
    W14 8PP London
    Amministratore
    Flat 8 60 Warwick Gardens
    W14 8PP London
    BritishAccountant63589180001
    BEART, Nicholas Anthony
    Yearlstone House
    Bickliegh
    EX16 8RL Tiverton
    Devon
    Amministratore
    Yearlstone House
    Bickliegh
    EX16 8RL Tiverton
    Devon
    BritishChartered Accountant69274920001
    BELL, Simon
    52 Bonser Road
    TW1 4RG Twickenham
    Middlesex
    Amministratore
    52 Bonser Road
    TW1 4RG Twickenham
    Middlesex
    United KingdomBritishSales Director63589260001
    BELT, Andrew Robert
    15 Cleveland Square
    W2 6DG London
    Amministratore
    15 Cleveland Square
    W2 6DG London
    BritishManagement Consultant7397590001
    BLAKE, Samantha Elizabeth
    2 Hollow Heap Farm Cottage
    The Hollow Ramsey
    PE17 1YF Huntingdon
    Cambridgeshire
    Amministratore
    2 Hollow Heap Farm Cottage
    The Hollow Ramsey
    PE17 1YF Huntingdon
    Cambridgeshire
    AustralianFood Technologist61885110001
    BURNETT, Robert
    44 Woodlands Avenue
    Cults
    AB15 9DE Aberdeen
    Amministratore
    44 Woodlands Avenue
    Cults
    AB15 9DE Aberdeen
    ScotlandBritishCeo86190250002
    CAWLEY, Hugh Charles Laurence
    Red Roke 137 Epsom Road
    Merrow
    GU1 2PP Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Red Roke 137 Epsom Road
    Merrow
    GU1 2PP Guildford
    Surrey
    United KingdomBritishFinance Director41820960003
    CONTE, Pasquale
    Thorpe Park
    LS15 8ZB Leeds
    2100
    West Yorkshire
    Amministratore
    Thorpe Park
    LS15 8ZB Leeds
    2100
    West Yorkshire
    UsaUs CitizenCompany Director202392730001
    FALTISCHEK, Denise Menikheim
    Thorpe Park
    LS15 8ZB Leeds
    2100
    West Yorkshire
    Amministratore
    Thorpe Park
    LS15 8ZB Leeds
    2100
    West Yorkshire
    United StatesAmericanExecutive Vice President And General Counsel178917830001
    FREEDMAN, Cyril Winston
    Golden Mead
    Mead Road
    BR7 6AD Chislehurst
    Kent
    Amministratore
    Golden Mead
    Mead Road
    BR7 6AD Chislehurst
    Kent
    BritishCompany Director1631420001
    FREEDMAN, Cyril Winston
    Golden Mead
    Mead Road
    BR7 6AD Chislehurst
    Kent
    Amministratore
    Golden Mead
    Mead Road
    BR7 6AD Chislehurst
    Kent
    BritishVenture Capital1631420001
    HANCOCK, Geoffrey Charles
    The Grange
    LE17 6NE North Kilwortth
    Leicestershire
    Amministratore
    The Grange
    LE17 6NE North Kilwortth
    Leicestershire
    United KingdomBritishDirector28516220001
    HILL, John Anthony Crassweller
    48 Moreton Street
    SW1V 2PB London
    Amministratore
    48 Moreton Street
    SW1V 2PB London
    BritishSolicitor53615390001
    HOFFMANN, Andreas Serenus
    16 Thurloe Square
    SW7 2TE London
    Amministratore
    16 Thurloe Square
    SW7 2TE London
    SwitzerlandSwissCompany Director52410020001
    HUDSON, Jeremy Stuart
    Thorpe Park
    LS15 8ZB Leeds
    2100
    West Yorkshire
    Amministratore
    Thorpe Park
    LS15 8ZB Leeds
    2100
    West Yorkshire
    United KingdomBritishFinance Director90292510006
    IDROVO, Javier H
    4225 Park Approach
    Thorpe Park
    LS15 8GB Leeds
    Templar House
    England
    Amministratore
    4225 Park Approach
    Thorpe Park
    LS15 8GB Leeds
    Templar House
    England
    United StatesAmericanChief Financial Officer265407720001
    JENKS, Dennis Anthony
    Little Sarratt Hall
    Sarratt
    WD3 6BS Rickmansworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    Little Sarratt Hall
    Sarratt
    WD3 6BS Rickmansworth
    Hertfordshire
    BritishCompany Director221640001
    JEREMY, Caroline Monat
    12 Ridgmount Road
    SW18 2DA London
    Amministratore
    12 Ridgmount Road
    SW18 2DA London
    BritishMarketing Director34078750002
    KENDALL, William Bruce
    Millow Hall
    SG18 8RH Biggleswade
    Bedfordshire
    Amministratore
    Millow Hall
    SG18 8RH Biggleswade
    Bedfordshire
    BritishLawyer Farmer Director38245080001
    LANGROCK, James Michael
    Thorpe Park Business Park
    LS15 8ZB Leeds
    2100 Century Way
    West Yorkshire
    Amministratore
    Thorpe Park Business Park
    LS15 8ZB Leeds
    2100 Century Way
    West Yorkshire
    United StatesAmericanCfo235110160001
    MILLS, Michael John
    Maple Heath
    Parsonage Lane Farnham Common
    SL2 3NZ Slough
    Berkshire
    Amministratore
    Maple Heath
    Parsonage Lane Farnham Common
    SL2 3NZ Slough
    Berkshire
    United KingdomBritishCompany Director34628600001
    PALMER, Rowland Andrew
    34 Delorme Street
    W6 8DT London
    Amministratore
    34 Delorme Street
    W6 8DT London
    BritishCompany Director56956750001
    RAISON, Katherine Barbara Gabriel
    66 Riverview Gardens
    London
    Amministratore
    66 Riverview Gardens
    London
    BritishDirector57498640001
    RISDON, Shaun William
    Red Lodge
    Jule Lane
    Alderleigh
    Suffolk
    Amministratore
    Red Lodge
    Jule Lane
    Alderleigh
    Suffolk
    BritishSales Director68224320001
    SIMON, Irwin David
    Thorpe Park
    LS15 8ZB Leeds
    2100
    West Yorkshire
    Amministratore
    Thorpe Park
    LS15 8ZB Leeds
    2100
    West Yorkshire
    United StatesAmericanCeo170074710001

    Chi sono le persone con controllo significativo di NEW COVENT GARDEN SOUP COMPANY LIMITED(THE)?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Daniels Chilled Foods Limited
    Century Way, Thorpe Park
    LS15 8ZB Leeds
    2100
    England
    06 apr 2016
    Century Way, Thorpe Park
    LS15 8ZB Leeds
    2100
    England
    No
    Forma giuridicaCompany Limited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland And Wales Companies Registry
    Numero di registrazione03102559
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    NEW COVENT GARDEN SOUP COMPANY LIMITED(THE) ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee & debenture
    Creato il 06 mar 1998
    Consegnato il 19 mar 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 mar 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 ott 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge over credit balances
    Creato il 30 nov 1993
    Consegnato il 14 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge over all the deposit(s) being all sums of money in any currency (a) deposited or paid by the company with or to the bank or held by the bank on behalf of the company pursuant to the deposit contract(s) re: new covent garden soup company limited gts bid deposit client no. 5751630 and (b) representing the renewal or replacement of or for any sums deposited or paid or held as aforesaid, together with all interest accruing thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 ott 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 23 nov 1990
    Consegnato il 13 dic 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The companys obligation to repay to the charge the principal amount of a securedloan constituted by an instrument of even date under the te rms of the loan this debenture or any othe security
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Alan Patric of Associates Limited
    Transazioni
    • 13 dic 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 04 dic 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge
    Creato il 16 mag 1990
    Consegnato il 19 mag 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £60,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. Under the terms of the charge
    Brevi particolari
    F/H property k/a 35 hythe road l/b of hammersmith & fulham t/n ngl 589186.
    Persone aventi diritto
    • The Mayor and Burgesses of the London Borough of Hammersmith and Fulham.
    Transazioni
    • 19 mag 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 04 dic 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 30 mar 1990
    Consegnato il 12 apr 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £100,000 due from the company to the chargee under the terms of the loan notes and this debenture
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Alan Patrick Associates Limited
    Transazioni
    • 12 apr 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 04 dic 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 03 gen 1990
    Consegnato il 11 gen 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Gustimix precessing equipment:- ( see doc for full details ).
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 gen 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 04 dic 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 14 giu 1989
    Consegnato il 21 giu 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    35 hythe road, lb of hammersmith and fulham t/no. Ngl 589186.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 giu 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 16 ott 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 09 feb 1988
    Consegnato il 19 feb 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 feb 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 16 ott 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0