NEW COVENT GARDEN SOUP COMPANY LIMITED(THE)
Panoramica
Nome della società | NEW COVENT GARDEN SOUP COMPANY LIMITED(THE) |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01950388 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di NEW COVENT GARDEN SOUP COMPANY LIMITED(THE)?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova NEW COVENT GARDEN SOUP COMPANY LIMITED(THE)?
Indirizzo della sede legale | Templar House 4225 Park Approach Thorpe Park LS15 8GB Leeds England |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di NEW COVENT GARDEN SOUP COMPANY LIMITED(THE)?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 30 giu 2022 |
Quali sono le ultime deposizioni per NEW COVENT GARDEN SOUP COMPANY LIMITED(THE)?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2022 | 12 pagine | AA | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 dic 2022 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Nicholas Keen come segretario in data 14 set 2022 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Nomina di Mrs Farhaana Hussain Aslam come segretario in data 14 set 2022 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 03 ago 2022
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cessazione della carica di Javier H Idrovo come amministratore in data 04 feb 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Christopher James Bellairs come amministratore in data 04 feb 2022 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2021 | 11 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 dic 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2020 | 11 pagine | AA | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 2100 Century Way Thorpe Park Business Park Leeds West Yorkshire LS15 8ZB a Templar House 4225 Park Approach Thorpe Park Leeds LS15 8GB in data 04 mag 2021 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 dic 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Nomina di Dr Wolfgang Goldenitsch come amministratore in data 24 ago 2020 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Robin James Skidmore come amministratore in data 24 ago 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2019 | 11 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 dic 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Javier H Idrovo come amministratore in data 02 dic 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di James Michael Langrock come amministratore in data 02 dic 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Denise Menikheim Faltischek come amministratore in data 30 giu 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di NEW COVENT GARDEN SOUP COMPANY LIMITED(THE)?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASLAM, Farhaana Hussain | Segretario | 4225 Park Approach Thorpe Park LS15 8GB Leeds Templar House England | 300834500001 | |||||||
BELLAIRS, Christopher James | Amministratore | 4225 Park Approach Thorpe Park LS15 8GB Leeds Templar House England | United States | American | Director | 292255820001 | ||||
GOLDENITSCH, Wolfgang, Dr | Amministratore | 4225 Park Approach Thorpe Park LS15 8GB Leeds Templar House England | Austria | Austrian | Ceo | 273996560001 | ||||
SCHILLER, Mark Lawrence | Amministratore | 4225 Park Approach Thorpe Park LS15 8GB Leeds Templar House England | United States | American | Ceo Hain Celestial | 253401770001 | ||||
AUSTIN, Graham | Segretario | Flat 8 60 Warwick Gardens W14 8PP London | British | 63589180001 | ||||||
BEART, Nicholas Anthony | Segretario | Yearlstone House Bickliegh EX16 8RL Tiverton Devon | British | Chartered Accountant | 69274920001 | |||||
CLARK, Peter Ian | Segretario | 2 Grosvenor Avenue SW14 8BX London | New Zealander | 64941070002 | ||||||
HUDSON, Jeremy Stuart | Segretario | Unit 4 Acorn Business Park Killingbeck Drive York Road Leeds West Yorkshirels14 6uf | British | 90292510003 | ||||||
KEEN, Nicholas | Segretario | Century Way Thorpe Park Business Park LS15 8ZA Leeds 2100 West Yorkshire United Kingdom | 199266290001 | |||||||
KENDALL, William Bruce | Segretario | Millow Hall SG18 8RH Biggleswade Bedfordshire | British | 38245080001 | ||||||
AUSTIN, Graham | Amministratore | Flat 8 60 Warwick Gardens W14 8PP London | British | Accountant | 63589180001 | |||||
BEART, Nicholas Anthony | Amministratore | Yearlstone House Bickliegh EX16 8RL Tiverton Devon | British | Chartered Accountant | 69274920001 | |||||
BELL, Simon | Amministratore | 52 Bonser Road TW1 4RG Twickenham Middlesex | United Kingdom | British | Sales Director | 63589260001 | ||||
BELT, Andrew Robert | Amministratore | 15 Cleveland Square W2 6DG London | British | Management Consultant | 7397590001 | |||||
BLAKE, Samantha Elizabeth | Amministratore | 2 Hollow Heap Farm Cottage The Hollow Ramsey PE17 1YF Huntingdon Cambridgeshire | Australian | Food Technologist | 61885110001 | |||||
BURNETT, Robert | Amministratore | 44 Woodlands Avenue Cults AB15 9DE Aberdeen | Scotland | British | Ceo | 86190250002 | ||||
CAWLEY, Hugh Charles Laurence | Amministratore | Red Roke 137 Epsom Road Merrow GU1 2PP Guildford Surrey | United Kingdom | British | Finance Director | 41820960003 | ||||
CONTE, Pasquale | Amministratore | Thorpe Park LS15 8ZB Leeds 2100 West Yorkshire | Usa | Us Citizen | Company Director | 202392730001 | ||||
FALTISCHEK, Denise Menikheim | Amministratore | Thorpe Park LS15 8ZB Leeds 2100 West Yorkshire | United States | American | Executive Vice President And General Counsel | 178917830001 | ||||
FREEDMAN, Cyril Winston | Amministratore | Golden Mead Mead Road BR7 6AD Chislehurst Kent | British | Company Director | 1631420001 | |||||
FREEDMAN, Cyril Winston | Amministratore | Golden Mead Mead Road BR7 6AD Chislehurst Kent | British | Venture Capital | 1631420001 | |||||
HANCOCK, Geoffrey Charles | Amministratore | The Grange LE17 6NE North Kilwortth Leicestershire | United Kingdom | British | Director | 28516220001 | ||||
HILL, John Anthony Crassweller | Amministratore | 48 Moreton Street SW1V 2PB London | British | Solicitor | 53615390001 | |||||
HOFFMANN, Andreas Serenus | Amministratore | 16 Thurloe Square SW7 2TE London | Switzerland | Swiss | Company Director | 52410020001 | ||||
HUDSON, Jeremy Stuart | Amministratore | Thorpe Park LS15 8ZB Leeds 2100 West Yorkshire | United Kingdom | British | Finance Director | 90292510006 | ||||
IDROVO, Javier H | Amministratore | 4225 Park Approach Thorpe Park LS15 8GB Leeds Templar House England | United States | American | Chief Financial Officer | 265407720001 | ||||
JENKS, Dennis Anthony | Amministratore | Little Sarratt Hall Sarratt WD3 6BS Rickmansworth Hertfordshire | British | Company Director | 221640001 | |||||
JEREMY, Caroline Monat | Amministratore | 12 Ridgmount Road SW18 2DA London | British | Marketing Director | 34078750002 | |||||
KENDALL, William Bruce | Amministratore | Millow Hall SG18 8RH Biggleswade Bedfordshire | British | Lawyer Farmer Director | 38245080001 | |||||
LANGROCK, James Michael | Amministratore | Thorpe Park Business Park LS15 8ZB Leeds 2100 Century Way West Yorkshire | United States | American | Cfo | 235110160001 | ||||
MILLS, Michael John | Amministratore | Maple Heath Parsonage Lane Farnham Common SL2 3NZ Slough Berkshire | United Kingdom | British | Company Director | 34628600001 | ||||
PALMER, Rowland Andrew | Amministratore | 34 Delorme Street W6 8DT London | British | Company Director | 56956750001 | |||||
RAISON, Katherine Barbara Gabriel | Amministratore | 66 Riverview Gardens London | British | Director | 57498640001 | |||||
RISDON, Shaun William | Amministratore | Red Lodge Jule Lane Alderleigh Suffolk | British | Sales Director | 68224320001 | |||||
SIMON, Irwin David | Amministratore | Thorpe Park LS15 8ZB Leeds 2100 West Yorkshire | United States | American | Ceo | 170074710001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di NEW COVENT GARDEN SOUP COMPANY LIMITED(THE)?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniels Chilled Foods Limited | 06 apr 2016 | Century Way, Thorpe Park LS15 8ZB Leeds 2100 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
NEW COVENT GARDEN SOUP COMPANY LIMITED(THE) ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Guarantee & debenture | Creato il 06 mar 1998 Consegnato il 19 mar 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge over credit balances | Creato il 30 nov 1993 Consegnato il 14 dic 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed charge over all the deposit(s) being all sums of money in any currency (a) deposited or paid by the company with or to the bank or held by the bank on behalf of the company pursuant to the deposit contract(s) re: new covent garden soup company limited gts bid deposit client no. 5751630 and (b) representing the renewal or replacement of or for any sums deposited or paid or held as aforesaid, together with all interest accruing thereon. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 23 nov 1990 Consegnato il 13 dic 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The companys obligation to repay to the charge the principal amount of a securedloan constituted by an instrument of even date under the te rms of the loan this debenture or any othe security | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of charge | Creato il 16 mag 1990 Consegnato il 19 mag 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £60,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. Under the terms of the charge | |
Brevi particolari F/H property k/a 35 hythe road l/b of hammersmith & fulham t/n ngl 589186. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 30 mar 1990 Consegnato il 12 apr 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £100,000 due from the company to the chargee under the terms of the loan notes and this debenture | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Chattel mortgage | Creato il 03 gen 1990 Consegnato il 11 gen 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Gustimix precessing equipment:- ( see doc for full details ). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 14 giu 1989 Consegnato il 21 giu 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 35 hythe road, lb of hammersmith and fulham t/no. Ngl 589186. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 09 feb 1988 Consegnato il 19 feb 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0